Actos BORME de Ice Cream Factory Co Maker Sa
28 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 11095, L 8373, F 206, S 8, H V92109, I/A 48 (21.11.23).
10 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: HUGUET CASTELLO VICENTE JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPARCOMASSIMO;ROCCHICCIOLI OMAR;LOMBARDELLI STEFANO;USINA GORBA JOAQUIN;LLORET CARRERA ENRIQUE. Datosregistrales. T 11095, L 8373, F 203, S 8, H V 92109, I/A 47 ( 3.10.23).
24 de Mayo de 2023Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: FERRERO INTERNATIONAL SA. Fusión por absorción.Sociedades absorbidas: ICE CREAM FACTORY COMAKER INTERNATIONAL SL. PUMALVERDE SL. HIGHESTIME XXI SL. Datosregistrales. T 11095, L 8373, F 202, S 8, H V 92109, I/A 46 (17.05.23).
26 de Abril de 2023Reelecciones. Consejero: MARTINEZ CARRETERO DANIEL. Presidente: MARTINEZ CARRETERO DANIEL. Consejero: CALABROLEONARDO;SANTOUL JEAN BAPTISTE;SOLDI MARCO. Datos registrales. T 11095, L 8373, F 202, S 8, H V 92109, I/A 45(19.04.23).
16 de Febrero de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: GRAU MANSANET ROGELIA;SAEZ GALDON JESUS. Nombramientos. Apoderado: ANDRESSANCHEZ CRISTINA. Datos registrales. T 11095, L 8373, F 201, S 8, H V 92109, I/A 43 ( 9.02.23).
Ceses/Dimisiones. Consejero: DEGREGORI MARCO. Nombramientos. Consejero: NERVEGNA ALESSANDRO. Datosregistrales. T 11095, L 8373, F 202, S 8, H V 92109, I/A 44 ( 9.02.23).
18 de Abril de 2022Reelecciones. Consejero: MARTINEZ CARRETERO DANIEL. Presidente: MARTINEZ CARRETERO DANIEL. Consejero:DEGREGORI MARCO. Datos registrales. T 11095, L 8373, F 201, S 8, H V 92109, I/A 42 ( 7.04.22).
09 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: BAUBRY PATRICK ANDRE. Nombramientos. Consejero: SANTOUL JEAN BAPTISTE. Datosregistrales. T 9331, L 6613, F 50, S 8, H V 92109, I/A 39 ( 2.02.22).
Ceses/Dimisiones. Consejero: LAMSFUS BRAVO GUILLERMO. Nombramientos. Consejero: SOLDI MARCO. Datos registrales.T 11095, L 8373, F 201, S 8, H V 92109, I/A 40 ( 2.02.22).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LAMSFUS BRAVO GUILLERMO;GIL JUAN RICARDO. Nombramientos. Apoderado: SOLDIMARCO;GUINART PALENZUELA PERE. Datos registrales. T 11095, L 8373, F 201, S 8, H V 92109, I/A 41 ( 2.02.22).
30 de Julio de 2021Nombramientos. Consejero: CALABRO LEONARDO. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 50, S 8, H V 92109, I/A 38 (20.07.21).
08 de Abril de 2021Reelecciones. Consejero: MARTINEZ CARRETERO DANIEL;BAUBRY PATRICK ANDRE;DEGREGORI MARCO;LAMSFUS BRAVOGUILLERMO. Presidente: MARTINEZ CARRETERO DANIEL. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 50, S 8, H V 92109, I/A 37(30.03.21).
07 de Abril de 2021Revocaciones. Apoderado: LAMSFUS LOPEZ GUILLERMO;GIL JUAN RICARDO;GRAU MANSANET ROGELIA. Apo.Man.Soli:GRAU MANSANET ROGELIA. Apoderado: GRAU MANSANET ROGELIA;SOSPEDRA ZAMORA AGUSTIN SALVADOR;MARZOMOMPO MARIA LUISA;PICAZO SOLSONA JUAN JOSE;LAMSFUS BRAVO GUILLERMO. Apo.Man.Soli: FONT MARTIN JOSEVICENTE;SAEZ GALDON JESUS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: LAMSFUS BRAVO GUILLERMO;GIL JUAN RICARDO;PICAZOSOLSONA JUAN JOSE;THIERRY KUENTZ THIBAUT ANNE;ALVAREZ CASTRO CARLA;CAMARASA OLIVAS MARIA;FONTMARTIN JOSE VICENTE;JOS OLVOORT HENRI;DELGADO HUESO CARLOS ARTURO;GRAU MANSANET ROGELIA;VIDALJORDAN MARTA;SAEZ GALDON JESUS;HUGUET CASTELLO VICENTE JAVIER;CERDA CASTILLO KARINA. Datos registrales. T9331, L 6613, F 47, S 8, H V 92109, I/A 36 (29.03.21).
27 de Julio de 2020Nombramientos. Apoderado: GRAU MANSANET ROGELIA. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 46, S 8, H V 92109, I/A 34(21.07.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: ADLAOUI GUIDO SAMIR;CASAS VILASECA SANTIAGO. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 46, S 8,H V 92109, I/A 35 (21.07.20).
06 de Julio de 2020Reelecciones. Consejero: MARTINEZ CARRETERO DANIEL;BAUBRY PATRICK ANDRE;DEGREGORI MARCO;LAMSFUS BRAVOGUILLERMO. Presidente: MARTINEZ CARRETERO DANIEL. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 46, S 8, H V 92109, I/A 32(29.06.20).
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 46, S 8, H V92109, I/A 33 (29.06.20).
02 de Septiembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: LAMSFUS LOPEZ GUILLERMO;PORTOBELLO ALFA SL;PORTOBELLO BETA SL;PORTOBELLOGAMMA SL. SecreNoConsj: CERDEIRAS CHECA RAMON. Presidente: LAMSFUS LOPEZ GUILLERMO. Nombramientos.Consejero: MARTINEZ CARRETERO DANIEL;BAUBRY PATRICK ANDRE;DEGREGORI MARCO;LAMSFUS BRAVO GUILLERMO.Presidente: MARTINEZ CARRETERO DANIEL. SecreNoConsj: TRIAS DE BES MAQUEDA ALBERT. Modificaciones estatutarias.ARTICULO 11.- RETRIBUCION ORGANO DE ADMINISTRACION. Otros conceptos: La duración del cargo de Administrador serápor UN AÑO. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 45, S 8, H V 92109, I/A 31 (26.08.19).
23 de Julio de 2019Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/8. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 44, S 8, H V 92109, I/A 29(16.07.19).
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 45, S 8, H V 92109, I/A 30 (16.07.19).
30 de Noviembre de 2018Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 44, S 8, H V 92109, I/A 28 (23.11.18).
27 de Septiembre de 2018Nombramientos. Apoderado: GRAU MANSANET ROGELIA. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 44, S 8, H V 92109, I/A 27(20.09.18).
22 de Noviembre de 2017Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 44, S 8, H V 92109, I/A 26 (15.11.17).
15 de Febrero de 2017Otros conceptos: La mercantil PORTOBELLO BETA, S.L., consejero de la sociedad de esta hoja ha cambiado su persona físicarepresentante, designando a DON RAMON CERDEIRAS CHECA, NIF. 05234503-W. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 43, S 8, HV 92109, I/A 24 M ( 8.02.17).
18 de Noviembre de 2016Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 43, S 8, H V 92109, I/A 25 (11.11.16).
08 de Agosto de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: HIGHESTIME XXI SL. Nombramientos. Consejero: PORTOBELLO ALFA SL;PORTOBELLO BETASL;PORTOBELLO GAMMA SL;LAMSFUS LOPEZ GUILLERMO. SecreNoConsj: CERDEIRAS CHECA RAMON. Modificacionesestatutarias. ARTICULO 5º. DE LA JUNTA.-. ARTICULO 10. DEL CONSEJO.. ARTICULO 11.- DE LA RETRIBUCION.-. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. ARTICULO 9.- DEL CONSEJO.-DON JUAN-LUIS RAMIREZ BELAUSTEGUI, con DNI 50.814.020-M, ha sido designado persona física representante de la entidad"PORTOBELLO ALFA SL", con CIF B-86.144.383, administradora única de "ICE CREAM FACTORY CO MAKER SA". DON JORGEMORRAL HOSPITAL, con DNI 37.323.102-J, ha sido designado persona física representante de la entidad "PORTOBELLO BETA SL",con CIF B-86.144.391, administradora única de "ICE CREAM FACTORY CO MAKER SA". DON LUIS PEÑARROCHA TERES, conDNI 50.182.411-E, ha sido designado persona física representante de la entidad "PORTOBELLO GAMMA SL", con CIF B-86.144.409,administradora única de "ICE CREAM FACTORY CO MAKER SA". Datos registrales. T 9331, L 6613, F 43, S 8, H V 92109, I/A 24(29.07.16).
22 de Marzo de 2016Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: HIGHESTIME XXI SL. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 42, S 8,H V 92109, I/A 24 (15.03.16).
17 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: GRAU MANSANET ROGELIA. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 42, S 8, H V 92109, I/A 23 (9.12.15).
21 de Octubre de 2015Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 42, S 8, H V 92109, I/A 22 (13.10.15).
24 de Agosto de 2015Ampliacion del objeto social. c. El arrendamiento, excluyendo el financiero o leasing, de terrenos y locales para uso privado o condestino empresarial. CNAE 1052 Elaboracion de helados. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 41, S 8, H V 92109, I/A 21 (17.08.15).
17 de Junio de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAEZ GALDON JESUS. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 41, S 8, H V 92109, I/A 20 (10.06.15).
23 de Marzo de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: FONT MARTIN JOSE VICENTE. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 40, S 8, H V 92109, I/A 19(13.03.15).
18 de Agosto de 2014Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 40, S 8, H V 92109, I/A 18 ( 8.08.14).
25 de Julio de 2013Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 40, S 8, H V 92109, I/A 17 (18.07.13).
15 de Junio de 2011Nombramientos. Apoderado: LAMSFUS BRAVO GUILLERMO. Datos registrales. T 7585, L 4885, F 224, S 8, H V 92109, I/A 16 (6.06.11).
16 de Marzo de 2011Nombramientos. Apoderado: PICAZO SOLSONA JUAN JOSE. Datos registrales. T 7585, L 4885, F 223, S 8, H V 92109, I/A 15 (7.03.11).
15 de Marzo de 2011Revocaciones. Apoderado: DEL REY DIAZ MAYORDOMO JUAN MANUEL. Datos registrales. T 7585, L 4885, F 223, S 8, H V92109, I/A 14 ( 4.03.11).
16 de Diciembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: LAMSFUS LOPEZ GUILLERMO;GIL JUAN RICARDO;DEL REY DIAZ MAYORDOMO JUANMANUEL. Presidente: LAMSFUS LOPEZ GUILLERMO. Secretario: DEL REY DIAZ MAYORDOMO JUAN MANUEL. Nombramientos.Adm. Unico: HIGHESTIME XXI SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Consejo de administracióna Administrador único.ARTICULO 10. MODIFICADO.ARTICULO 5º. MODIFICADO.ARTICULO 9º.- SIN CONTENIDO.ARTICULO 11.-MODIFICADO. Datos registrales. T 7585, L 4885, F 222, S 8, H V 92109, I/A 13 ( 3.12.10).
02 de Junio de 2010Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 7585, L 4885, F 222, S 8, H V 92109, I/A 12 (24.05.10).
28 de Mayo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: LAMSFUS LOPEZ GUILLERMO;GIL JUAN RICARDO;DEL REY DIAZ MAYORDOMO JUANMANUEL. Presidente: LAMSFUS LOPEZ GUILLERMO. Secretario: DEL REY DIAZ MAYORDOMO JUAN MANUEL. Nombramientos.Consejero: LAMSFUS LOPEZ GUILLERMO;GIL JUAN RICARDO;DEL REY DIAZ MAYORDOMO JUAN MANUEL. Presidente: