Buscador CIF Logo

Actos BORME Idea Informatica Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Idea Informatica Sa

Actos BORME Idea Informatica Sa - A79475448

Tenemos registrados 17 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Idea Informatica Sa con CIF A79475448

馃敊 Perfil de Idea Informatica Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Idea Informatica Sa

17 de Octubre de 2014
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 30298 , F 57, S 8, H M 8443, I/A 31 ( 9.10.14).

09 de Octubre de 2014
Ceses/Dimisiones. Secretario: MELENDEZ SUAREZ DE LEZO JOSE RAMON. Nombramientos. SecreNoConsj: MAFUZ GUMIELROSA MARIA. Datos registrales. T 30298 , F 57, S 8, H M 8443, I/A 30 (30.09.14).

24 de Diciembre de 2013
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GIL TEJEDOR Y ASOCIADOS SLP. Consejero: DE ANDRADE GONCALVES JOSECARLOS;SPREAFICO OLIVIER D.J. Presidente: SPREAFICO OLIVIER D.J. Consejero: PONSOBY BRYAN JOHN. Representan:GONZALEZ IRUN RODRIGUEZ MIGUEL. Nombramientos. Secretario: MELENDEZ SUAREZ DE LEZO JOSE RAMON. Consejero:BAPTISTA JOAO. Presidente: BAPTISTA JOAO. Consejero: GILL CHARLES. Datos registrales. T 30298 , F 57, S 8, H M 8443, I/A29 (17.12.13).

16 de Noviembre de 2012
Revocaciones. Apoderado: DUBRANA SERGE ALAIN;MACKAY THOMAS OWEN;DE ANDRADE GONCALVES JOSE CARLOS.Nombramientos. Apo.Sol.: SPREAFICO OLIVIER D.J.;PONSOBY BRYAN JOHN;DE ANDRADE GONCALVES JOSECARLOS;ANDERSON ROBERT DAVID. Datos registrales. T 30298 , F 53, S 8, H M 8443, I/A 28 ( 5.11.12).

02 de Noviembre de 2012
Revocaciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Consejero: ANDERSON ROBERTDAVID. Auditor: ERNST & YOUNG SL;ERNST & YOUNG SL. Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/9.Datos registrales. T 30298 , F 52, S 8, H M 8443, I/A 27 (23.10.12).

24 de Octubre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: DUBRANA SERGE ALAIN;MACKAY THOMAS OWEN. Presidente: MACKAY THOMAS OWEN.Nombramientos. Consejero: SPREAFICO OLIVIER D.J. Presidente: SPREAFICO OLIVIER D.J. Consejero: PONSOBY BRYANJOHN. Datos registrales. T 13344 , F 199, S 8, H M 8443, I/A 25 (11.10.12).

Nombramientos. Apoderado: ROACH MICHAEL EDWARD;CASTRO ALVAREZ MIGUEL;RODRIGUES VILACA BARREIROS DOSSANTOS MARIA DA CON;GALAN VEGA JUAN;MONTON MILLAN MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 30298 , F 51, S 8, H M8443, I/A 26 (11.10.12).

30 de Enero de 2012
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre deEjercicio: 31/12. Datos registrales. T 13344 , F 199, S 8, H M 8443, I/A 24 (18.01.12).

09 de Diciembre de 2011
Revocaciones. Apoderado: CEA SORIANO JOSE MARIA;ZAMORANO VALI脩A ENRIQUE. Nombramientos. Apo.Manc.:MIRALLES MANRESA CARLOS. Datos registrales. T 13344 , F 198, S 8, H M 8443, I/A 23 (25.11.11).

05 de Diciembre de 2011
Revocaciones. Apoderado: MACKAY THOMAS OWEN;DE ANDRADE GONCALVES JOSE CARLOS;DUBRANA SERGE ALAIN.

28 de Septiembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Secretario: GIL DE LA PARRA ENRIQUE. Nombramientos. SecreNoConsj: GIL TEJEDOR Y ASOCIADOSSLP. Representan: GONZALEZ IRUN RODRIGUEZ MIGUEL. Datos registrales. T 13344 , F 194, S 8, H M 8443, I/A 21 (16.09.11).

23 de Agosto de 2011
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 13344 , F 194, S 8, H M 8443, I/A 20 (11.08.11).

10 de Junio de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE RIVA ZORRILLA JOSE MANUEL. Presidente: DE RIVA ZORRILLA JOSE MANUEL. Consejero:DEL REY TAPIA JAIME. Vicepresid.: DEL REY TAPIA JAIME. Consejero: TEJEDOR REDONDO LUIS. Con.Delegado: DE RIVAZORRILLA JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero: DUBRANA SERGE ALAIN;MACKAY THOMAS OWEN. Presidente:MACKAY THOMAS OWEN. Consejero: DE ANDRADE GONCALVES JOSE CARLOS. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de losestatutos: Modificaci贸n del ejercicio social.. Datos registrales. T 13344 , F 189, S 8, H M 8443, I/A 18 (31.05.11).

Revocaciones. Apoderado: RAMOS PEREZ FAUSTINO;FLORES ROMERO EMILIO;DE RIVA ZORRILLA JOSEMANUEL;HERNANDEZ ALONSO FERNANDO. Apo.Manc.: RUESGAS SANTOS MARIA BEGO脩A;DE RIVA ZORRILLAJAVIER;HERRERA GONZALEZ EMILIO;FIGUEREDO ZALVE ANGEL. Apoderado: CEA SORIANO JOSE MARIA;VELASCO DEFRUTOS CRISTINA;DE LA PE脩A GONZALEZ MONICA;DEL REY TAPIA JAIME;HERRERA GONZALEZ EMILIO;DEL REY TAPIAJAIME;HERRERA GONZALEZ EMILIO;CEA SORIANO JOSE MARIA;MORENO RICO JOSE MIGUEL;CASTRO ALVAREZ MIGUELANGEL;HACES HACES DOLORES;SANTOS GONZALEZ SALVADOR;DEL VALLE BALLESTEROS SALVADOR. Nombramientos.Apoderado: MACKAY THOMAS OWEN;DE ANDRADE GONCALVES JOSE CARLOS;DE RIVA ZORRILLA JOSE MANUEL;DEL REYTAPIA JAIME;CASTRO ALVAREZ MIGUEL ANGEL;CEA SORIANO JOSE MARIA;RODRIGUES VILACA BARREIROS DOS SANTOSMARIA DA CON;MOREIRA DA CUNHA MANUEL-LUIS;VELASCO DE FRUTOS CRISTINA;DE LA PE脩A GONZALEZMONICA;DUBRANA SERGE ALAIN;HACES HACES DOLORES;SANCHEZ GARCIA JERONIMO;OSET FERNANDEZJOAQUIN;GALAN VEGA JUAN JOSE;ZAMORANO VALI脩A ENRIQUE;SANTOS GONZALEZ SALVADOR. Datos registrales. T13344 , F 190, S 8, H M 8443, I/A 19 (31.05.11).

23 de Mayo de 2011
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 13344 , F 189, S 8, H M 8443, I/A 17 (12.05.11).

10 de Noviembre de 2010
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 13344 , F 189, S 8, H M 8443, I/A 16 (28.10.10).

20 de Febrero de 2009
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 13344 , F 188, S 8, H M 8443, I/A 15 (10.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n