Buscador CIF Logo

Actos BORME Idecon Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Idecon Sa

Actos BORME Idecon Sa - A50042407

Tenemos registrados 40 Actos BORME del Registro Mercantil de Zaragoza para Idecon Sa con CIF A50042407

馃敊 Perfil de Idecon Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Zaragoza

Actos BORME de Idecon Sa

21 de Marzo de 2022
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 176/2021. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 30/12/2021. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ZARAGOZA. Juez: MARIA DEL CARMEN VILLELLASSANCHO. Resoluciones: Aprobado el convenio. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 176/2021. Fecha de resoluci贸n9/07/2021. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DEZARAGOZA. Juez: MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO. Administrador Concursal. Fecha 30/12/2021, NIF/CIF J99561854.NIETO Y MONTES CONCURSAL SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 176/2021.Fecha de resoluci贸n 9/07/2021. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTILNUMERO 2 DE ZARAGOZA. Juez: MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO. Auxiliar Delegado Concursal. Fecha 30/12/2021,NIF/CIF 29087666A. MONTES BEL LUIS. Datos registrales. T 3973 , F 209, S 8, H Z 6241, I/A 69 (14.03.22).

24 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Auditor: Q GLOBALAUDIT SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 3973 , F 209, S 8, H Z6241, I/A 68 (18.11.21).

13 de Septiembre de 2021
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 176/2021. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 9/07/2021. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ZARAGOZA. Juez: MARIA DEL CARMENVILLELLAS SANCHO. Resoluciones: Declarada en concurso voluntario. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 176/2021.

Otros conceptos: PRORROGADO EL PLAZO DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2020, porautorizaci贸n de la administraci贸n concursal y al amparo del art铆culo 115 del TRLSC. Datos registrales. T 3973 , F 209, S 8, H Z 6241,I/A 67 N ( 6.09.21).

10 de Mayo de 2021
Revocaciones. Apo.Manc.: LOZANO GARCIA SERGIO. Apo.Sol.: LOZANO GARCIA SERGIO. Datos registrales. T 3973 , F 209, S8, H Z 6241, I/A 66 ( 3.05.21).

02 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apoderado: CRISTOBAL DE FRANCISCO JOSE LUIS. Datos registrales. T 3973 , F 208, S 8, H Z 6241, I/A 65(23.02.21).

18 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apoderado: GURUCEAGA GOMEZ FERNANDO DANIEL. Datos registrales. T 3973 , F 208, S 8, H Z 6241, I/A 64(11.02.20).

22 de Marzo de 2019
Reelecciones. Adm. Unico: DIGESCAR SL. Datos registrales. T 3973 , F 208, S 8, H Z 6241, I/A 63 (15.03.19).

06 de Febrero de 2019
Nombramientos. Apoderado: GURUCEAGA GOMEZ FERNANDO DANIEL. Datos registrales. T 3973 , F 207, S 8, H Z 6241, I/A 62(28.01.19).

01 de Febrero de 2018
Otros conceptos: Se abre una Sucursal en Zaragoza de la IDECON SA que girar谩 bajo la referencia de "IDECON, S.A.U.SUCURSAL PRINCIPAL". NOMBRAR como REPRESENTANTES DE LA SUCURSAL a los mismos Apoderados que tiene IDECONSA, o sea a: D. Domingo Aguerri San Rafael, D. Sergio Lozano Garcia, D. Jos茅 Manuel G贸mez Royo, D. Juan Carlos Pu茅rtolas Aranday D. Pablo Aguerri del R铆o y a su administradora "DIGESCAR, SL". Cambio de domicilio social. C/ SANTO DOMINGO 6 -POLIGONO INDUSTRIAL CENTROVIA (MUELA (LA)). Datos registrales. T 3973 , F 207, S 8, H Z 6241, I/A 61 (25.01.18).

18 de Enero de 2018
Nombramientos. Auditor: JLC AUDITORES Y ASESORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESI. Datos registrales. T 3973 , F 206, S 8,H Z 6241, I/A 60 (11.01.18).

07 de Diciembre de 2017
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3973 , F 206, S 8, H Z 6241, I/A 59 (28.11.17).

04 de Noviembre de 2016
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: TRADIEL SA. Datos registrales. T 3973 , F 206, S 8, H Z 6241, I/A 58 (27.10.16).

11 de Octubre de 2016
Revocaciones. Apo.Sol.: AGUERRI SAN RAFAEL LEONOR MARIA RITA. Datos registrales. T 3973 , F 206, S 8, H Z 6241, I/A 56 (3.10.16).

Revocaciones. Apoderado: LOZANO MENSAT EDUARDO. Apo.Manc.: AURIA JASO IGNACIO;GOMEZ ROYO JOSEMANUEL;LOZANO MENSAT EDUARDO;SORO OROZ ARMANDO. Datos registrales. T 3973 , F 206, S 8, H Z 6241, I/A 57 (3.10.16).

03 de Junio de 2016
Revocaciones. Apo.Sol.: CELMA MELUS SERGIO;LOZANO MENSAT EDUARDO. Nombramientos. Apoderado: AGUERRI DELRIO PABLO. Datos registrales. T 3973 , F 204, S 8, H Z 6241, I/A 54 (26.05.16).

Revocaciones. Apo.Manc.: LOZANO MENSAT EDUARDO;CELMA MELUS SERGIO. Nombramientos. Apo.Manc.: AGUERRI DELRIO PABLO;GOMEZ ROYO JOSE MANUEL;LOZANO GARCIA SERGIO. Datos registrales. T 3973 , F 204, S 8, H Z 6241, I/A 55(26.05.16).

07 de Enero de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.160.817,32 Euros. Resultante Suscrito: 60.238,28 Euros. Datos registrales. T 3973 , F204, S 8, H Z 6241, I/A 53 (29.12.15).

20 de Agosto de 2015
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3973 , F 204, S 8, H Z 6241, I/A 52 (12.08.15).

28 de Enero de 2015
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3973 , F 204, S 8, H Z 6241, I/A 51 (19.01.15).

25 de Julio de 2014
Revocaciones. Apo.Manc.: SORO OROZ ARMANDO. Apo.Sol.: SORO OROZ ARMANDO. Datos registrales. T 3973 , F 204, S 8, HZ 6241, I/A 49 (17.07.14).

Nombramientos. Apoderado: PUERTOLAS ARANDA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 3973 , F 204, S 8, H Z 6241, I/A 50(17.07.14).

29 de Abril de 2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: AGUERRI SAN RAFAEL DOMINGO. Nombramientos. Adm. Unico: DIGESCAR SL. Datosregistrales. T 3973 , F 203, S 8, H Z 6241, I/A 48 (16.04.14).

05 de Febrero de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3973 , F 203, S 8, H Z 6241, I/A 47 (28.01.14).

14 de Mayo de 2013
Revocaciones. Apoderado: CIKLIC SCHAEFFER ADRIAN JOSE. Apo.Sol.: SORO OROZ ARMANDO;AURIA JASOIGNACIO;GOMEZ ROYO JOSE MANUEL;LOZANO MENSAT EDUARDO. Datos registrales. T 3505 , F 225, S 8, H Z 6241, I/A 44 (6.05.13).

Nombramientos. Apo.Manc.: SORO OROZ ARMANDO;LOZANO MENSAT EDUARDO;GOMEZ ROYO JOSE MANUEL;CELMAMELUS SERGIO;LOZANO GARCIA SERGIO. Datos registrales. T 3505 , F 225, S 8, H Z 6241, I/A 45 ( 6.05.13).

Nombramientos. Apo.Sol.: SORO OROZ ARMANDO;LOZANO MENSAT EDUARDO;GOMEZ ROYO JOSE MANUEL;CELMAMELUS SERGIO;LOZANO GARCIA SERGIO. Datos registrales. T 3973 , F 203, S 8, H Z 6241, I/A 46 ( 6.05.13).

01 de Febrero de 2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3505 , F 225, S 8, H Z 6241, I/A 43 (24.01.13).

25 de Enero de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3505 , F 225, S 8, H Z 6241, I/A 42 (16.01.12).

18 de Mayo de 2011
Revocaciones. Apo.Sol.: DE ANA GARCIA ALFREDO;OLIVER DRUET BRUNO;SORO OROZ ARMANDO;AURIA JASOIGNACIO;GOMEZ ROYO JOSE MANUEL;LOZANO MENSAT EDUARDO. Datos registrales. T 3505 , F 225, S 8, H Z 6241, I/A 41 (7.05.11).

29 de Marzo de 2011
Revocaciones. Apoderado: MARTIN BENAVIDES MARIA ANGELES;RIVAS DE LA RIEGA JOSE LUIS;SAN RAFAEL TAUS ANAMARIA. Apo.Sol.: SAN RAFAEL TAUS ANA MARIA. Apoderado: SAN RAFAEL TAUS ANA MARIA. Datos registrales. T 3505 , F225, S 8, H Z 6241, I/A 40 (17.03.11).

14 de Febrero de 2011
Modificaciones estatutarias. Art铆culo 31.- El cargo de administrador ser谩 retribuido y su retribuci贸n consistir谩 en una cantidad fijaanual que deber谩 ser establecida por la Junta General en funci贸n de su efectiva dedicaci贸n. La retribuci贸n anterior ser谩 compatible yseentender谩 independiente de la posible retribuci贸n -o. Cambio de objeto social. a) La construcci贸n, conservaci贸n, mantenimiento yexplotaci贸n de toda clase de obra, ya sea p煤blica como privada, realizando los trabajos necesarios para ello como: Movimiento detierras y perforaciones; puentes, viaductos, y grandes estructuras; edificaciones, demoliciones y alba帽iler铆a en general;. Datosregistrales. T 3505 , F 224, S 8, H Z 6241, I/A 38 (31.01.11).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3505 , F 225, S 8, H Z 6241, I/A 39 (31.01.11).

24 de Diciembre de 2010
Nombramientos. Apoderado: CIKLIC SCHAEFFER ADRIAN JOSE. Apo.Sol.: SORO OROZ ARMANDO;AURIA JASOIGNACIO;GOMEZ ROYO JOSE MANUEL;LOZANO MENSAT EDUARDO. Datos registrales. T 3505 , F 223, S 8, H Z 6241, I/A 37(14.12.10).

05 de Octubre de 2009
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3505 , F 223, S 8, H Z 6241, I/A 36 (24.09.09).

10 de Junio de 2009
Revocaciones. Apo.Manc.: SORO OROZ ARMANDO. Apo.Sol.: LOZANO MENSAT EDUARDO;SORO OROZ ARMANDO;GOMEZROYO JOSE MANUEL. Apo.Manc.: LOZANO MENSAT EDUARDO;GOMEZ ROYO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3505 , F223, S 8, H Z 6241, I/A 35 ( 1.06.09).

22 de Mayo de 2009
Reelecciones. Adm. Unico: AGUERRI SAN RAFAEL DOMINGO. Datos registrales. T 3505 , F 223, S 8, H Z 6241, I/A 34(12.05.09).

11 de Febrero de 2009
Nombramientos. Apo.Manc.: SORO OROZ ARMANDO;LOZANO MENSAT EDUARDO;GOMEZ ROYO JOSE MANUEL;AURIA JASOIGNACIO. Datos registrales. T 3505 , F 222, S 8, H Z 6241, I/A 32 (30.01.09).

Nombramientos. Apo.Sol.: DE ANA GARCIA ALFREDO;OLIVER DRUET BRUNO;SORO OROZ ARMANDO;AURIA JASOIGNACIO;GOMEZ ROYO JOSE MANUEL;LOZANO MENSAT EDUARDO. Datos registrales. T 3505 , F 222, S 8, H Z 6241, I/A 33(30.01.09).

02 de Enero de 2009
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3505 , F 222, S 8, H Z 6241, I/A 31 (19.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n