Actos BORME de Ids Boadilla Garden Residencial Sociedad Anonima
30 de Agosto de 2023Cancelaciones de oficio de nombramientos. Vicepresid.: BON NATURA SA. Reelecciones. SecreNoConsj: ASTORGA MORANORICARDO. VsecrNoConsj: IRIARTE BORREGO PABLO. Consejero: PUMAR LOPEZ FRANCISCO;BON NATURA SA;PUMAR LOPEZRICARDO;GALAN GONZALEZ JOSE LUIS;ALARCON BAENA JUAN MARIA. Presidente: PUMAR LOPEZ RICARDO. Consejero:TESTA CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA. Otros conceptos: LUIS ALARCON DE FRANCISCO ES REPRESENTANTEPERSONA FISICA DE LA ENTIDAD "BON NATURA SA" EN EL EJERCICIO DEL CARGO DE CONSEJERO DE "IDS MONTEVILLARESIDENCIAL SOCIEDAD ANONIMA" JUAN BOSCO VILLAGRAN NU脩EZ ES REPRESENTANE PERSONA FISICA DE "TESTACONSULTORES, S.L.", EN EL EJERCICIO DEL CARGO DE CONSEJERO EN LA SOCIEDAD "IDS MONTEVILLA RESIDENCIALSOCIEDAD ANONIMA". Datos registrales. T 6398 , F 146, S 8, H SE114289, I/A 20 (11.08.23).
21 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: ESTEBAN BERNAL FRANCISCO. Nombramientos. VsecrNoConsj: IRIARTE BORREGOPABLO. Datos registrales. T 6398 , F 145, S 8, H SE114289, I/A 17 (10.03.23).
Nombramientos. Apoderado: PEREZ GONZALEZ JORGE. Datos registrales. T 6398 , F 145, S 8, H SE114289, I/A 18 (13.03.23).
Revocaciones. Apoderado: CRISTOBAL GONZALEZ FELIX. Otros conceptos: REVOCADO el PODER NO INSCRITO conferido adon F茅lix Crist贸bal Gonz谩lez, mediante escritura otorgada ante la Notario de Sevilla, do帽a Montserrat Alvarez S谩nchez, el d铆a veintiunode julio de dos mil veinte, bajo el n煤mero 1129 de protocolo. Datos registrales. T 6398 , F 145, S 8, H SE114289, I/A 19 (14.03.23).
02 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ PRADO RAFAEL. Datos registrales. T 6398 , F 145, S 8, H SE114289, I/A 16 (26.10.22).
24 de Octubre de 2022Nombramientos. Apoderado: DE FRANCISCO SANZ MANUEL. Datos registrales. T 6398 , F 144, S 8, H SE114289, I/A 15(17.10.22).
16 de Junio de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.008.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.492.000,00 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 6. Capital social.-. Datos registrales. T 6398 , F 144, S 8, H SE114289, I/A 14 ( 9.06.22).
27 de Noviembre de 2020Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 6398 , F 143, S 8, H SE114289, I/A 13 (20.11.20).
02 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ PRADO RAFAEL. Datos registrales. T 6398 , F 143, S 8, H SE114289, I/A 12 (25.11.19).
16 de Enero de 2019Revocaciones. Apoderado: PUMAR LOPEZ FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado: PUMAR LOPEZ FRANCISCO. Datosregistrales. T 6398 , F 141, S 8, H SE114289, I/A 11 ( 8.01.19).
28 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLAGRAN NU脩EZ JUAN BOSCO. Nombramientos. Consejero: TESTA CONSULTORESSOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 6398 , F 141, S 8, H SE114289, I/A 10 (19.12.18).
19 de Octubre de 2018Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ MAVILLARD JOSE LUIS. Datos registrales. T 6398 , F 140, S 8, H SE114289, I/A 9(11.10.18).
12 de Diciembre de 2017Nombramientos. Apoderado: CRISTOBAL GONZALEZ FELIX. Datos registrales. T 6398 , F 140, S 8, H SE114289, I/A 8(29.11.17).
05 de Octubre de 2017Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.500.000,00 Euros. Desembolsado: 2.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.500.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 4.500.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 6. Capital social.-. Datosregistrales. T 6398 , F 139, S 8, H SE114289, I/A 7 (27.09.17).
07 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: ZAPATERO MIGUELEZ GUSTAVO. Datos registrales. T 6398 , F 136, S 8, H SE114289, I/A 4(28.06.17).
Nombramientos. Apoderado: AYALA MARTINEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 6398 , F 137, S 8, H SE114289, I/A 5 (29.06.17).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GOMEZ DOMINGO. Datos registrales. T 6398 , F 138, S 8, H SE114289, I/A 6(29.06.17).
05 de Julio de 2017Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 19.06.17. Objeto social: La adquisici贸n, promoci贸n inmobiliaria y enajenaci贸n -antes ydurante la promoci贸n- de las Parcelas R-8 y R-14, Fincas Registrales N煤mero 25.105 y 25.111, respectivamente, del Registro de laPropiedad de Boadilla del Monte,. Domicilio: C/ ANGEL GELAN 2 (SEVILLA). Capital suscrito: 2.000.000,00 Euros. Desembolsado:2.000.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: PUMAR LOPEZ FRANCISCO;BON NATURA SA;VILLAGRAN NU脩EZ JUANBOSCO;LOPEZ PUMAR RICARDO;GALAN GONZALEZ JOSE LUIS;ALARCON BAENA JUAN MARIA. Datos registrales. T 6398 , F130, S 8, H SE114289, I/A 1 (28.06.17).
Nombramientos. Presidente: LOPEZ PUMAR RICARDO. Vicepresid.: BON NATURA SA. SecreNoConsj: ASTORGA MORANORICARDO. VsecrNoConsj: ESTEBAN BERNAL FRANCISCO. Datos registrales. T 6398 , F 134, S 8, H SE114289, I/A 2 (28.06.17).
Nombramientos. Apoderado: PUMAR LOPEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 6398 , F 135, S 8, H SE114289, I/A 3 (28.06.17).