Actos BORME de Ie2 Holdco Sa
10 de Febrero de 2023Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 1126 , F 179, S 8, H S 30206, I/A 22 (26.01.23).
14 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Datos registrales. T 1126 , F 179, S 8, H S 30206, I/A20 ( 1.12.21).
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 45.000,00 Euros. Datos registrales. T 1126 , F 179, S 8, H S 30206, I/A 21 (2.12.21).
24 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ ALCANTARA JUAN MIGUEL. Apo.Manc.: GOUVEIA CARVALHO JOAO RUI
25 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ANTO脩ANZAS ALVEAR MIGUEL;DEVESA DEL BARRIO MIGUEL-ANGEL. Revocaciones.Apo.Man.Soli: DEVESA DEL BARRIO MIGUEL-ANGEL. Nombramientos. Adm. Mancom.: MATEOS VALLES MIGUELCELSO;GOUVEIA CARVALHO JOAO. Apo.Man.Soli: GOUVEIA CARVALHO JOAO. Apoderado: ARRIBAS ARIAS FELIX. Datosregistrales. T 1126 , F 176, S 8, H S 30206, I/A 18 (15.02.21).
04 de Febrero de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Datos registrales. T 1126 , F 176, S 8, H S 30206, I/A17 (26.01.21).
19 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: EVERIS SPAIN SL. Datos registrales. T 1126 , F 176, S 8, H S 30206, I/A 16 (10.03.20).
15 de Enero de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Datos registrales. T 1126 , F 176, S 8, H S 30206, I/A15 ( 7.01.20).
16 de Abril de 2019Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ GUTIERREZ JOSE-ANTONIO. Datos registrales. T 1126 , F 175, S 8, H S 30206, I/A 14 (8.04.19).
19 de Diciembre de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: ANZOLA PEREZ JAVIER;RODRIGUEZ GONZALEZ CESAR RUFINO;AGUILERA TUBET JAVIER.Apo.Sol.: AGUILERA TUBET JAVIER. Datos registrales. T 1126 , F 175, S 8, H S 30206, I/A 13 (10.12.18).
20 de Noviembre de 2018Modificaciones estatutarias. 6潞.- Relativo a la no retribuci贸n del cargo de administrador.. Datos registrales. T 1126 , F 175, S 8, HS 30206, I/A 12 (12.11.18).
13 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: ALONSO SANCHEZ SUSANA. Datos registrales. T 1126 , F 174, S 8, H S 30206, I/A 11 (29.10.18).
07 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: DELGADO DELGADO DAVID. Datos registrales. T 1126 , F 174, S 8, H S 30206, I/A 10 (29.10.18).
05 de Julio de 2018Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Datos registrales. T 1126 , F 174, S 8, H S 30206, I/A 9(29.06.18).
18 de Abril de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: RABAGO TEJA RICARDO. Datos registrales. T 1126 , F 174, S 8, H S 30206, I/A 8 (11.04.18).
16 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: AGUILERA TUBET JAVIER. Datos registrales. T 1126 , F 173, S 8, H S 30206, I/A 7 ( 6.03.17).
05 de Abril de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: ANZOLA PEREZ JAVIER;SANCHEZ DIAZ DE LA CAMPA MANUEL;DEVESA DEL BARRIOMIGUEL-ANGEL;RODRIGUEZ LOPEZ FRANCISCO;TEMBOURY MOLINA JAVIER;NAVARRO VARELA MANUEL;ALONSOSANCHEZ SUSANA;VALERO DE BERNABE TEIJEIRA MONICA MARIA;OROZ GUINEA BRUNO;RABAGO TEJARICARDO;MERINO MORO JESUS;GARCIA GONZALEZ DE RIANCHO MARTA ISABEL;RODRIGUEZ GONZALEZ CESARRUFINO;VALLE GUTIERREZ LEOPOLDO JOSE;CERVERA SAN JOSE MARTA;AGUILERA TUBET JAVIER;DELGADO DELGADODAVID;GONZALEZ MILLAN RUBEN;MARTINEZ ZAMACOLA IGNACIO;ALVAREZ RAMOS MARIA ANGELES. Datos registrales. T1113 , F 142, S 8, H S 30206, I/A 6 (28.03.16).
28 de Marzo de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: ALONSO SANCHEZ SUSANA;RODRIGUEZ LOPEZ FRANCISCO. Apo.Man.Soli: DEVESA DEL BARRIOMIGUEL-ANGEL. Apo.Sol.: ALVAREZ RAMOS MARIA ANGELES. Apo.Manc.: DELGADO DELGADO DAVID;CERVERA SAN JOSEMARTA;GONZALEZ MILLAN RUBEN;MARTINEZ ZAMACOLA IGNACIO;LOPEZ YESTE BELEN;VALLE GUTIERREZ LEOPOLDOJOSE;SANCHEZ DIAZ DE LA CAMPA MANUEL;ANZOLA PEREZ JAVIER. Datos registrales. T 1113 , F 142, S 8, H S 30206, I/A 5(14.03.16).
27 de Enero de 2016Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Datos registrales. T 1113 , F 142, S 8, H S 30206,I/A 4 (19.01.16).
17 de Diciembre de 2015Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: VIESGO HOLDCO SA. Datos registrales. T 1113 , F 141, S 8, H S30206, I/A 3 ( 7.12.15).
24 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO SANCHEZ SUSANA;RODRIGUEZ LOPEZ FRANCISCO. Apo.Man.Soli: DEVESA DEL BARRIOMIGUEL-ANGEL. Apo.Sol.: ALVAREZ RAMOS MARIA ANGELES. Apo.Manc.: DELGADO DELGADO DAVID;CERVERA SAN JOSEMARTA;GONZALEZ MILLAN RUBEN;MARTINEZ ZAMACOLA IGNACIO;LOPEZ YESTE BELEN;VALLE GUTIERREZ LEOPOLDOJOSE;SANCHEZ DIAZ DE LA CAMPA MANUEL;ANZOLA PEREZ JAVIER. Datos registrales. T 1113 , F 140, S 8, H S 30206, I/A 2(16.11.15).
05 de Noviembre de 2015Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 29.09.15. Objeto social: Emisi贸n de obligaciones, participaciones preferentes y otrosinstrumentos de deudas negociables en mercados secundarios organizados espa帽oles y extranjeros. Domicilio: C/ ISABEL TORRES25 (SANTANDER). Capital suscrito: 60.000,00 Euros. Desembolsado: 15.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio煤nico: VIESGO INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SL. Nombramientos. Adm. Mancom.: ANTO脩ANZAS ALVEARMIGUEL;DEVESA DEL BARRIO MIGUEL-ANGEL. Datos registrales. T 1113 , F 139, S 8, H S 30206, I/A 1 (28.10.15).