Actos BORME de Ielab Calidad Sl
06 de Octubre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: CALDERON ARENAS MARIA JESUS;MORRAL ROMERO ALVARO. Datos registrales. T 4601 , F 125,S 8, H A 145919, I/A 29 (27.09.23).
14 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apoderado: BENITO LOPEZ MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apoderado: REVUELTA RUEDA BEATRIZ. Datosregistrales. T 4601 , F 124, S 8, H A 145919, I/A 28 ( 6.09.23).
28 de Agosto de 2023Nombramientos. Apoderado: MASA VIDAL LAURA. Datos registrales. T 4443 , F 208, S 8, H A 145919, I/A 27 (18.08.23).
04 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: SASTRE GONZALEZ ESTIBALIZ. Datos registrales. T 4443 , F 206, S 8, H A 145919, I/A 26 (25.10.22).
23 de Marzo de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: RIBALAYGUE CALZADA SONIA;LLOSES MERCADAL YVET. Nombramientos. Apo.Man.Soli:RIBALAYGUE CALZADA SONIA;YUS ARNAL ROSA MARIA;GUTIERREZ GUTIERREZ PATRICIA. Datos registrales. T 4443 , F206, S 8, H A 145919, I/A 25 (15.03.22).
16 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: MIQUEL ROMERA TERESA. Datos registrales. T 4443 , F 205, S 8, H A 145919, I/A 24 ( 9.03.22).
10 de Febrero de 2022Revocaciones. Apoderado: CATALAN CUENCA VICENTE. Datos registrales. T 4443 , F 205, S 8, H A 145919, I/A 23 ( 2.02.22).
09 de Febrero de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: NAVALON MADRIGAL PEDRO. Datos registrales. T 4195 , F 92, S 8, H A 145919, I/A 22 ( 1.02.22).
18 de Noviembre de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: SUEZ SPAIN SL. Datos registrales. T 4195 , F 92, S 8, H A 145919,I/A 21 (10.11.21).
08 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apoderado: SORIANO BELDA RAFAEL. Datos registrales. T 4195 , F 90, S 8, H A 145919, I/A 20 (31.08.21).
10 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: BENITO LOPEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 4195 , F 89, S 8, H A 145919, I/A 19(30.04.21).
29 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Apo.Man.Soli: YUS ARNAL ROSA MARIA. Datos registrales. T 4195 , F 89, S 8, H A 145919, I/A 18 (18.03.21).
07 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: DOMINGO TALLARICO FERNANDO. Datos registrales. T 4115 , F 12, S 8, H A 145919, I/A 17(28.02.19).
21 de Agosto de 2018Nombramientos. Apoderado: MIQUEL ROMERA TERESA. Datos registrales. T 4115 , F 12, S 8, H A 145919, I/A 16 (10.08.18).
17 de Julio de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: ANDRE ROMERO FERNANDO;CARRETERO GARCIA MANUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: MORAMUÑOZ JORGE RAUL;LOPEZ CUEVAS JUAN MANUEL. Datos registrales. T 4115 , F 11, S 8, H A 145919, I/A 15 ( 9.07.18).
12 de Abril de 2018Nombramientos. Apoderado: CATALAN CUENCA VICENTE. Datos registrales. T 4115 , F 10, S 8, H A 145919, I/A 14 ( 4.04.18).
11 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: CERMERON ROMERO MANUEL;PASCUAL GISBERT GUILLERMO. Nombramientos. Adm.Unico: PASCUAL GISBERT GUILLERMO. Modificaciones estatutarias. Artículo 20. Sistema de administración. Artículo 21º.Nombramiento de administradores. Funcionamiento del consejo de administración. Artículo 22º. Representación de la Sociedad ypoderes.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Datosregistrales. T 3921 , F 161, S 8, H A 145919, I/A 13 ( 3.04.18).
28 de Agosto de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: ANDRE ROMERO FERNANDO. Apoderado: CORA VITALLER FRANCESC XAVIER. Nombramientos.Apo.Sol.: ANDRE ROMERO FERNANDO;CARRETERO GARCIA MANUEL. Datos registrales. T 3921 , F 161, S 8, H A 145919, I/A12 (18.08.17).
24 de Mayo de 2017Nombramientos. Apoderado: GARCIA BERENGUER PABLO. Datos registrales. T 3921 , F 160, S 8, H A 145919, I/A 11 (16.05.17).
06 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: FABREGUES GARCIA JORDINA. Datos registrales. T 3921 , F 158, S 8, H A 145919, I/A 10(22.02.17).
14 de Octubre de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: MIRALLES ROLDAN JOAN. Datos registrales. T 3921 , F 158, S 8, H A 145919, I/A 9 ( 5.10.16).
18 de Marzo de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: MIRALLES ROLDAN JOAN;RIBALAYGUE CALZADA SONIA;LLOSES MERCADAL YVET;YUSARNAL ROSA MARIA. Datos registrales. T 3921 , F 158, S 8, H A 145919, I/A 8 (11.03.16).
17 de Febrero de 2016Revocaciones. Apoderado: TORNE CAYON JUDIT. Nombramientos. Apo.Man.Soli: TORNE CAYON JUDIT. Apo.Manc.: SIMONLLUMA FERRAN. Datos registrales. T 3875 , F 38, S 8, H A 145919, I/A 7 (10.02.16).
09 de Febrero de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: MIRALLES ROLDAN JOAN;RIBALAYGUE CALZADA SONIA;LLOSES MERCADAL YVET;YUSARNAL ROSA MARIA. Datos registrales. T 3875 , F 37, S 8, H A 145919, I/A 6 ( 2.02.16).
19 de Enero de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: MIRALLES ROLDAN JOAN;RIBALAYGUE CALZADA SONIA;DE PRADO LUENGO JORGE.Nombramientos. Apo.Man.Soli: MIRALLES ROLDAN JOAN;RIBALAYGUE CALZADA SONIA;LLOSES MERCADAL YVET;YUSARNAL ROSA MARIA. Datos registrales. T 3875 , F 36, S 8, H A 145919, I/A 5 (12.01.16).
11 de Noviembre de 2015Revocaciones. Apoderado: MARTIN VALDES MARCOS. Nombramientos. Apo.Sol.: ANDRE ROMERO FERNANDO. Apoderado:CORA VITALLER FRANCESC XAVIER. Datos registrales. T 3875 , F 36, S 8, H A 145919, I/A 4 ( 3.11.15).
04 de Septiembre de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: SABOYA PASCUAL MONTSERRAT. Datos registrales. T 3875 , F 36, S 8, H A 145919, I/A 3 (28.08.15).
24 de Julio de 2015Cambio de domicilio social. C/ DRACMA 16-18 - POLIGONO INDUSTRIAL LAS ATALAYAS (ALICANTE). Datos registrales. T3875 , F 36, S 8, H A 145919, I/A 2 (17.07.15).
05 de Febrero de 2015Nombramientos. APODERAD.SOL: TORNE CAYON JUDIT. Datos registrales. T 42713 , F 202, S 8, H B 324038, I/A 11 (28.01.15).
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: MIRALLES ROLDAN JOAN;RIBALAYGUE CALZADA SONIA;DE PRADO LUENGO JORGE.Datos registrales. T 42713 , F 203, S 8, H B 324038, I/A 12 (28.01.15).
28 de Octubre de 2014Revocaciones. APODERAD.SOL: RODRIGUEZ MARGALEF ANNA. Nombramientos. APODERAD.SOL: MARTIN VALDESMARCOS. Datos registrales. T 42713 , F 201, S 8, H B 324038, I/A 10 (21.10.14).
17 de Julio de 2013Nombramientos. APODERAD.SOL: SABOYA PASCUAL MONTSERRAT;RODRIGUEZ MARGALEF ANNA. Datos registrales. T42713 , F 201, S 8, H B 324038, I/A 9 (10.07.13).
24 de Octubre de 2012Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: CAMPOS CALLAO CARLOS. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: CERMERON ROMEROMANUEL. Datos registrales. T 42713 , F 201, S 8, H B 324038, I/A 8 (11.10.12).
15 de Julio de 2011Otros conceptos: SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO:LABAQUA SA. Datos registrales. T 42713 , F 201, S 8, H B 324038,I/A 7 ( 5.07.11).
25 de Noviembre de 2010Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: PASCUAL GISBERT GUILLERMO. Datos registrales. T 38233 , F 75, S 8, H B 324038, I/A 5
Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: CAMPOS CALLAO CARLOS. Datos registrales. T 38233 , F 75, S 8, H B 324038, I/A 6(12.11.10).
08 de Noviembre de 2010Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: DE MIGUEL GOMEZ JONAS. Datos registrales. T 38233 , F 75, S 8, H B 324038, I/A 4 (25.10.10).
25 de Mayo de 2010Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: APRAIZ GOYENAGA DAVID. Datos registrales. T 38233 , F 75, S 8, H B 324038, I/A 3 (13.05.10).