Actos BORME de Igmo Sl
14 de Enero de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: JAINAGA URIARTE JOSEBA ANDONI. Apoderado: JAINAGA URIARTE JOSEBA ANDONI;LOPEZ DEVERGARA LASA ITZIAR;LOPEZ ORTIZ MARIA;MUJIKA ZAPIRAIN ALBERT. Datos registrales. T 747, L 538, F 192, S 8, H BU1460, I/A 39 (10.01.22).
Nombramientos. Apoderado: ERA脩A URIARTE MIREN MAITE. Datos registrales. T 747, L 538, F 192, S 8, H BU 1460, I/A 40(10.01.22).
04 de Marzo de 2021Reelecciones. Auditor: LKS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 747, L 538, F 191, S 8, H BU 1460, I/A 36 (26.02.21).
10 de Febrero de 2020Reelecciones. Auditor: LKS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 747, L 538, F 191, S 8, H BU 1460, I/A 35 ( 4.02.20).
06 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apoderado: GAGO ONECHA LAURA. Datos registrales. T 747, L 538, F 190, S 8, H BU 1460, I/A 34 (30.10.19).
25 de Abril de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: JAINAGA URIARTE JOSEBA ANDONI;RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA. Apoderado: MUGICA ZAPIRAINALBERT;ERA脩A URIARTE MIREN MAITE;LOPEZ ORTIZ MARIA. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA. Datos registrales. T747, L 538, F 190, S 8, H BU 1460, I/A 33 (16.04.19).
13 de Agosto de 2018Nombramientos. Apoderado: ERA脩A URIARTE MIREN MAITE. Datos registrales. T 747, L 538, F 186, S 8, H BU 1460, I/A 28 (6.08.18).
Nombramientos. Apoderado: GAGO ONECHA LAURA. Datos registrales. T 747, L 538, F 187, S 8, H BU 1460, I/A 29 ( 6.08.18).
Nombramientos. Apoderado: MUJIKA ZAPIRAIN ALBERT. Datos registrales. T 747, L 538, F 187, S 8, H BU 1460, I/A 30 (6.08.18).
Nombramientos. Apoderado: PEREZ IGLESIAS SARA. Datos registrales. T 747, L 538, F 188, S 8, H BU 1460, I/A 31 ( 6.08.18).
Nombramientos. Apoderado: ARCOS FONCILLAS JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 747, L 538, F 189, S 8, H BU 1460, I/A 32 (6.08.18).
01 de Agosto de 2018Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA. Datos registrales. T 703, L 494, F 161, S 8, H BU 1460, I/A 24(26.07.18).
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ ORTIZ MARIA. Datos registrales. T 703, L 494, F 164, S 8, H BU 1460, I/A 25 (26.07.18).
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ DE VERGARA LASA ITZIAR. Datos registrales. T 703, L 494, F 166, S 8, H BU 1460, I/A 26(26.07.18).
Nombramientos. Apoderado: GINE BENAIGUES ROSA. Datos registrales. T 747, L 538, F 185, S 8, H BU 1460, I/A 27 (26.07.18).
13 de Julio de 2017Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: AUSOLAN RCN SL. Datos registrales. T 703, L 494, F 161, S 8, HBU 1460, I/A 22 ( 6.07.17).
03 de Abril de 2017Reelecciones. Auditor: LKS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 703, L 494, F 160, S 8, H BU 1460, I/A 21 (28.03.17).
08 de Marzo de 2016Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: IGMO SERVICIOS EDUCATIVOS SL. LIMPIEZAS IGMO SL. Datos registrales. T678, L 469, F 225, S 8, H BU 1460, I/A 20 ( 2.03.16).
30 de Diciembre de 2015Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: COCINA CENTRAL MAGUI SL. Datos registrales. T 678, L 469, F 225, S 8, H BU1460, I/A 19 (22.12.15).
10 de Agosto de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: JAINAGA URIARTE JOSEBA ANDONI;RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA. Apoderado: JAINAGAURIARTE JOSEBA ANDONI. Datos registrales. T 678, L 469, F 223, S 8, H BU 1460, I/A 18 ( 4.08.15).
15 de Junio de 2015Revocaciones. Apoderado: LOPEZ ORTIZ MARIA. Datos registrales. T 678, L 469, F 223, S 8, H BU 1460, I/A 17 ( 9.06.15).
17 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apoderado: ERA脩A URIARTE MIREN MAITE. Datos registrales. T 678, L 469, F 221, S 8, H BU 1460, I/A 15(29.07.14).
05 de Agosto de 2014Nombramientos. Apoderado: LOPEZ ORTIZ MARIA. Datos registrales. T 667, L 458, F 132, S 8, H BU 1460, I/A 14 (29.07.14).
Nombramientos. Apoderado: MUGICA ZAPIRAIN ALBERT. Datos registrales. T 678, L 469, F 222, S 8, H BU 1460, I/A 16(29.07.14).
09 de Julio de 2014Cambio de objeto social. La elaboraci贸n, distribuci贸n y servicio de comidas destinadas a ser consumidas de forma colectiva oindividual y su venta. Prestaci贸n de servicios de asesoramiento en hosteleria, servicios de limpieza, servicios auxiliares ycomplementarios, servicios de monitores escolares,servicios de jardiner铆a. Datos registrales. T 667, L 458, F 132, S 8, H BU 1460,I/A 13 ( 2.07.14).
10 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: JAINAGA URIARTE JOSEBA ANDONI;RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA;ROA BEDIA SUSANA.Presidente: JAINAGA URIARTE JOSEBA ANDONI. Secretario: RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA. Nombramientos. Adm. Unico:AUZO LAGUN S. COOP. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 667, L 458, F 131, S 8, H BU 1460, I/A 12 ( 4.02.14).
Nombramientos. Auditor: LKS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 667, L 458, F 131, S 8, H BU 1460, I/A 13 ( 4.02.14).
18 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apoderado: LOPEZ ORTIZ MARIA. Datos registrales. T 667, L 458, F 131, S 8, H BU 1460, I/A 11 (12.11.13).
23 de Septiembre de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: JAINAGA URIARTE JOSEBA ANDONI;RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA. Datos registrales. T 409, L200, F 18, S 8, H BU 1460, I/A 9 (17.09.13).
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 154.213,29 Euros. Resultante Suscrito: 101.109,54 Euros. Cambio de domicilio social.CTRA MADRID-IRUN Km 244 - COMPLEJO GALA, NAVES 313 (BURGOS). Datos registrales. T 667, L 458, F 130, S 8, H BU 1460,I/A 10 (17.09.13).
16 de Septiembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: DELGADO LACALLE MARIA VICTORIA. Presidente: DELGADO LACALLE MARIA VICTORIA.Consejero: PEDROSA SAEZ SALVADOR. Secretario: MORAZA HERRAN JOSE IGNACIO. Consejero: MORAZA HERRAN JOSEIGNACIO. Con.Delegado: PEDROSA SAEZ SALVADOR. Nombramientos. Consejero: JAINAGA URIARTE JOSEBAANDONI;RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA;ROA BEDIA SUSANA. Presidente: JAINAGA URIARTE JOSEBA ANDONI. Secretario:RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA. Datos registrales. T 409, L 200, F 18, S 8, H BU 1460, I/A 8 ( 9.09.13).
09 de Junio de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 200.331,33 Euros. Resultante Suscrito: 255.322,83 Euros. Datos registrales. T 409, L 200, F 17, S8, H BU 1460, I/A 7 (29.05.09).