Buscador CIF Logo

Actos BORME Ikasa Actividad De Promocion Inmobiliaria Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ikasa Actividad De Promocion Inmobiliaria Sl

Actos BORME Ikasa Actividad De Promocion Inmobiliaria Sl - B87698890

Tenemos registrados 26 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Ikasa Actividad De Promocion Inmobiliaria Sl con CIF B87698890

馃敊 Perfil de Ikasa Actividad De Promocion Inmobiliaria Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Ikasa Actividad De Promocion Inmobiliaria Sl

16 de Agosto de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ ANES GLORIA. Apo.Manc.: RODRIGUEZ ANES GLORIA. Datos registrales. T 41928 , F191, S 8, H M 635459, I/A 26 ( 8.08.23).

05 de Enero de 2023
Revocaciones. Apoderado: ARAUZO CANCELA ROBERTO. Datos registrales. T 41928 , F 191, S 8, H M 635459, I/A 25(29.12.22).

30 de Diciembre de 2022
Ampliaci贸n de capital. Capital: 35.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 335.000,00 Euros. Datos registrales. T 41928 , F 190, S 8, HM 635459, I/A 24 (22.12.22).

04 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apoderado: CA脩IZARES GOMEZ SILVIA. Datos registrales. T 41928 , F 190, S 8, H M 635459, I/A 23 (28.07.22).

24 de Junio de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: LUENGO GARCIA DAVID JOSE. Datos registrales. T 41928 , F 190, S 8, H M 635459, I/A 22 (17.06.22).

17 de Junio de 2021
Revocaciones. Apoderado: BENITO LEBORANS MARIA CATRINA. Datos registrales. T 38526 , F 144, S 8, H M 635459, I/A 21(10.06.21).

08 de Junio de 2021
Nombramientos. Apoderado: ARAUZO CANCELA ROBERTO. Datos registrales. T 38526 , F 144, S 8, H M 635459, I/A 20 (1.06.21).

06 de Abril de 2021
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: INVERSIONES MOLDAVIA SL. URANTIS SL. PROMOCION EBRO 25 LAS ROZASSL. Datos registrales. T 38526 , F 139, S 8, H M 635459, I/A 19 (26.03.21).

15 de Marzo de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALCOJOR VALOR MATIAS;LEON MARTINEZ JOSE MANUEL;VEGAS BECERRIL ASIER. Datosregistrales. T 38526 , F 139, S 8, H M 635459, I/A 18 ( 8.03.21).

01 de Febrero de 2021
Reelecciones. Auditor: BNFIX AUDIT AUDITORES SLP. Datos registrales. T 38526 , F 139, S 8, H M 635459, I/A 17 (25.01.21).

20 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apo.Sol.: VEGAS BECERRIL ASIER. Datos registrales. T 38526 , F 139, S 8, H M 635459, I/A 16 (13.11.20).

24 de Junio de 2020
Cambio de domicilio social. CSTA. DE SAN VICENTE 12 - LOCAL (MADRID). Datos registrales. T 38526 , F 138, S 8, H M635459, I/A 15 (17.06.20).

25 de Mayo de 2020
Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ ARAUJO MARIELA BEATRIZ. Datos registrales. T 38526 , F 138, S 8, H M 635459, I/A 14(18.05.20).

30 de Diciembre de 2019
Reelecciones. Auditor: BNFIX AUDIT AUDITORES SLP. Datos registrales. T 38526 , F 138, S 8, H M 635459, I/A 13 (20.12.19).

25 de Julio de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BENITO LEBORANS MARIA CATRINA;TOVAR CUETARA MARTA. Datos registrales. T 38526 , F137, S 8, H M 635459, I/A 10 (17.07.19).

Revocaciones. Apo.Sol.: SIERRA GOMEZ ALBERTO. Datos registrales. T 38526 , F 137, S 8, H M 635459, I/A 11 (17.07.19).

Nombramientos. Apoderado: BAYON ASENJO SARA;BENITO LEBORANS MARIA CATRINA. Datos registrales. T 38526 , F 138,S 8, H M 635459, I/A 12 (17.07.19).

19 de Febrero de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: ALCOJOR VALOR MATIAS;VEGAS BECERRIL ASIER;LEON MARTINEZ JOSE MANUEL;LUENGOGARCIA DAVID JOSE;GONZALEZ ARAUJO MARIELA BEATRIZ. Datos registrales. T 35347 , F 121, S 8, H M 635459, I/A 9(12.02.19).

19 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALCOJOR VALOR MATIAS;LEON MARTINEZ JOSE MANUEL;VEGAS BECERRIL ASIER. Datosregistrales. T 35347 , F 121, S 8, H M 635459, I/A 8 ( 8.11.18).

25 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BENITO LEBORANS MARIA CATRINA;TOVAR CUETARA MARTA. Datos registrales. T 35347 , F120, S 8, H M 635459, I/A 7 (17.10.18).

22 de Junio de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: SIERRA GOMEZ ALBERTO;DIAZ GARCIA MARIA PILAR. Apoderado: DIAZ GARCIA MARIAPILAR;SIERRA GOMEZ ALBERTO. Nombramientos. Apo.Sol.: DIAZ GARCIA MARIA PILAR;SIERRA GOMEZALBERTO;FERNANDEZ RUBIO JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 35347 , F 117, S 8, H M 635459, I/A 6 (15.06.18).

28 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: DIAZ GARCIA MARIA PILAR;SIERRA GOMEZ ALBERTO. Datos registrales. T 35347 , F 117, S 8, HM 635459, I/A 5 (20.11.17).

28 de Agosto de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: SIERRA GOMEZ ALBERTO. Datos registrales. T 35347 , F 116, S 8, H M 635459, I/A 3 (14.08.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: DIAZ GARCIA MARIA PILAR. Datos registrales. T 35347 , F 117, S 8, H M 635459, I/A 4 (14.08.17).

09 de Febrero de 2017
Nombramientos. Auditor: BNFIX AUDIT AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35347 , F 116, S 8, H M 635459, I/A 2 ( 2.02.17).

30 de Diciembre de 2016
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 29.11.16. Objeto social: La compra, venta, alquiler, parcelaci贸n y urbanizaci贸n de solares,errenos y fincas de cualquier naturaleza, pudiendo proceder a la edificaci贸n de los mismos y la enajenaci贸n integramente en formaparcial o en regimen de propiedad horizonal. Domicilio: C/ ALTAMIRANO 35 (MADRID). Capital: 300.000,00 Euros. Nombramientos.Consejero: RODRIGUEZ LOSADA FRANCISCO. Presidente: RODRIGUEZ LOSADA FRANCISCO. Consejero: RODRIGUEZ PUENTEIVAN FRANCISCO. Vicepresid.: RODRIGUEZ PUENTE IVAN FRANCISCO. Consejero: RODRIGUEZ PUENTE HARYAN. Secretario:RODRIGUEZ PUENTE HARYAN. Consejero: PUENTE VIDA MARIA LUISA. Cons.Del.Sol: RODRIGUEZ PUENTE IVANFRANCISCO;RODRIGUEZ PUENTE HARYAN. Datos registrales. T 35347 , F 108, S 8, H M 635459, I/A 1 (20.12.16).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n