Actos BORME de Ilbira Motor Sociedad Limitada
22 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: C Y O CONSULTORES Y AUDITORES SLP. Datos registrales. T 6542 , F 37, S 8, H SE 86838, I/A 26(14.11.22).
03 de Febrero de 2021Reelecciones. Auditor: C Y O CONSULTORES Y AUDITORES S.L.P. Datos registrales. T 6542 , F 36, S 8, H SE 86838, I/A 24(26.01.21).
28 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: BORRAS MARTIN JOSE MARIA. Datos registrales. T 6542 , F 35, S 8, H SE 86838, I/A 23(17.12.20).
14 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: BAUTISTA PEREZ RAMON MANUEL. Datos registrales. T 6542 , F 35, S 8, H SE 86838, I/A 22 (3.12.20).
28 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apoderado: BORRAS MARTIN JOSE MARIA. Datos registrales. T 6542 , F 34, S 8, H SE 86838, I/A 21(19.11.19).
21 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GONZALEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 6542 , F 33, S 8, H SE 86838, I/A 20(11.05.18).
18 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: ROCA DE TOGORES PEREZ DE GUZMAN MANUEL;ESCRIBANO IVISON JOSEMARIA;VILLAGRAN NU脩EZ JUAN BOSCO;DELGADO DE COS CHOZAS ALFREDO;GONZALO DE BUSTO FERNANDO;OSBORNEBORES EDUARDO;YBARRA OSBORNE PELAYO;ALVEAR ALMUNIA CRISTOBAL. Presidente: ROCA DE TOGORES Y PEREZ DEGUZMAN MANUEL. Vicepresid.: ESCRIBANO IVISON JOSE MARIA. Con.Delegado: ROCA DE TOGORES PEREZ DE GUZMANMANUEL. Consejero: MARTINEZ MEJIAS Y GARCIA DEL CID JOSE JOAQUIN. SecreNoConsj: MORA CARAZO JUAN CARLOS.Nombramientos. Adm. Solid.: COMERCIAL AUTOTRACTOR SA. Auditor: C Y O CONSULTORES Y AUDITORES S.L.P. Adm. Solid.:NITA SL. Modificaciones estatutarias. Refundicion total de estatutos sociales. Art铆culo de los estatutos: 27. Cierre del Ejercicio.-.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales.T 5263 , F 99, S 8, H SE 86838, I/A 18 ( 8.05.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORALES MORENO IGNACIO JAVIER;ESCRIBANO DEL CASTILLO CLARA MARIA;ZAMBRANOSANCHEZ MANUELA. Datos registrales. T 6542 , F 33, S 8, H SE 86838, I/A 19 ( 9.05.18).
22 de Febrero de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: COSTILLA PURO ANGEL. Apo.Manc.: COSTILLA PURO ANGEL;ESCRIBANO CASTILLO CLARAMARIA;ALVEAR ALMUNIA GUADALUPE. Apo.Sol.: FERRERA DE CASTRO TOMAS MANUEL. Apoderado: VARELA GONZALEZMARIA TERESA. Apo.Sol.: GONZALEZ GONZALEZ ENRIQUE. Apo.Manc.: COSTILLA PURO ANGEL;LANCHA LANCHA JOSEMARIA;ESCRIBANO CASTILLO CLARA MARIA;ALVEAR ALMUNIA GUADALUPE;MORALES MORENO IGNACIO JAVIER. Apo.Sol.:MORALES MORENO IGNACIO JAVIER;ALVEAR ALMUNIA GUADALUPE. Datos registrales. T 5263 , F 99, S 8, H SE 86838, I/A 17(14.02.18).
20 de Julio de 2015Nombramientos. Con.Delegado: ROCA DE TOGORES PEREZ DE GUZMAN MANUEL. Datos registrales. T 5263 , F 92, S 8, H SE86838, I/A 2 (26.07.10).
Nombramientos. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 5263 , F 98, S 8, H SE 86838, I/A 16 (13.07.15).
12 de Febrero de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 900.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:1.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.000.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-.Datos registrales. T 5263 , F 98, S 8, H SE 86838, I/A 15 ( 5.02.15).
07 de Julio de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: ESCRIBANO CASTILLO CLARA MARIA;MORALES MORENO IGNACIO JAVIER;ALVEAR ALMUNIAGUADALUPE. Datos registrales. T 5263 , F 97, S 8, H SE 86838, I/A 14 (26.06.14).
05 de Marzo de 2014Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: ARTICULO 3潞: Domicilio.-. Cambio de domicilio social. CTRA DE SUEMINENCIA 26 (SEVILLA). Datos registrales. T 5263 , F 97, S 8, H SE 86838, I/A 13 (24.02.14).
12 de Septiembre de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: NU脩EZ ALVAREZ ANTONIO. Apo.Manc.: NU脩EZ ALVAREZ ANTONIO. Datos registrales. T 5263 , F 97,S 8, H SE 86838, I/A 12 (29.08.13).
28 de Agosto de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 900.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo delos estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 5263 , F 96, S 8, H SE 86838, I/A 11 (19.08.13).
20 de Agosto de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: COSTILLA PURO ANGEL;LANCHA LANCHA JOSE MARIA;ESCRIBANO CASTILLO CLARAMARIA;ALVEAR ALMUNIA GUADALUPE;MORALES MORENO IGNACIO JAVIER. Datos registrales. T 5263 , F 96, S 8, H SE86838, I/A 10 ( 8.08.13).
05 de Agosto de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ GONZALEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 5263 , F 95, S 8, H SE 86838, I/A 9 (29.07.13).
12 de Diciembre de 2012Nombramientos. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 5263 , F 95, S 8, H SE 86838, I/A 8 ( 3.12.12).
22 de Febrero de 2011Nombramientos. Apoderado: VARELA GONZALEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 5263 , F 95, S 8, H SE 86838, I/A 7 (9.02.11).
26 de Enero de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: FERRERA DE CASTRO TOMAS MANUEL. Datos registrales. T 5263 , F 94, S 8, H SE 86838, I/A 6 (7.01.11).
11 de Agosto de 2010Nombramientos. Presidente: ROCA DE TOGORES Y PEREZ DE GUZMAN MANUEL. Vicepresid.: ESCRIBANO IVISON JOSEMARIA. Datos registrales. T 5263 , F 92, S 8, H SE 86838, I/A 2 (26.07.10).
Nombramientos. Apoderado: LANCHA LANCHA JOSE MARIA. Datos registrales. T 5263 , F 92, S 8, H SE 86838, I/A 3 (27.07.10).
Nombramientos. Apo.Sol.: COSTILLA PURO ANGEL;NU脩EZ ALVAREZ ANTONIO. Datos registrales. T 5263 , F 93, S 8, H SE86838, I/A 4 (28.07.10).
Nombramientos. Apo.Manc.: COSTILLA PURO ANGEL;NU脩EZ ALVAREZ ANTONIO;ESCRIBANO CASTILLO CLARAMARIA;ALVEAR ALMUNIA GUADALUPE. Otros conceptos: los administradores mancomunados actuaran dos a dos cualesquierade ellos.- Datos registrales. T 5263 , F 94, S 8, H SE 86838, I/A 5 (28.07.10).
02 de Agosto de 2010Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 30.06.10. Objeto social: La compraventa de autom贸viles, camiones y veh铆culos articulados,maquinaria comercial, industrial, agr铆cola, de servicio y de cualquier clase, sea detracci贸n mec谩nica o no, sus complementos yaccesorios, nueva y usada.- Domicilio: C/ ANTONIO DE LA PE脩A Y LOPEZ 3 (SEVILLA). Capital: 500.000,00 Euros. Declaraci贸n deunipersonalidad. Socio 煤nico: COMERCIAL AUTOTRACTOR SA. Nombramientos. Consejero: ROCA DE TOGORES PEREZ DEGUZMAN MANUEL;ESCRIBANO IVISON JOSE MARIA;VILLAGRAN NU脩EZ JUAN BOSCO;MARTINEZ MEJIAS Y GARCIA DEL CIDJOSE JOAQUIN;DELGADO DE COS CHOZAS ALFREDO;GONZALO DE BUSTO FERNANDO;OSBORNE BORESEDUARDO;YBARRA OSBORNE PELAYO;ALVEAR ALMUNIA CRISTOBAL. SecreNoConsj: MORA CARAZO JUAN CARLOS. Datosregistrales. T 5263 , F 90, S 8, H SE 86838, I/A 1 (20.07.10).