Buscador CIF Logo

Actos BORME Ilunion Cee Centro De Servicios Compartidos Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ilunion Cee Centro De Servicios Compartidos Sl

Actos BORME Ilunion Cee Centro De Servicios Compartidos Sl - B82335142

Tenemos registrados 37 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Ilunion Cee Centro De Servicios Compartidos Sl con CIF B82335142

馃敊 Perfil de Ilunion Cee Centro De Servicios Compartidos Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Ilunion Cee Centro De Servicios Compartidos Sl

08 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ RODRIGUEZ REYES;PEREZ DEL PULGAR LORITZ PATRICIA;PARRADO SANCHEZROSANA;LIMON VAZQUEZ JUAN ANTONIO;DIEGO PERI脩AN ROSA MARIA;DURO RAMOS MARIA ANGELES;RAMIREZ PUENTESONIA;BORREGO ESPARRAGO MARIA SOLEDAD;DAVILA MORENO CARMEN;GOMEZ CARRASCAL CRISTINA;CAPUCHINOCASANOVA ELISA;VIDAL SEARA ANITA;MARINAS AGUADO GEMA;VILLAGOMEZ BETANCOURT LAURA;PEREZ NIETOCARMEN;REDONDO FERNANDEZ ESTRELLA;GARCIA CABRERIZO MARIA ROSARIO;HERVAS MARTINEZ JOSE;PEREZCAYUELA ELENA;GARCIA BETANCOR MARTA ANDREA;GARCIA DEL POTRO SANDRA;ANDRES PE脩A PAULA;VENTASCURIEL SERGIO;ABAD SOTO JORGE;BARCELO BLANCO STEGER JOSE LUIS;ARNAEZ RUIZ LAURA;BASILDO ALVAREZ JUANCARLOS;PONCELA MORENO SUSANA;VASQUEZ GONZALEZ VIVIAN CAROLINA;TORANZO MEDIERO LAURAISABEL;ALMANSA RAMIREZ JORGE;DIEGO DEL CAMPO ALVAREZ;BENAVIDES MARTINEZ MARIA DEL MAR. Datosregistrales. T 33409 , F 71, S 8, H M 235913, I/A 129 (31.10.23).

28 de Julio de 2023
Ceses/Dimisiones. Representan: O脩ORO MEDRANO ALEJANDRO;INGELMO DE LA MATA JOAQUIN. Adm. Mancom.: GRUPOILUNION SL;ILUNION FACILITY SERVICES SL. Nombramientos. Representan: O脩ORO MEDRANO ALEJANDRO;INGELMO DELA MATA JOAQUIN. Adm. Mancom.: GRUPO ILUNION SL;ILUNION EMPRENDE SL. Datos registrales. T 33409 , F 70, S 8, H M235913, I/A 128 (21.07.23).

05 de Enero de 2023
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 33409 , F 70, S 8, H M 235913, I/A 127 (29.12.22).

18 de Julio de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LUQUE JAEN JUAN MANUEL. Datos registrales. T 33409 , F 69, S 8, H M 235913, I/A 126(11.07.22).

18 de Mayo de 2022
Revocaciones. Apoderado: CICUENDEZ ARELLANO DAVID. Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 125 la revocaci贸ncomo apoderado de don Alejandro O帽oro Medrano siendo lo correcto don David Cicuendez Arellano. Datos registrales. T 33409 , F69, S 8, H M 235913, I/A 125 (22.04.22).

29 de Abril de 2022
Revocaciones. Apoderado: O脩ORO MEDRANO ALEJANDRO. Datos registrales. T 33409 , F 69, S 8, H M 235913, I/A 125(22.04.22).

17 de Noviembre de 2021
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del Art铆culo 33潞 de los Estatutos Sociales.. Cambio de objeto social. La Sociedad tieneuna vocaci贸n eminentemente social que define su objeto como la consecuci贸n de la plena inclusi贸n social y laboral de las personascon discapacidad a trav茅s de la creaci贸n de empleo estable y de calidad para este colectivo de personas.. Datos registrales. T 33409, F 69, S 8, H M 235913, I/A 124 (10.11.21).

27 de Octubre de 2020
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ GONZALEZ MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 33409 , F 68, S 8, H M 235913, I/A123 (20.10.20).

24 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MEGO PEREZ ROSA. Datos registrales. T 33409 , F 67, S 8, H M 235913, I/A 122 (17.03.20).

11 de Diciembre de 2019
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 33409 , F 67, S 8, H M 235913, I/A 121 ( 2.12.19).

19 de Julio de 2019
Nombramientos. Apoderado: DE LOS RIOS VARELA DAVID CRISTIAN. Datos registrales. T 33409 , F 67, S 8, H M 235913, I/A120 (12.07.19).

12 de Junio de 2019
Nombramientos. Apoderado: MEGO PEREZ ROSA MARIA. Datos registrales. T 33409 , F 66, S 8, H M 235913, I/A 119 ( 5.06.19).

12 de Enero de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GRUPO ILUNION SL. Representan: O脩ORO MEDRANO ALEJANDRO. Nombramientos.Representan: O脩ORO MEDRANO ALEJANDRO;INGELMO DE LA MATA JOAQUIN. Adm. Mancom.: GRUPO ILUNION SL;ILUNIONFACILITY SERVICES SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradoresmancomunados. Datos registrales. T 33409 , F 63, S 8, H M 235913, I/A 116 ( 5.01.18).

Nombramientos. Apoderado: O脩ORO MEDRANO ALEJANDRO. Datos registrales. T 33409 , F 63, S 8, H M 235913, I/A 117 (5.01.18).

Nombramientos. Apoderado: INGELMO DE LA MATA JOAQUIN. Datos registrales. T 33409 , F 65, S 8, H M 235913, I/A 118 (5.01.18).

17 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: NAVARRO HIGUERA MERCEDES. Datos registrales. T 33409 , F 61, S 8, H M 235913, I/A 113(10.11.17).

Revocaciones. Apo.Sol.: BUESA GARCIA PEDRO. Nombramientos. Apoderado: BUESA GARCIA PEDRO. Datos registrales. T33409 , F 62, S 8, H M 235913, I/A 114 (10.11.17).

Nombramientos. Apoderado: DAVILA MORENO CARMEN. Datos registrales. T 33409 , F 62, S 8, H M 235913, I/A 115 (10.11.17).

01 de Agosto de 2017
Cambio de objeto social. a) La creaci贸n y desarrollo de Centros Especiales de Empleo u otras entidades que pudiesen crearse en elfuturo como forma id贸nea de promoci贸n laboral de los trabajadores discapacitados, as铆 como su direcci贸n, gesti贸n y administraci贸n. b)La direcci贸n, gesti贸n y administraci贸n de empresas o grupos. Datos registrales. T 33409 , F 61, S 8, H M 235913, I/A 112 (21.07.17).

07 de Julio de 2017
Revocaciones. Apoderado: REYES DURAN JOSE ANTONIO;NAVARRO PLANCHAT JAVIER FRANCISCO;RODRIGUEZMOHEDANO ENRIQUE FRANCISCO;MARTIN CHICO ELENA. Apo.Manc.: REYES DURAN JOSE ANTONIO;MARTINEZ GUINEALUIS MANUEL;ROMERO GALVEZ ANGEL;ESPARRAGO MOGENA JUAN. Apoderado: MORENO VERDEJO I脩IGO;FUERTESGARCIA ROSA MARIA. Apo.Manc.: REYES DURAN JOSE ANTONIO;FUERTES GARCIA ROSA MARIA;DELGADO MORANCHELPABLO;REYES DURAN JOSE ANTONIO;FUERTES GARCIA ROSA MARIA;FUERTES GARCIA ROSA MARIA. Apoderado: BUESAGARCIA PEDRO;PINEDO MOYA PEDRO ANGEL;HERRADOR ALCAIDE ANA MARIA;CESTERO RICO JUAN JOSE;PINEDO MOYAPEDRO ANGEL;BUESA GARCIA PEDRO;MORENO MARIN SUSANA. Apo.Sol.: ARELLANO GONZALEZ JORGE. Datosregistrales. T 33409 , F 60, S 8, H M 235913, I/A 110 (29.06.17).

Revocaciones. Apo.Manc.: BIDAURRAZAGA MARIJUAN NEREA. Apo.Sol.: BIDAURRAZAGA MARIJUAN NEREA.Nombramientos. Apo.Sol.: BIDAURRAZAGA MARIJUAN NEREA. Datos registrales. T 33409 , F 60, S 8, H M 235913, I/A 111(30.06.17).

22 de Marzo de 2017
Cambio de domicilio social. C/ ALBACETE NUMERO 3, EDIFICIO TORRE ILUNION (MADRID). Datos registrales. T 33409 , F 59,S 8, H M 235913, I/A 109 (13.03.17).

17 de Febrero de 2017
Nombramientos. Apoderado: PALMERO MANGADO VIRGINIA. Datos registrales. T 33409 , F 59, S 8, H M 235913, I/A 107 (9.02.17).

Nombramientos. Apoderado: CAMARENA GONZALEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 33409 , F 59, S 8, H M 235913, I/A 108 (9.02.17).

03 de Febrero de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: RODRIGUEZ BAQUERO JAVIER. Datos registrales. T 33409 , F 58, S 8, H M 235913, I/A 106(26.01.17).

24 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 33409 , F 58, S 8, H M 235913, I/A 105 (15.11.16).

12 de Septiembre de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: FLOR GONZALEZ MARIA VICTORIA;FLOR GONZALEZ MARIA VICTORIA. Nombramientos.Apo.Man.Soli: ARELLANO GONZALEZ JORGE;SUAREZ SAIZ RAQUEL;INGELMO DE LA MATA JOAQUIN;PEDROTE GARCIAFERNANDO;NAVARRO HIGUERA MERCEDES;BIDAURRAZAGA MARIJUAN NEREA;REDONDO UTRILLA JESUS. Datosregistrales. T 33409 , F 57, S 8, H M 235913, I/A 104 ( 5.09.16).

05 de Julio de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: DIAZ PANIAGUA MARIA ESTHER. Datos registrales. T 33409 , F 57, S 8, H M 235913, I/A 103(27.06.16).

31 de Marzo de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CORPORACION EMPRESARIAL ONCE SA. Representan: O脩ORO MEDRANO ALEJANDRO.Nombramientos. Adm. Unico: GRUPO ILUNION SL. Representan: O脩ORO MEDRANO ALEJANDRO. Datos registrales. T 33409 ,F 56, S 8, H M 235913, I/A 102 (21.03.16).

21 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: BUESA GARCIA PEDRO. Datos registrales. T 33409 , F 56, S 8, H M 235913, I/A 101 (14.12.15).

09 de Octubre de 2015
Nombramientos. Apoderado: ARELLANO GONZALEZ JORGE. Datos registrales. T 33409 , F 56, S 8, H M 235913, I/A 100(30.09.15).

06 de Agosto de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: PINEDO MOYA PEDRO ANGEL. Nombramientos. Apoderado: PINEDO MOYA PEDRO ANGEL. Datosregistrales. T 33409 , F 55, S 8, H M 235913, I/A 99 (30.07.15).

01 de Julio de 2015
Cambio de domicilio social. C/ ALBACETE 3 - EDIFICIO MIZAR, 4& Y 5& PLANTA. (MADRID). Datos registrales. T 33409 , F 54,S 8, H M 235913, I/A 97 (24.06.15).

Nombramientos. Apo.Sol.: BIDAURRAZAGA MARIJUAN NEREA;DEL RIO CEBRIAN PAOLA. Datos registrales. T 33409 , F 54, S8, H M 235913, I/A 98 (24.06.15).

09 de Junio de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: O脩ORO MEDRANO ALEJANDRO;MARTINEZ DONOSO JOSE LUIS. Datos registrales. T 33409 , F 53, S8, H M 235913, I/A 94 (29.05.15).

Nombramientos. Apo.Manc.: BIDAURRAZAGA MARIJUAN NEREA. Apo.Sol.: BIDAURRAZAGA MARIJUAN NEREA. Datosregistrales. T 33409 , F 53, S 8, H M 235913, I/A 95 (29.05.15).

Nombramientos. Apo.Manc.: ARELLANO GONZALEZ JORGE. Apo.Sol.: ARELLANO GONZALEZ JORGE. Datos registrales. T33409 , F 54, S 8, H M 235913, I/A 96 (29.05.15).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n