Actos BORME de Image Profile Sl
15 de Enero de 2018Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ DIEZ AGUSTIN. Datos registrales. T 26365 , F 2, S 8, H M 11662, I/A 11 ( 5.01.18).
22 de Julio de 2011Cambio de domicilio social. C/ LOPEZ SANTOS 2 (ROZAS DE MADRID (LAS)). Datos registrales. T 26365 , F 2, S 8, H M 11662,I/A 10 (12.07.11).
21 de Julio de 2011Ceses/Dimisiones. Representan: SANCHEZ DEL REAL VICTOR. Nombramientos. Representan: ALLOZA MOYA JESUS. Datosregistrales. T 26365 , F 2, S 8, H M 11662, I/A 9 (11.07.11).
02 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: PASCUAL GONZALEZ-BABE ENRIQUE. Datos registrales. T 26365 , F 1, S 8, H M 11662, I/A 8(22.01.09).
30 de Enero de 2009Ceses/Dimisiones. Presidente: ABAD GUIJARRO DANIEL. Consejero: ESTEBAN OREA ELVIRA;ABAD GUIJARRO DANIEL.Con.Delegado: ABAD GUIJARRO DANIEL. Consejero: ABAD ESTEBAN AARON. SecreNoConsj: PRIETO FOLGUEIRA CARLOS.Nombramientos. Adm. Unico: BLOGS BUSINESS SL. Representan: SANCHEZ DEL REAL VICTOR. Modificaciones estatutarias.Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico.MODIFICADO EL ARTICULO 17 DE LOSESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 26365 , F 1, S 8, H M 11662, I/A 7 (20.01.09).