Actos BORME de Imasa Ingenieria Y Proyectos Sa
20 de Diciembre de 2023Revocaciones. SecreNoConsj: ZAPICO GARCIA ANA MARIA. VsecrNoConsj: MARTINEZ RODRIGUEZ RUBEN. Nombramientos.SecreNoConsj: MARTINEZ RODRIGUEZ RUBEN. Datos registrales. T 4237 , F 92, S 8, H AS 4729, I/A 183 (14.12.23).
25 de Octubre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: DE LAS HERAS GARCIA IZQUIERDO PABLO MANUEL. Apo.Manc.: DE LAS HERAS GARCIAIZQUIERDO PABLO MANUEL;MARTINEZ RODRIGUEZ RUBEN. Datos registrales. T 4237 , F 91, S 8, H AS 4729, I/A 181(17.10.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ ESPINAR JOSE IGNACIO;REDONDO CANAL FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T4237 , F 91, S 8, H AS 4729, I/A 182 (17.10.23).
08 de Mayo de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: HERRERO BELON JOSE MIGUEL. Apo.Manc.: HERRERO BELON JOSE MIGUEL;GARCIA GARCIAJAVIER. Datos registrales. T 4237 , F 90, S 8, H AS 4729, I/A 180 (27.04.23).
02 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4237 , F 90, S 8, H AS 4729, I/A 178(24.10.22).
Reelecciones. Aud.C.Con.: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4237 , F 90, S 8, H AS 4729, I/A179 (24.10.22).
03 de Octubre de 2022Modificaciones estatutarias. 10. Acciones. Copropiedad, usufructo y prenda.. 1. Transmisi贸n de Acciones.. 28. Aplicaci贸n delresultado.. Datos registrales. T 4237 , F 89, S 8, H AS 4729, I/A 177 (26.09.22).
04 de Agosto de 2022Nombramientos. VsecrNoConsj: MARTINEZ RODRIGUEZ RUBEN. Datos registrales. T 4237 , F 89, S 8, H AS 4729, I/A 176(27.07.22).
07 de Enero de 2022Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 1. Domicilio social.-. Otros conceptos: Adici贸n a los Estatutos Sociales delos Art铆culos 4 bis, 14 bis, 15 bis primero a cuarto y 22 bis primero a sexto sobre celebraci贸n de Juntas y Consejeros telem谩ticos.Cambio de domicilio social. C/ FAYA, 10 - PARQUE TECNOLOGICO DE ASTURIAS. CAY (LLANERA). Datos registrales. T 4237, F 87, S 8, H AS 4729, I/A 175 (27.12.21).
15 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4237 , F 87, S 8, H AS 4729, I/A 173
Reelecciones. Aud.C.Con.: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4237 , F 87, S 8, H AS 4729, I/A174 ( 3.12.21).
28 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MARTINEZ ZAPICO SATURNINO. Nombramientos. Con.Delegado: MARTINEZ ZAPICOSATURNINO. Reelecciones. Consejero: MARTINEZ ZAPICO SATURNINO;CASADO MARTINEZ TOMAS;BUZNEGO SUAREZ LUISABELARDO;MARTINEZ ALVAREZ JUAN MANUEL. Presidente: MARTINEZ ZAPICO SATURNINO. Consejero: GARCIA GONZALEZAMANCIO. SecreNoConsj: ZAPICO GARCIA ANA MARIA. Datos registrales. T 4237 , F 86, S 8, H AS 4729, I/A 172 (21.06.21).
26 de Febrero de 2021Modificaciones estatutarias. 19. Otros.- Retribuci贸n. Datos registrales. T 4237 , F 86, S 8, H AS 4729, I/A 171 (19.02.21).
18 de Enero de 2021Reelecciones. Auditor: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4237 , F 86, S 8, H AS 4729, I/A 169( 8.01.21).
Reelecciones. Aud.C.Con.: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4237 , F 86, S 8, H AS 4729, I/A170 ( 8.01.21).
16 de Septiembre de 2020Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ESPINAR JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 4237 , F 85, S 8, H AS 4729, I/A 168 (7.09.20).
20 de Mayo de 2020Nombramientos. Apoderado: BUZNEGO SUAREZ LUIS ABELARDO. Datos registrales. T 4237 , F 84, S 8, H AS 4729, I/A 167(11.05.20).
05 de Febrero de 2020Revocaciones. Apoderado: REDONDO BLAZQUEZ FRANCISCO JAVIER;REDONDO BLAZQUEZ FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.:FUENTES GONZALEZ ALFREDO DEMETRIO. Apoderado: REDONDO CANAL FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: MARTINEZ DIAZALBERTO. Apo.Sol.: FUENTES GONZALEZ ALFREDO DEMETRIO. Apo.Manc.: MARTINEZ DIAZ ALBERTO. Apo.Sol.: MARTINEZDIAZ ALBERTO. Apo.Manc.: LAFUENTE ALVAREZ JESUS JOSE. Apoderado: CANAL ANTU脩A OVIDIO ADOLFO;MARTINEZZAPICO SATURNINO. Apo.Manc.: REGO FERNANDEZ SECUNDINO. Apo.Sol.: GARCIA SUAREZ JOSE IGNACIO. Apo.Manc.:GARCIA SUAREZ JOSE IGNACIO. Apoderado: MARTINEZ ESPINAR JOSE IGNACIO. Apo.Sol.: GOMEZ GARCIA FRANCISCOJAVIER. Apo.Manc.: GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 4237 , F 84, S 8, H AS 4729, I/A 166 (28.01.20).
26 de Diciembre de 2019Reelecciones. Auditor: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4237 , F 83, S 8, H AS 4729, I/A 164(17.12.19).
Reelecciones. Aud.C.Con.: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4237 , F 83, S 8, H AS 4729, I/A165 (17.12.19).
27 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ PEREZ JOSE ANTONIO. Apo.Manc.: PEREZ PEREZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 4237, F 82, S 8, H AS 4729, I/A 162 (19.11.19).
Nombramientos. Apoderado: REDONDO CANAL FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 4237 , F 82, S 8, H AS 4729, I/A 163(19.11.19).
24 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA CUENCA MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: GARCIA CUENCA MIGUEL ANGEL;MARTINEZESPINAR JOSE IGNACIO;REDONDO CANAL FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 4237 , F 81, S 8, H AS 4729, I/A 161(12.04.19).
02 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER;GARCIAGARCIA JAVIER. Datos registrales. T 4237 , F 81, S 8, H AS 4729, I/A 160 (25.03.19).
19 de Febrero de 2019Nombramientos. Apoderado: GARCIA CUENCA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 4237 , F 80, S 8, H AS 4729, I/A 159 (8.02.19).
06 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ ESPINAR JOSE IGNACIO. Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ESPINAR JOSEIGNACIO. Datos registrales. T 4237 , F 79, S 8, H AS 4729, I/A 156 (29.10.18).
Reelecciones. Auditor: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4237 , F 80, S 8, H AS 4729, I/A 157(29.10.18).
Reelecciones. Aud.C.Con.: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4237 , F 80, S 8, H AS 4729, I/A158 (29.10.18).
23 de Octubre de 2018Nombramientos. Apoderado: GARCIA SUAREZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 4237 , F 79, S 8, H AS 4729, I/A 155(16.10.18).
11 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: CASADO MARTINEZ TOMAS. Datos registrales. T 4237 , F 78, S 8, H AS 4729, I/A 154 ( 4.07.18).
10 de Julio de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER;LAFUENTEALVAREZ JESUS JOSE. Datos registrales. T 4237 , F 77, S 8, H AS 4729, I/A 153 ( 2.07.18).
01 de Junio de 2018Revocaciones. Apoderado: CASADO MARTINEZ TOMAS. Datos registrales. T 4237 , F 77, S 8, H AS 4729, I/A 152 (25.05.18).
04 de Abril de 2018Nombramientos. Apoderado: REDONDO BLAZQUEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 4237 , F 77, S 8, H AS 4729, I/A151 (23.03.18).
21 de Marzo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: REDONDO CANAL FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: REDONDO CANAL FRANCISCOJAVIER;DUARTE MARION JOSE LUIS. Datos registrales. T 4237 , F 76, S 8, H AS 4729, I/A 150 (13.03.18).
07 de Febrero de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: RUBIO GARCIA FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: RUBIO GARCIA FRANCISCO JAVIER;DUARTEMARION JOSE LUIS. Datos registrales. T 4237 , F 76, S 8, H AS 4729, I/A 149 (30.01.18).
20 de Diciembre de 2017Reelecciones. Auditor: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4237 , F 76, S 8, H AS 4729, I/A 147(12.12.17).
Reelecciones. Aud.C.Con.: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4237 , F 76, S 8, H AS 4729, I/A148 (12.12.17).
09 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ PEREZ JOSE ANTONIO. Apo.Manc.: PEREZ PEREZ JOSE ANTONIO;MARTINEZ DIAZALBERTO. Datos registrales. T 3279 , F 224, S 8, H AS 4729, I/A 145 ( 1.03.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER;LAFUENTEALVAREZ JESUS JOSE. Datos registrales. T 3279 , F 225, S 8, H AS 4729, I/A 146 ( 1.03.17).
15 de Febrero de 2017Revocaciones. Apoderado: MIRANDA GUTIERREZ JULIO CESAR. Datos registrales. T 3279 , F 224, S 8, H AS 4729, I/A 144 (7.02.17).
30 de Enero de 2017Reelecciones. Aud.C.Con.: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3279 , F 224, S 8, H AS 4729,I/A 143 (19.01.17).
28 de Noviembre de 2016Reelecciones. Auditor: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3279 , F 224, S 8, H AS 4729, I/A142 (17.11.16).
02 de Junio de 2016Revocaciones. Presidente: CASADO MARTINEZ TOMAS. Cons.Del.Sol: MARTINEZ ZAPICO SATURNINO. Vicepresid.: MARTINEZZAPICO SATURNINO. Nombramientos. Presidente: MARTINEZ ZAPICO SATURNINO. Con.Delegado: MARTINEZ ZAPICOSATURNINO. Reelecciones. Consejero: BUZNEGO SUAREZ LUIS ABELARDO;CASADO MARTINEZ TOMAS;MARTINEZ ZAPICOSATURNINO;MARTINEZ ALVAREZ JUAN MANUEL;GARCIA GONZALEZ AMANCIO. SecreNoConsj: ZAPICO GARCIA ANA MARIA.Datos registrales. T 3279 , F 224, S 8, H AS 4729, I/A 141 (25.05.16).
04 de Enero de 2016Reelecciones. Auditor: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3279 , F 223, S 8, H AS 4729, I/A140 (18.12.15).
16 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3279 , F 223, S 8, H AS 4729, I/A139 ( 5.12.14).
19 de Septiembre de 2014Modificaciones estatutarias. 15. Funcionamiento Junta Gral.-. Datos registrales. T 3279 , F 223, S 8, H AS 4729, I/A 138(11.09.14).
01 de Septiembre de 2014Modificaciones estatutarias. 3. Otros.-. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.imasa.com.Datos registrales. T 3279 , F 222, S 8, H AS 4729, I/A 137 (21.08.14).
03 de Abril de 2014Modificaciones estatutarias. 10. Acciones/Participaciones.-. 11. Acciones/Participaciones.-. 19. Administraci贸n y Representacion.-.Datos registrales. T 3279 , F 221, S 8, H AS 4729, I/A 136 (27.03.14).
27 de Marzo de 2014Nombramientos. Aud.C.Con.: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3279 , F 220, S 8, H AS 4729,I/A 135 (19.03.14).
21 de Marzo de 2014Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ ALVAREZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 3279 , F 220, S 8, H AS 4729, I/A 134(13.03.14).
07 de Marzo de 2014Revocaciones. Apoderado: VILA RIUDAVETS CARLOS. Datos registrales. T 3279 , F 219, S 8, H AS 4729, I/A 133 (25.02.14).
02 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apoderado: REDONDO CANAL FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3279 , F 219, S 8, H AS 4729, I/A 132(25.11.13).
13 de Noviembre de 2013Reelecciones. Auditor: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3279 , F 219, S 8, H AS 4729, I/A131 ( 5.11.13).
18 de Septiembre de 2013Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: CASADO MARTINEZ TOMAS. Datos registrales. T 3279 , F 219, S 8, H AS 4729, I/A 130(10.09.13).
24 de Abril de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO GARCIA FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: RUBIO GARCIA FRANCISCO JAVIER;DUARTEMARION JOSE LUIS. Datos registrales. T 3279 , F 218, S 8, H AS 4729, I/A 129 (16.04.13).
22 de Febrero de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: MENENDEZ SUAREZ NICANOR. Apoderado: MENENDEZ SUAREZ NICANOR. Apo.Manc.: MENENDEZSUAREZ NICANOR;DUARTE MARION JOSE LUIS. Datos registrales. T 3279 , F 218, S 8, H AS 4729, I/A 128 (14.02.13).
27 de Diciembre de 2012Revocaciones. Apoderado: BARROSA CUERVO JOSE;IGLESIAS NAYA PEDRO. Apo.Sol.: ALONSO VEGA AMADORCARLOS;CABAL GARCIA LUIS MIGUEL;ALONSO VEGA AMADOR CARLOS;CABAL GARCIA LUIS MIGUEL. Apoderado:MARTINEZ BRAVO SARA;FERNANDEZ ARANGO ANGEL;FERNANDEZ ARANGO ANGEL;GARCIA GONZALEZ AMANCIO.Apo.Manc.: CASADO MARTINEZ ARCADIO. Apoderado: GARCIA GONZALEZ EUTIMIO. Apo.Manc.: GARCIA GARCIAFAUSTINO;MARTINEZ ESPINAR JAVIER. Apoderado: VAZQUEZ PALACIOS RODOLFO ALBERTO. Apo.Sol.: REDONDO CANALFRANCISCO JAVIER;GARCIA GARCIA FAUSTINO. Apo.Manc.: REDONDO CANAL FRANCISCO JAVIER;GARCIA GARCIAFAUSTINO. Apoderado: MARTINEZ ESPINAR JAVIER. Datos registrales. T 3279 , F 218, S 8, H AS 4729, I/A 127 (18.12.12).
03 de Diciembre de 2012Reelecciones. Auditor: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3279 , F 218, S 8, H AS 4729, I/A126 (21.11.12).
16 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ESPINAR JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 3279 , F 217, S 8, H AS 4729, I/A 125 (3.05.12).
14 de Marzo de 2012Nombramientos. Apoderado: VILA RIUDAVETS CARLOS. Datos registrales. T 3279 , F 216, S 8, H AS 4729, I/A 124 ( 5.03.12).
17 de Febrero de 2012Revocaciones. Apo.Manc.: FUENTES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.: FUENTES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER.Datos registrales. T 3279 , F 216, S 8, H AS 4729, I/A 123 ( 6.02.12).
01 de Diciembre de 2011Reelecciones. Auditor: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3279 , F 216, S 8, H AS 4729, I/A122 (21.11.11).
11 de Agosto de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 4.286.520,00 Euros. Desembolsado: 4.286.520,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.715.360,00 Euros.Resultante Desembolsado: 5.715.360,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: ARTICULO 4.- El Capitalsocial, integrado por las aportaciones de los socios consistentes en bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoraci贸necon贸mica, y que constituye limite de responsabilidad respecto a los socios, en los t茅rminos previstos por la Ley. Datos registrales. T3279 , F 215, S 8, H AS 4729, I/A 121 ( 1.08.11).
11 de Julio de 2011Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: MARTINEZ ZAPICO SATURNINO;CASADO MARTINEZ TOMAS. Nombramientos. Cons.Del.Sol:CASADO MARTINEZ TOMAS;MARTINEZ ZAPICO SATURNINO. Reelecciones. Secretario: ZAPICO GARCIA ANA MARIA.
04 de Julio de 2011Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 198,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.428.840,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 4. Capital.-. Datos registrales. T 3279 , F 214, S 8, H AS 4729, I/A 119 (22.06.11).
24 de Mayo de 2011Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ESPINAR JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 3279 , F 214, S 8, H AS 4729, I/A 118(12.05.11).
18 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apoderado: BUZNEGO SUAREZ LUIS ABELARDO. Datos registrales. T 3279 , F 213, S 8, H AS 4729, I/A 117 (8.11.10).
04 de Noviembre de 2010Reelecciones. Auditor: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3279 , F 213, S 8, H AS 4729, I/A116 (22.10.10).
24 de Febrero de 2010Nombramientos. Apoderado: REDONDO CANAL FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3279 , F 213, S 8, H AS 4729, I/A 115(12.02.10).
02 de Noviembre de 2009Reelecciones. Auditor: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3279 , F 213, S 8, H AS 4729, I/A114 (22.10.09).
19 de Enero de 2009Reelecciones. Auditor: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3279 , F 211, S 8, H AS 4729, I/A112 (30.12.08).