Buscador CIF Logo

Actos BORME Imasa Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Imasa Sa

Actos BORME Imasa Sa - A28036333

Tenemos registrados 5 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Imasa Sa con CIF A28036333

🔙 Perfil de Imasa Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Imasa Sa

01 de Junio de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: MANCHADO MIGUEL AGUSTIN PEDRO;MANCHADO JIMENEZ MIGUEL ENRIQUE;MIGUELSANCHEZ MARIA DOLORES;JIMENEZ HUMANES DOLORES. Presidente: MANCHADO MIGUEL AGUSTIN PEDRO. Secretario:MANCHADO JIMENEZ MIGUEL ENRIQUE. Cons.Del.Sol: MANCHADO MIGUEL AGUSTIN PEDRO;MANCHADO JIMENEZ MIGUELENRIQUE. Nombramientos. Adm. Unico: MANCHADO MIGUEL AGUSTIN PEDRO. Modificaciones estatutarias. Modificación delos artículos 15º, 16º, 17º, 18º, 19º y 23º de los Estatutos Sociales y derogación de los artículos 20º, 21º, 22º y 24º. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datos registrales. T 3026 , F 97, S 8, H M51800, I/A 25 (25.05.22).

18 de Julio de 2016
Nombramientos. Cons.Del.Sol: MANCHADO MIGUEL AGUSTIN PEDRO;MANCHADO JIMENEZ MIGUEL ENRIQUE.Reelecciones. Consejero: MANCHADO MIGUEL AGUSTIN PEDRO;MANCHADO JIMENEZ MIGUEL ENRIQUE;MIGUEL SANCHEZMARIA DOLORES;JIMENEZ HUMANES DOLORES. Presidente: MANCHADO MIGUEL AGUSTIN PEDRO. Secretario: MANCHADOJIMENEZ MIGUEL ENRIQUE. Modificaciones estatutarias. 17. Organización de la administración de la sociedad.- Duración delcargo.. Datos registrales. T 3026 , F 96, S 8, H M 51800, I/A 24 ( 8.07.16).

19 de Agosto de 2014
Cambio de domicilio social. CMNO DE LA GALEANA S/N (ARGANDA DEL REY). Datos registrales. T 3026 , F 95, S 8, H M51800, I/A 23 ( 8.08.14).

10 de Abril de 2012
Reducción de capital. Importe reducción: 179.892,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.108,00 Euros. Datos registrales. T 3026 , F 95,S 8, H M 51800, I/A 22 (27.03.12).

21 de Mayo de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: MANCHADO ALCARAZ AGUSTIN;MANCHADO ORGAZ ENRIQUE;MIGUEL SANCHEZ MARIADOLORES;JIMENEZ HUMANES DOLORES. Secretario: MANCHADO ORGAZ ENRIQUE. Presidente: MANCHADO ALCARAZAGUSTIN. Nombramientos. Consejero: MANCHADO MIGUEL AGUSTIN PEDRO;MANCHADO JIMENEZ MIGUELENRIQUE;MIGUEL SANCHEZ MARIA DOLORES;JIMENEZ HUMANES DOLORES. Presidente: MANCHADO MIGUEL AGUSTINPEDRO. Secretario: MANCHADO JIMENEZ MIGUEL ENRIQUE. Datos registrales. T 3026 , F 95, S 8, H M 51800, I/A 21 ( 7.05.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información