Actos BORME de Imbert Management Consulting Solutions Sl
18 de Abril de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: DE LA ENCINA PASCUA MONICA;CAMINO BARREIRA PABLO. Datos registrales. T 28715 , F 139, S8, H M 309344, I/A 26 (11.04.23).
02 de Febrero de 2023Nombramientos. Apoderado: LOBO MARTINEZ JUAN MANUEL;PLAZA SIMON RAUL. Datos registrales. T 28715 , F 139, S 8, HM 309344, I/A 25 (26.01.23).
05 de Agosto de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.502,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.502,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:1.502,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.004,00 Euros. Datos registrales. T 28715 , F 138, S 8, H M 309344, I/A 24 (29.07.22).
07 de Junio de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN MU脩OZ MARTA;DE LA ENCINA PASCUA MONICA;CAMINO BARREIRA PABLO. Datosregistrales. T 28715 , F 138, S 8, H M 309344, I/A 23 (31.05.22).
06 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: MARTIN MU脩OZ MARTA. Datos registrales. T 28715 , F 136, S 8, H M 309344, I/A 21 (28.04.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: DE LA ENCINA PASCUA MONICA;CAMINO BARREIRA PABLO. Datos registrales. T 28715 , F 137, S8, H M 309344, I/A 22 (28.04.22).
14 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: INTEGRACION DE TECNICAS DE GESTION AUDITORES SLP. Datos registrales. T 28715 , F 136, S 8, HM 309344, I/A 20 ( 3.12.21).
02 de Octubre de 2019Reelecciones. Auditor: INTEGRACION DE TECNICAS DE GESTION AUDITORES SLP. Datos registrales. T 28715 , F 136, S 8, HM 309344, I/A 19 (25.09.19).
24 de Enero de 2019Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: A3DATA INGENIERIA SL. Datos registrales. T 28715 , F 135, S 8, H M 309344, I/A18 (17.01.19).
13 de Septiembre de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.004,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.004,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:1.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.004,00 Euros. Datos registrales. T 28715 , F 134, S 8, H M 309344, I/A 17 ( 6.09.18).
22 de Septiembre de 2017Reelecciones. Auditor: INTEGRACION DE TECNICAS DE GESTION AUDITORES SLP. Datos registrales. T 28715 , F 134, S 8, HM 309344, I/A 16 (14.09.17).
27 de Mayo de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GARCIA PUERTAS JOSE FERMIN;GIL ORTEGA PEDRO. Datos registrales. T 28715 , F 134, S 8,H M 309344, I/A 15 (19.05.16).
25 de Enero de 2016Reelecciones. Auditor: INTEGRACION DE TECNICAS DE GESTION AUDITORES SLP. Datos registrales. T 28715 , F 134, S 8, HM 309344, I/A 14 (18.01.16).
02 de Noviembre de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 740,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.008,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culode los estatutos: ARTICULO 5.- CAPITAL. Datos registrales. T 28715 , F 133, S 8, H M 309344, I/A 13 (26.10.15).
26 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: MARIA ARRIBAS DAVID;LOPEZ LOPEZ JOSE CARLOS. Datos registrales. T 28715 , F 133, S 8, HM 309344, I/A 10 (17.06.14).
Ceses/Dimisiones. Consejero: IMBERT HERVE ANDRE PAUL EMMANUEL. Presidente: IMBERT HERVE ANDRE PAULEMMANUEL. Consejero: GARCIA PUERTAS JOSE FERMIN. Secretario: GARCIA PUERTAS JOSE FERMIN. Consejero:FERNANDEZ MARTINEZ LUIS;GIL ORTEGA PEDRO. Nombramientos. Adm. Solid.: GARCIA PUERTAS JOSE FERMIN;GILORTEGA PEDRO;FERNANDEZ MARTINEZ LUIS;IMBERT HERVE ANDRE PAUL EMMANUEL. Modificaciones estatutarias.Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 28715 , F 133, S8, H M 309344, I/A 11 (17.06.14).
Revocaciones. Apoderado: GARCIA PUERTAS JOSE FERMIN;GIL ORTEGA PEDRO;FERNANDEZ MARTINEZ LUIS;IMBERTHERVE-ANDRE-PAUL-EMMANUEL;LOPEZ LOPEZ JOSE CARLOS;MARIA ARRIBAS DAVID. Datos registrales. T 28715 , F 133, S8, H M 309344, I/A 12 (17.06.14).
15 de Enero de 2013Reelecciones. Auditor: INTEGRACION DE TECNICAS DE GESTION AUDITORES SLP. Datos registrales. T 28715 , F 132, S 8, HM 309344, I/A 9 ( 4.01.13).
06 de Octubre de 2011Nombramientos. Apoderado: GARCIA PUERTAS JOSE FERMIN;GIL ORTEGA PEDRO;FERNANDEZ MARTINEZ LUIS;IMBERTHERVE-ANDRE-PAUL-EMMANUEL;LOPEZ LOPEZ JOSE CARLOS;MARIA ARRIBAS DAVID. Datos registrales. T 28715 , F 130, S8, H M 309344, I/A 8 (23.09.11).
01 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: IMBERT HERVE-ANDRE-PAUL-EMMANUEL;FERNANDEZ MARTINEZ LUIS;GARCIA PUERTASJOSE FERMIN;GIL ORTEGA PEDRO. Nombramientos. Consejero: IMBERT HERVE ANDRE PAUL EMMANUEL. Presidente:IMBERT HERVE ANDRE PAUL EMMANUEL. Consejero: GARCIA PUERTAS JOSE FERMIN. Secretario: GARCIA PUERTAS JOSEFERMIN. Consejero: FERNANDEZ MARTINEZ LUIS;GIL ORTEGA PEDRO;MARIA ARRIBAS DAVID;LOPEZ LOPEZ JOSE CARLOS.Ampliaci贸n de capital. Capital: 740,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.748,00 Euros. Modificaciones estatutarias. - Establecimientode prestaciones accesorias para los socios. Inclusi贸n del art铆culo 7潞 en los Estatutos Sociales..- Supresi贸n del art铆culo 13潞 ymodificaci贸n de los art铆culos 21潞, 22潞 y 23潞 de los Estatutos Sociales.Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidariosa Consejo de administraci贸n.-- Refundici贸n de todos los Estatutos Sociales. Cambio de domicilio social. AVDA SUR DELAEROPUERTO DE BARAJAS 16 - CENTRO EMP (MADRID). Cambio de objeto social. Realizaci贸n de consultor铆as de todasclases, a personas f铆sicas o jur铆dicas, por cuenta propia o por encargo de terceros. comercializaci贸n y promoci贸n de t茅cnicas para elmejor aprovechamiento de la gesti贸n, planificaci贸n y explotaci贸n de los recursos humanos, industriales, comerciales e inform谩tico.Datos registrales. T 17914 , F 206, S 8, H M 309344, I/A 7 (23.08.11).
17 de Febrero de 2010Cambio de domicilio social. C/ CA脩ADA REAL DE MERINAS 25 - CENTRO EMPRESARIAL (MADRID). Datos registrales. T17914 , F 206, S 8, H M 309344, I/A 6 ( 3.02.10).
01 de Febrero de 2010Nombramientos. Auditor: INTEGRACION DE TECNICAS DE GESTION AUDITORES SLP. Datos registrales. T 17914 , F 206, S 8,H M 309344, I/A 5 (20.01.10).