Buscador CIF Logo

Actos BORME Imerys Talc Spain Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Imerys Talc Spain Sa

Actos BORME Imerys Talc Spain Sa - A28003044

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Malaga para Imerys Talc Spain Sa con CIF A28003044

馃敊 Perfil de Imerys Talc Spain Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Malaga

Actos BORME de Imerys Talc Spain Sa

05 de Abril de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: AGUIAR RAMOS ALFONSO;LANCHAS TRUJILLO CARLOS GABRIEL;RODRIGUEZ MORENOJOSE. Presidente: RODRIGUEZ MORENO JOSE. Dir. General: DOMINGUEZ DIEZ JOSE-MANUEL-DANIEL. SecreNoConsj: ANDINOLOPEZ JUAN ANTONIO. VsecrNoConsj: ANDINO VILLASANTE JUAN RAMON. Revocaciones. Apo.Sol.: GIMENO LOPEZ-DORIGA GERMAN;CALLERI DI SALA Y CACHERANO DI BRICHERASIO EDOARDO. Apoderado: GAUGLER FRANCOIS.Apo.Man.Soli: AGUIAR RAMOS ALFONSO;DELAMARE MARC THIERRY CLAUDE;LANCHAS TRUJILLO CARLOSGABRIEL;SANCHEZ MARTINEZ VICTOR. Apo.Manc.: AGUIAR RAMOS ALFONSO;LANCHAS TRUJILLO CARLOSGABRIEL;SANCHEZ MARTINEZ VICTOR;DELAMARE MARC THIERRY CLAUDE. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ MORENO JOSE.Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 5890, L 4797, F 114, S 8, H MA111765, I/A 25 (24.03.21).

07 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. Secretario: ROCA VIVAS DANIEL. L. Asesor: ROCA VIVAS DANIEL. Nombramientos. SecreNoConsj: ANDINOLOPEZ JUAN ANTONIO. VsecrNoConsj: ANDINO VILLASANTE JUAN RAMON. Datos registrales. T 5890, L 4797, F 114, S 8, HMA111765, I/A 24 (29.09.20).

05 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: PICARD EMMANUELLE MARIE ISABELLE. Presidente: PICARD EMMANUELLE MARIE ISABELLE.Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ MORENO JOSE. Presidente: RODRIGUEZ MORENO JOSE. Datos registrales. T 5337,L 4244, F 69, S 8, H MA111765, I/A 22 (27.11.19).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: PICARD EMMANUELLE MARIE ISABELLE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ MORENOJOSE. Datos registrales. T 5337, L 4244, F 70, S 8, H MA111765, I/A 23 (27.11.19).

07 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: CALMES RALPH PIERRE WILLY. Presidente: CALMES RALPH PIERRE WILLY. Nombramientos.Consejero: PICARD EMMANUELLE MARIE ISABELLE. Presidente: PICARD EMMANUELLE MARIE ISABELLE. Datos registrales. T5337, L 4244, F 67, S 8, H MA111765, I/A 19 (28.01.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: PICARD EMMANUELLE MARIE ISABELLE;SANCHEZ MARTINEZ VICTOR. Apo.Manc.: AGUIARRAMOS ALFONSO;LANCHAS TRUJILLO CARLOS GABRIEL;SANCHEZ MARTINEZ VICTOR;DELAMARE MARC THIERRYCLAUDE. Datos registrales. T 5337, L 4244, F 68, S 8, H MA111765, I/A 20 (28.01.19).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: TRUJILLO SOLNA JORDI;CALMES RALPH PIERRE WILLY. Datos registrales. T 5337, L 4244, F 69,S 8, H MA111765, I/A 21 (28.01.19).

01 de Febrero de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: KORICHI KARIMA. Nombramientos. Consejero: LANCHAS TRUJILLO CARLOS GABRIEL. Datosregistrales. T 5337, L 4244, F 67, S 8, H MA111765, I/A 17 (23.01.18).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: KORICHI KARIMA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: LANCHAS TRUJILLO CARLOS GABRIEL.Datos registrales. T 5337, L 4244, F 67, S 8, H MA111765, I/A 18 (23.01.18).

21 de Diciembre de 2016
Revocaciones. Apo.Sol.: DOMINGUEZ DIEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 5337, L 4244, F 66, S 8, H MA111765, I/A 16(13.12.16).

18 de Febrero de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DELAMARE MARC THIERRY CLAUDE. Datos registrales. T 5337, L 4244, F 66, S 8, HMA111765, I/A 15 ( 5.02.16).

13 de Noviembre de 2015
Revocaciones. Apoderado: WANG SHUMING;ZULAICA ALFONSO GUILLERMO;AUBRY DIDIER ALEXANDRE ROBERT;AGUIARRAMOS ALFONSO;KAINER ANDREA. Nombramientos. Presidente: CALMES RALPH PIERRE WILLY. Apo.Man.Soli: TRUJILLOSOLNA JORDI;CALMES RALPH PIERRE WILLY;KORICHI KARIMA;AGUIAR RAMOS ALFONSO. Datos registrales. T 5337, L 4244,F 66, S 8, H MA111765, I/A 14 (29.10.15).

10 de Noviembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: WANG SHUMIN;AUBRY DIDIER ALEXANDRE ROBERT;ZULAICA ALFONSO GUILLERMO.Presidente: ZULAICA ALFONSO GUILLERMO. Nombramientos. Consejero: CALMES RALPH PIERRE WILLY;KORICHIKARIMA;AGUIAR RAMOS ALFONSO. Datos registrales. T 5337, L 4244, F 65, S 8, H MA111765, I/A 13 (29.10.15).

10 de Febrero de 2015
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: IMERYS SOUTH EUROPE SA. Datos registrales. T 5337, L 4244, F65, S 8, H MA111765, I/A 12 (29.01.15).

14 de Noviembre de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: DOMINGUEZ DIEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 5337, L 4244, F 65, S 8, H MA111765, I/A 10 (5.11.14).

Revocaciones. Apoderado: GILHARDI FREDERIQUE ANNE. Nombramientos. Apoderado: KAINER ANDREA. Datos registrales.T 5337, L 4244, F 65, S 8, H MA111765, I/A 11 ( 5.11.14).

27 de Junio de 2014
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ACCIOLY MENEZES FERNANDO AUGUSTO;DOMINGUEZ DIEZ JOSE MANUEL;WANG SHUMIN.Apoderado: GILHARDI FREDERIQUE ANNE;AGUIAR RAMOS ALFONSO. Nombramientos. Apoderado: WANGSHUMING;ZULAICA ALFONSO GUILLERMO;AUBRY DIDIER ALEXANDRE ROBERT;GILHARDI FREDERIQUE ANNE;AGUIARRAMOS ALFONSO. Datos registrales. T 4958, L 3865, F 70, S 8, H MA111765, I/A 7 (18.06.14).

Nombramientos. Apoderado: GAUGLER FRANCOIS. Datos registrales. T 4958, L 3865, F 71, S 8, H MA111765, I/A 8 (18.06.14).

31 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: ACCIOLY MENEZES FERNANDO AUGUSTO. Presidente: ACCIOLY MENEZES FERNANDOAUGUSTO. Nombramientos. Consejero: ZULAICA ALFONSO GUILLERMO. Presidente: ZULAICA ALFONSO GUILLERMO. Datosregistrales. T 4958, L 3865, F 70, S 8, H MA111765, I/A 6 (23.10.13).

03 de Abril de 2013
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: IMERYS TALC EUROPE SAS. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:1.500.000,00 Euros. Desembolsado: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.070.000,00 Euros. Resultante Desembolsado:2.070.000,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.003.760,00 Euros. Resultante Suscrito: 66.240,00 Euros. Datosregistrales. T 4958, L 3865, F 69, S 8, H MA111765, I/A 5 (19.03.13).

08 de Febrero de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ARANA ARRANZ JOSEBA. Nombramientos. Apoderado: GILHARDI FREDERIQUE ANNE;AGUIARRAMOS ALFONSO. Datos registrales. T 4958, L 3865, F 69, S 8, H MA111765, I/A 4 (31.01.13).

18 de Mayo de 2012
Revocaciones. Apoderado: PEREZ GUILLEN JOSE-LUIS;DOMINGUEZ DIEZ JOSE MANUEL;GARCIA VALLEDOR JUAN;ARANAARRANZ JOSEBA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ACCIOLY MENEZES FERNANDO AUGUSTO;DOMINGUEZ DIEZ JOSEMANUEL;WANG SHUMIN;ARANA ARRANZ JOSEBA. Datos registrales. T 4958, L 3865, F 68, S 8, H MA111765, I/A 3 ( 4.05.12).

05 de Enero de 2012
Cambio de domicilio social. CMNO DE CAMPANALES S/N - MIJAS COSTA (MIJAS). Datos registrales. T 4958, L 3865, F 67, S 8,H MA111765, I/A 2 (22.12.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n