Buscador CIF Logo

Actos BORME Immediate Delivery Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Immediate Delivery Sl

Actos BORME Immediate Delivery Sl - B87511606

Tenemos registrados 30 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Immediate Delivery Sl con CIF B87511606

馃敊 Perfil de Immediate Delivery Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Immediate Delivery Sl

04 de Octubre de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DUE脩AS SERRANO SALVADOR CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: DUE脩AS SERRANOANTONIO JOSE. Datos registrales. T 40916 , F 67, S 8, H M 620080, I/A 29 (27.09.23).

Nombramientos. Apoderado: PE脩A SANCHEZ JESSICA. Datos registrales. T 40916 , F 67, S 8, H M 620080, I/A 30 (27.09.23).

26 de Enero de 2023
Revocaciones. Apoderado: RAMOS LOPEZ ALBERTO. Apo.Manc.: RAMOS LOPEZ ALBERTO. Datos registrales. T 40916 , F 67,S 8, H M 620080, I/A 27 (19.01.23).

Revocaciones. Apoderado: PRIETO GOMEZ DE LIA脩O JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 40916 , F 67, S 8, H M 620080, I/A28 (19.01.23).

19 de Enero de 2023
Revocaciones. Apoderado: PRIETO GOMEZ DE LIA脩O EDUARDO. Datos registrales. T 40916 , F 67, S 8, H M 620080, I/A 26(12.01.23).

30 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: DUE脩AS SERRANO ANTONIO JOSE. Datos registrales. T 40916 , F 66, S 8, H M 620080, I/A 25(22.12.22).

28 de Julio de 2022
Cambio de domicilio social. C/ CONDE DE VILCHES 25 (MADRID). Datos registrales. T 40916 , F 66, S 8, H M 620080, I/A 24(20.07.22).

06 de Mayo de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ROIBAS FOUQUAT JUAN ALBERTO. Nombramientos. Adm. Unico: DUE脩AS SERRANOSALVADOR CARLOS. Datos registrales. T 40916 , F 65, S 8, H M 620080, I/A 23 (28.04.22).

22 de Octubre de 2021
Reelecciones. Auditor: MGI AUDICON & PARTNERS SLP. Datos registrales. T 40916 , F 65, S 8, H M 620080, I/A 22 (15.10.21).

29 de Abril de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: SIGUERO GALBIS ANA BELEN;RUIZ BARRERA MANUEL;MARTIN PEREZ ANGEL. Datos registrales.T 40916 , F 65, S 8, H M 620080, I/A 21 (22.04.21).

27 de Noviembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: LLORENTE LINACERO HORTENSIA. Datos registrales. T 34475 , F 123, S 8, H M 620080, I/A 20(20.11.20).

31 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apoderado: DAVILA SERRANO EVA MARIA;TAJUELO SANCHEZ MARCO-ANTONIO;PE脩A SANCHEZ JESSICA.Datos registrales. T 34475 , F 123, S 8, H M 620080, I/A 19 (24.08.20).

14 de Octubre de 2019
Cambio de domicilio social. C/ MARCONI 1 (COSLADA). Datos registrales. T 34475 , F 123, S 8, H M 620080, I/A 18 ( 7.10.19).

30 de Enero de 2019
Nombramientos. Auditor: MGI AUDICON & PARTNERS SLP. Datos registrales. T 34475 , F 122, S 8, H M 620080, I/A 17(23.01.19).

31 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: LLORENTE LINACERO HORTENSIA. Datos registrales. T 34475 , F 122, S 8, H M 620080, I/A 16(21.12.18).

30 de Octubre de 2018
Cambio de domicilio social. C/ FRANCISCO SILVELA 42 - 1陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 34475 , F 122, S 8, H M620080, I/A 15 (23.10.18).

18 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ EDROSA GERMAN. Datos registrales. T 34475 , F 121, S 8, H M 620080, I/A 14(10.10.18).

19 de Marzo de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: CARRASCO CANDELARESE MARTA;NIETO PALMEIRO ANGEL CARLOS;CASTELLANO SANCHEZVICTORIANO;MARTIN PEREZ ANGEL;RUIZ BARRERA MANUEL;DUE脩AS SERRANO ERNESTO;DAVILA SERRANO EVAMARIA;SAN MAURICIO CALVO YOLANDA;GUTIERREZ LLEDO MONTSERRAT;MONTES MORENO GEMA MARIA. Datosregistrales. T 34475 , F 121, S 8, H M 620080, I/A 13 (12.03.18).

02 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: BARTOLOME MIGUEL ALBERTO. Datos registrales. T 34475 , F 120, S 8, H M 620080, I/A 12(25.01.18).

01 de Febrero de 2018
Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 14潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 34475 , F120, S 8, H M 620080, I/A 11 (24.01.18).

26 de Enero de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: LLORENTE LINACERO HORTENSIA;RAMOS LOPEZ ALBERTO. Datos registrales. T 34475 , F 119,S 8, H M 620080, I/A 10 (18.01.18).

05 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DUE脩AS SERRANO SALVADOR CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: ROIBAS FOUQUATJUAN ALBERTO. Datos registrales. T 34475 , F 119, S 8, H M 620080, I/A 9 (27.06.17).

26 de Mayo de 2017
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: TOTALICS SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: RIBERA SERRA JOSEP;DUE脩ASSERRANO ANTONIO JOSE. Nombramientos. Adm. Unico: DUE脩AS SERRANO SALVADOR CARLOS. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 34475 , F 118, S 8, H M620080, I/A 6 (18.05.17).

Nombramientos. Apoderado: PRIETO GOMEZ DE LIA脩O EDUARDO;PRIETO GOMEZ DE LIA脩O JOSE IGNACIO;RAMOS LOPEZALBERTO. Datos registrales. T 34475 , F 118, S 8, H M 620080, I/A 7 (18.05.17).

Nombramientos. Apoderado: TAJUELO SANCHEZ MARCO-ANTONIO. Datos registrales. T 34475 , F 119, S 8, H M 620080, I/A 8(18.05.17).

11 de Abril de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PRIETO GOMEZ DE LIA脩O EDUARDO. Nombramientos. Adm. Solid.: DUE脩AS SERRANOANTONIO JOSE. Datos registrales. T 34475 , F 117, S 8, H M 620080, I/A 5 (31.03.17).

25 de Octubre de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 80.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 190.000,00 Euros. Datos registrales. T 34475 , F 117, S 8, HM 620080, I/A 4 (13.10.16).

26 de Julio de 2016
Nombramientos. Apoderado: LLORENTE LINACERO HORTENSIA. Datos registrales. T 34475 , F 116, S 8, H M 620080, I/A 3(13.07.16).

15 de Julio de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 60.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 110.000,00 Euros. Datos registrales. T 34475 , F 115, S 8, HM 620080, I/A 2 ( 8.07.16).

28 de Marzo de 2016
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 1.03.16. Objeto social: Esta Sociedad tiene por objeto: 1 .- La creaci贸n, desarrollo,implantaci贸n y mantenimiento de todo tipo de programas inform谩ticos, software y plataformas digitales, mediante las que se facilitar谩 elcontacto entre personas f铆sicas o jur铆dicas que requieran de servicios de entregas... Domicilio: C/ CONDE DE VILCHES 25 (MADRID).Capital: 50.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Solid.: PRIETO GOMEZ DE LIA脩O EDUARDO;RIBERA SERRA JOSEP. Datosregistrales. T 34475 , F 113, S 8, H M 620080, I/A 1 (14.03.16).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n