Actos BORME de Imont Legal Services Srl
01 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: TERESA LAVALLE GOMEZ. Datos registrales. T 2672 , F 188, S 8, H MU 48721, I/A 26 (24.11.22).
11 de Julio de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: LOUISE FAULDS. Apoderado: LOUISE FAULDS. Datos registrales. T 2672 , F 187, S 8, H MU 48721, I/A25 ( 4.07.22).
29 de Junio de 2022Nombramientos. Apoderado: HUGO VAN DER HOLST. Datos registrales. T 2672 , F 187, S 8, H MU 48721, I/A 23 (22.06.22).
Nombramientos. Apoderado: DAVID SANCHEZ VILLAESCUSA. Datos registrales. T 2672 , F 187, S 8, H MU 48721, I/A 24(22.06.22).
01 de Junio de 2022Nombramientos. Apoderado: DAVID SANCHEZ VILLAESCUSA. Datos registrales. T 2672 , F 187, S 8, H MU 48721, I/A 22(25.05.22).
13 de Enero de 2022Nombramientos. Apoderado: JOSE VILLA DOMINGO. Datos registrales. T 2672 , F 187, S 8, H MU 48721, I/A 21 ( 5.01.22).
28 de Enero de 2021Nombramientos. Apoderado: HUGO VAN DER HOLST. Datos registrales. T 2672 , F 186, S 8, H MU 48721, I/A 19 (21.01.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: MONICA ISABEL LORENTE RAMON;ALFONSO GARCIA MONTESINOS. Datos registrales. T 2672 , F186, S 8, H MU 48721, I/A 20 (21.01.21).
06 de Septiembre de 2019Revocaciones. Apoderado: MARIA ROSARIO LAJARIN GARCIA. Datos registrales. T 2672 , F 186, S 8, H MU 48721, I/A 18 (2.09.19).
08 de Julio de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: ANNA MARIA SCHAFFRANKA;DAVID SANCHEZ VILLAESCUSA. Datos registrales. T 2672 , F 186, S8, H MU 48721, I/A 17 ( 1.07.19).
19 de Julio de 2018Revocaciones. Apoderado: MARTA GUERRERO DURENDEZ. Datos registrales. T 2672 , F 186, S 8, H MU 48721, I/A 16(11.07.18).
31 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: LOUISE FAULDS;ELENA PALAZON ROS. Datos registrales. T 2672 , F 185, S 8, H MU 48721, I/A 14(24.05.18).
Nombramientos. Apoderado: LOUISE FAULDS. Datos registrales. T 2672 , F 185, S 8, H MU 48721, I/A 15 (24.05.18).
03 de Junio de 2015Otros conceptos: Modifican la retribucion del cargo del organo de administracion y en su consecuencia el punto 3 del articulo 9º delos Estatutos Sociales. Datos registrales. T 2672 , F 184, S 8, H MU 48721, I/A 11 (27.05.15).
Nombramientos. Apoderado: MARTA GUERRERO DURENDEZ. Datos registrales. T 2672 , F 185, S 8, H MU 48721, I/A 12(27.05.15).
Nombramientos. Apoderado: MARIA ROSARIO LAJARIN GARCIA. Datos registrales. T 2672 , F 185, S 8, H MU 48721, I/A 13(27.05.15).
30 de Junio de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: NATHALIE ROMERO;ELENA PALAZON ROS. Datos registrales. T 2672 , F 184, S 8, H MU 48721, I/A10 (20.06.11).
14 de Mayo de 2009Nombramientos. Apoderado: NATHALIE ROMERO. Datos registrales. T 2130 , F 29, S 8, H MU 48721, I/A 9 ( 5.05.09).
05 de Febrero de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: MARIA CARMEN GARCIA BLANC;MARIA DEL PILAR LOURDES LUCAS GARCIA. Datos registrales. T2130 , F 28, S 8, H MU 48721, I/A 8 (27.01.09).