Actos BORME de Impermat Sa
16 de Abril de 2019Nombramientos. Cons.Del.Sol: JIMENEZ GOMEZ JAVIER;JIMENEZ GOMEZ MANUELA. Apoderado: JIMENEZ GOMEZ JAVIER.Datos registrales. T 1092 , F 128, S 8, H M 20845, I/A 19 ( 9.04.19).
20 de Noviembre de 2018Otros conceptos: Fijado el capital social en 841.400 euros por la toma de razon de la sentencia de 28 de abril de 2014, de laAudiencia Provincial de Madrid, modificando el art铆culo 5 de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 1092 , F 128, S 8, H M20845, I/A 18 (13.11.18).
23 de Enero de 2018Nombramientos. Presidente: JIMENEZ GOMEZ JAVIER. Secretario: JIMENEZ GOMEZ MANUELA. Vicesecret.: ROMILLO JIMENEZDIANA. Datos registrales. T 1092 , F 128, S 8, H M 20845, I/A 17 (16.01.18).
03 de Noviembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ GOMEZ JAVIER. Presidente: JIMENEZ GOMEZ JAVIER. Consejero: JIMENEZ GOMEZMANUELA. Secretario: JIMENEZ GOMEZ MANUELA. Consejero: ROMILLO JIMENEZ DIANA. Cons.Del.Sol: JIMENEZ GOMEZJAVIER;JIMENEZ GOMEZ MANUELA. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ GOMEZ JAVIER;JIMENEZ GOMEZMANUELA;ROMILLO JIMENEZ DIANA. Datos registrales. T 1092 , F 127, S 8, H M 20845, I/A 16 (25.10.17).
30 de Enero de 2015Fe de erratas: POR SENTENCIA FIRME DICTADA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2014, SE DECRETA LA NULIDAD DEL ACUERDOADOPTADO BAJO EL PUNTO " SEGUNDO " DEL ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL CELEBRADA EL DIA 27 DEOCTUBRE DE 2005 Y LA CANCELACION DEL ASIENTO QUE CAUSO EN ESTE REGISTRO.- Datos registrales. T 1092 , F 127, S8, H M 20845, I/A 15 (23.01.15).
17 de Julio de 2014Otros conceptos: SENTENCIA DE ANULACION DEL ACUERDO SEGUNDO DE LA INSCRIPCION 11& DE LA HOJA SOCIAL, QUEQUEDA CANCELADO. Datos registrales. T 1092 , F 127, S 8, H M 20845, I/A A ( 7.07.14).
03 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ GOMEZ JAVIER;JIMENEZ GOMEZ MANUELA;ROMILLO JIMENEZ DIANA. Presidente:JIMENEZ GOMEZ JAVIER. Secretario: JIMENEZ GOMEZ MANUELA. Cons.Del.Sol: JIMENEZ GOMEZ JAVIER;JIMENEZ GOMEZMANUELA. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ GOMEZ JAVIER. Presidente: JIMENEZ GOMEZ JAVIER. Consejero: JIMENEZGOMEZ MANUELA. Secretario: JIMENEZ GOMEZ MANUELA. Consejero: ROMILLO JIMENEZ DIANA. Cons.Del.Sol: JIMENEZGOMEZ JAVIER;JIMENEZ GOMEZ MANUELA. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 585.975,00 Euros. Desembolsado: 585.975,00Euros. Resultante Suscrito: 878.962,50 Euros. Resultante Desembolsado: 878.962,50 Euros. Datos registrales. T 1092 , F 125, S 8,H M 20845, I/A 14 (19.04.12).
29 de Mayo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ GOMEZ JAVIER;JIMENEZ GOMEZ MANUELA;ROMILLO JIMENEZ DIANA. Presidente:JIMENEZ GOMEZ JAVIER. Secretario: JIMENEZ GOMEZ MANUELA. Vicesecret.: ROMILLO JIMENEZ DIANA. Cons.Del.Sol:JIMENEZ GOMEZ JAVIER;JIMENEZ GOMEZ MANUELA. Nombramientos. Auditor: NU脩EZ & MARTIN AUDIFIS ASOCIADOS SAP.Consejero: JIMENEZ GOMEZ JAVIER;JIMENEZ GOMEZ MANUELA;ROMILLO JIMENEZ DIANA. Presidente: JIMENEZ GOMEZJAVIER. Secretario: JIMENEZ GOMEZ MANUELA. Cons.Del.Sol: JIMENEZ GOMEZ JAVIER;JIMENEZ GOMEZ MANUELA.Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 195.325,00 Euros. Desembolsado: 195.325,00 Euros. Resultante Suscrito: 292.988,71 Euros.Resultante Desembolsado: 292.988,71 Euros. Datos registrales. T 1092 , F 124, S 8, H M 20845, I/A 13 (18.05.09).