Buscador CIF Logo

Actos BORME Impermat Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Impermat Sa

Actos BORME Impermat Sa - A79219937

Tenemos registrados 8 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Impermat Sa con CIF A79219937

馃敊 Perfil de Impermat Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Impermat Sa

16 de Abril de 2019
Nombramientos. Cons.Del.Sol: JIMENEZ GOMEZ JAVIER;JIMENEZ GOMEZ MANUELA. Apoderado: JIMENEZ GOMEZ JAVIER.Datos registrales. T 1092 , F 128, S 8, H M 20845, I/A 19 ( 9.04.19).

20 de Noviembre de 2018
Otros conceptos: Fijado el capital social en 841.400 euros por la toma de razon de la sentencia de 28 de abril de 2014, de laAudiencia Provincial de Madrid, modificando el art铆culo 5 de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 1092 , F 128, S 8, H M20845, I/A 18 (13.11.18).

23 de Enero de 2018
Nombramientos. Presidente: JIMENEZ GOMEZ JAVIER. Secretario: JIMENEZ GOMEZ MANUELA. Vicesecret.: ROMILLO JIMENEZDIANA. Datos registrales. T 1092 , F 128, S 8, H M 20845, I/A 17 (16.01.18).

03 de Noviembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ GOMEZ JAVIER. Presidente: JIMENEZ GOMEZ JAVIER. Consejero: JIMENEZ GOMEZMANUELA. Secretario: JIMENEZ GOMEZ MANUELA. Consejero: ROMILLO JIMENEZ DIANA. Cons.Del.Sol: JIMENEZ GOMEZJAVIER;JIMENEZ GOMEZ MANUELA. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ GOMEZ JAVIER;JIMENEZ GOMEZMANUELA;ROMILLO JIMENEZ DIANA. Datos registrales. T 1092 , F 127, S 8, H M 20845, I/A 16 (25.10.17).

30 de Enero de 2015
Fe de erratas: POR SENTENCIA FIRME DICTADA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2014, SE DECRETA LA NULIDAD DEL ACUERDOADOPTADO BAJO EL PUNTO " SEGUNDO " DEL ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL CELEBRADA EL DIA 27 DEOCTUBRE DE 2005 Y LA CANCELACION DEL ASIENTO QUE CAUSO EN ESTE REGISTRO.- Datos registrales. T 1092 , F 127, S8, H M 20845, I/A 15 (23.01.15).

17 de Julio de 2014
Otros conceptos: SENTENCIA DE ANULACION DEL ACUERDO SEGUNDO DE LA INSCRIPCION 11& DE LA HOJA SOCIAL, QUEQUEDA CANCELADO. Datos registrales. T 1092 , F 127, S 8, H M 20845, I/A A ( 7.07.14).

03 de Mayo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ GOMEZ JAVIER;JIMENEZ GOMEZ MANUELA;ROMILLO JIMENEZ DIANA. Presidente:JIMENEZ GOMEZ JAVIER. Secretario: JIMENEZ GOMEZ MANUELA. Cons.Del.Sol: JIMENEZ GOMEZ JAVIER;JIMENEZ GOMEZMANUELA. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ GOMEZ JAVIER. Presidente: JIMENEZ GOMEZ JAVIER. Consejero: JIMENEZGOMEZ MANUELA. Secretario: JIMENEZ GOMEZ MANUELA. Consejero: ROMILLO JIMENEZ DIANA. Cons.Del.Sol: JIMENEZGOMEZ JAVIER;JIMENEZ GOMEZ MANUELA. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 585.975,00 Euros. Desembolsado: 585.975,00Euros. Resultante Suscrito: 878.962,50 Euros. Resultante Desembolsado: 878.962,50 Euros. Datos registrales. T 1092 , F 125, S 8,H M 20845, I/A 14 (19.04.12).

29 de Mayo de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ GOMEZ JAVIER;JIMENEZ GOMEZ MANUELA;ROMILLO JIMENEZ DIANA. Presidente:JIMENEZ GOMEZ JAVIER. Secretario: JIMENEZ GOMEZ MANUELA. Vicesecret.: ROMILLO JIMENEZ DIANA. Cons.Del.Sol:JIMENEZ GOMEZ JAVIER;JIMENEZ GOMEZ MANUELA. Nombramientos. Auditor: NU脩EZ & MARTIN AUDIFIS ASOCIADOS SAP.Consejero: JIMENEZ GOMEZ JAVIER;JIMENEZ GOMEZ MANUELA;ROMILLO JIMENEZ DIANA. Presidente: JIMENEZ GOMEZJAVIER. Secretario: JIMENEZ GOMEZ MANUELA. Cons.Del.Sol: JIMENEZ GOMEZ JAVIER;JIMENEZ GOMEZ MANUELA.Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 195.325,00 Euros. Desembolsado: 195.325,00 Euros. Resultante Suscrito: 292.988,71 Euros.Resultante Desembolsado: 292.988,71 Euros. Datos registrales. T 1092 , F 124, S 8, H M 20845, I/A 13 (18.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n