Buscador CIF Logo

Actos BORME Implantaciones De Tiendas Alimenticias Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Implantaciones De Tiendas Alimenticias Sa

Actos BORME Implantaciones De Tiendas Alimenticias Sa - A28946705

Tenemos registrados 8 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Implantaciones De Tiendas Alimenticias Sa con CIF A28946705

🔙 Perfil de Implantaciones De Tiendas Alimenticias Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Implantaciones De Tiendas Alimenticias Sa

25 de Junio de 2021
Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 40894 , F190, S 8, H M 62007, I/A 18 (18.06.21).

Nombramientos. Apoderado: LIN LIFENG. Datos registrales. T 40894 , F 190, S 8, H M 62007, I/A 19 (18.06.21).

19 de Febrero de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPOS GARCIA AGUSTIN. Secretario: CAMPOS GARCIA AGUSTIN. Cons.Del.Sol: CAMPOSGARCIA AGUSTIN. Consejero: LOPEZ MARTINEZ ANDRES SILVESTRE. Presidente: LOPEZ MARTINEZ ANDRES SILVESTRE.Consejero: VEGA CEREZO EVILASIO. Cons.Del.Sol: LOPEZ MARTINEZ ANDRES SILVESTRE. Nombramientos. Adm. Unico: ZHUXUBING. Modificaciones estatutarias. Dejar sin contenido los artículos 22º, 23º, 24º, 25º y 26º de los Estatutos Sociales ymodificados los artículos 9º, 20º, 21º y 22º de los mismos. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo deadministración a Administrador único. Datos registrales. T 3691 , F 116, S 8, H M 62007, I/A 17 (12.02.21).

28 de Septiembre de 2020
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 14.896,69 Euros. Datos registrales. T 3691 , F 116, S 8, H M 62007, I/A 16(21.09.20).

03 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apoderado: ZHU XUBING. Datos registrales. T 3691 , F 115, S 8, H M 62007, I/A 15 (27.07.20).

20 de Marzo de 2020
Ampliación de capital. Suscrito: 27.045,54 Euros. Desembolsado: 12.148,85 Euros. Resultante Suscrito: 147.247,96 Euros.Resultante Desembolsado: 132.351,27 Euros. Datos registrales. T 3691 , F 115, S 8, H M 62007, I/A 14 (13.03.20).

17 de Enero de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: VEGA CEREZO EVILASIO;CAMPOS GARCIA AGUSTIN;LOPEZ MARTINEZ ANDRESSILVESTRE;COMERCIAL SUPERMA SA EN LIQUIDACION. Presidente: CAMPOS GARCIA AGUSTIN. Secretario: VEGA CEREZOEVILASIO. Cons.Del.Sol: CAMPOS GARCIA AGUSTIN;VEGA CEREZO EVILASIO. Representan: JIMENEZ GUERRALEONCIO;JIMENEZ GUERRA LEONCIO;DORADO BERGAZ PAULINO;VEGA CEREZO EVILASIO. Nombramientos. Consejero:CAMPOS GARCIA AGUSTIN. Secretario: CAMPOS GARCIA AGUSTIN. Cons.Del.Sol: CAMPOS GARCIA AGUSTIN. Consejero:LOPEZ MARTINEZ ANDRES SILVESTRE. Presidente: LOPEZ MARTINEZ ANDRES SILVESTRE. Consejero: VEGA CEREZOEVILASIO. Cons.Del.Sol: LOPEZ MARTINEZ ANDRES SILVESTRE. Datos registrales. T 3691 , F 114, S 8, H M 62007, I/A 13 (5.01.17).

25 de Octubre de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: VEGA CEREZO EVILASIO;CAMPOS GARCIA AGUSTIN;LOPEZ MARTINEZ ANDRESSILVESTRE;COMERCIAL SUPERMA SA EN LIQUIDACION. Presidente: CAMPOS GARCIA AGUSTIN. Secretario: VEGA CEREZOEVILASIO. Cons.Del.Man: VEGA CEREZO EVILASIO;CAMPOS GARCIA AGUSTIN;LOPEZ MARTINEZ ANDRESSILVESTRE;COMERCIAL SUPERMA SA EN LIQUIDACION. Nombramientos. Consejero: VEGA CEREZO EVILASIO;CAMPOSGARCIA AGUSTIN;LOPEZ MARTINEZ ANDRES SILVESTRE;COMERCIAL SUPERMA SA EN LIQUIDACION. Presidente: CAMPOSGARCIA AGUSTIN. Secretario: VEGA CEREZO EVILASIO. Cons.Del.Sol: CAMPOS GARCIA AGUSTIN;VEGA CEREZO EVILASIO.Representan: DORADO BERGAZ PAULINO;VEGA CEREZO EVILASIO. Datos registrales. T 3691 , F 113, S 8, H M 62007, I/A 12(13.10.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información