Actos BORME de Implantaciones De Tiendas Alimenticias Sa
25 de Junio de 2021Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 40894 , F190, S 8, H M 62007, I/A 18 (18.06.21).
Nombramientos. Apoderado: LIN LIFENG. Datos registrales. T 40894 , F 190, S 8, H M 62007, I/A 19 (18.06.21).
19 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPOS GARCIA AGUSTIN. Secretario: CAMPOS GARCIA AGUSTIN. Cons.Del.Sol: CAMPOSGARCIA AGUSTIN. Consejero: LOPEZ MARTINEZ ANDRES SILVESTRE. Presidente: LOPEZ MARTINEZ ANDRES SILVESTRE.Consejero: VEGA CEREZO EVILASIO. Cons.Del.Sol: LOPEZ MARTINEZ ANDRES SILVESTRE. Nombramientos. Adm. Unico: ZHUXUBING. Modificaciones estatutarias. Dejar sin contenido los artículos 22º, 23º, 24º, 25º y 26º de los Estatutos Sociales ymodificados los artículos 9º, 20º, 21º y 22º de los mismos. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo deadministración a Administrador único. Datos registrales. T 3691 , F 116, S 8, H M 62007, I/A 17 (12.02.21).
28 de Septiembre de 2020Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 14.896,69 Euros. Datos registrales. T 3691 , F 116, S 8, H M 62007, I/A 16(21.09.20).
03 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: ZHU XUBING. Datos registrales. T 3691 , F 115, S 8, H M 62007, I/A 15 (27.07.20).
20 de Marzo de 2020Ampliación de capital. Suscrito: 27.045,54 Euros. Desembolsado: 12.148,85 Euros. Resultante Suscrito: 147.247,96 Euros.Resultante Desembolsado: 132.351,27 Euros. Datos registrales. T 3691 , F 115, S 8, H M 62007, I/A 14 (13.03.20).
17 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: VEGA CEREZO EVILASIO;CAMPOS GARCIA AGUSTIN;LOPEZ MARTINEZ ANDRESSILVESTRE;COMERCIAL SUPERMA SA EN LIQUIDACION. Presidente: CAMPOS GARCIA AGUSTIN. Secretario: VEGA CEREZOEVILASIO. Cons.Del.Sol: CAMPOS GARCIA AGUSTIN;VEGA CEREZO EVILASIO. Representan: JIMENEZ GUERRALEONCIO;JIMENEZ GUERRA LEONCIO;DORADO BERGAZ PAULINO;VEGA CEREZO EVILASIO. Nombramientos. Consejero:CAMPOS GARCIA AGUSTIN. Secretario: CAMPOS GARCIA AGUSTIN. Cons.Del.Sol: CAMPOS GARCIA AGUSTIN. Consejero:LOPEZ MARTINEZ ANDRES SILVESTRE. Presidente: LOPEZ MARTINEZ ANDRES SILVESTRE. Consejero: VEGA CEREZOEVILASIO. Cons.Del.Sol: LOPEZ MARTINEZ ANDRES SILVESTRE. Datos registrales. T 3691 , F 114, S 8, H M 62007, I/A 13 (5.01.17).
25 de Octubre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: VEGA CEREZO EVILASIO;CAMPOS GARCIA AGUSTIN;LOPEZ MARTINEZ ANDRESSILVESTRE;COMERCIAL SUPERMA SA EN LIQUIDACION. Presidente: CAMPOS GARCIA AGUSTIN. Secretario: VEGA CEREZOEVILASIO. Cons.Del.Man: VEGA CEREZO EVILASIO;CAMPOS GARCIA AGUSTIN;LOPEZ MARTINEZ ANDRESSILVESTRE;COMERCIAL SUPERMA SA EN LIQUIDACION. Nombramientos. Consejero: VEGA CEREZO EVILASIO;CAMPOSGARCIA AGUSTIN;LOPEZ MARTINEZ ANDRES SILVESTRE;COMERCIAL SUPERMA SA EN LIQUIDACION. Presidente: CAMPOSGARCIA AGUSTIN. Secretario: VEGA CEREZO EVILASIO. Cons.Del.Sol: CAMPOS GARCIA AGUSTIN;VEGA CEREZO EVILASIO.Representan: DORADO BERGAZ PAULINO;VEGA CEREZO EVILASIO. Datos registrales. T 3691 , F 113, S 8, H M 62007, I/A 12(13.10.10).