Actos BORME de Incalplas Sl
31 de Octubre de 2023Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 928 , F 176, S 8, H OR 3016, I/A 42 (24.10.23).
19 de Junio de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: DUMOULIN YVES MARIE. Presidente: DUMOULIN YVES MARIE. Nombramientos. Consejero:BRILLAT-SAVARIN YANN HENRI NICOLAS. Presidente: BRILLAT-SAVARIN YANN HENRI NICOLAS. Datos registrales. T 928 , F175, S 8, H OR 3016, I/A 41 (31.05.23).
31 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: BAYO CONTEL PABLO. Apo.Sol.: GONZALEZ RODRIGUEZ DE SANABRIA JOSE LUIS;BAYO CONTELPABLO. Nombramientos. Apo.Sol.: OLIVERT RICART JORGE. Apo.Manc.: OLIVERT RICART JORGE. Apo.Sol.: BERENGUER
07 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 928 , F 174, S 8, H OR 3016, I/A 39 (27.10.22).
09 de Mayo de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: TORIBIO CAMARA EMILIANO. Nombramientos. Apo.Manc.: KERLEGUER YANNICK. Apo.Sol.:KERLEGUER YANNICK. Datos registrales. T 928 , F 173, S 8, H OR 3016, I/A 38 (22.04.22).
17 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: CHARLES ANCEY CHRISTOPHE. Presidente: CHARLES ANCEY CHRISTOPHE. Nombramientos.Consejero: DUMOULIN YVES MARIE. Presidente: DUMOULIN YVES MARIE. Datos registrales. T 928 , F 173, S 8, H OR 3016, I/A37 (27.10.21).
13 de Agosto de 2021Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 928 , F 172, S 8, H OR 3016, I/A 36 (30.07.21).
28 de Julio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ RODRIGUEZ DE SANABRIA JOSE LUIS. Apo.Manc.: GONZALEZ RODRIGUEZ DESANABRIA JOSE LUIS. Nombramientos. Apo.Manc.: BLANCO BELLO NURIA. Apo.Sol.: BLANCO BELLO NURIA. Datosregistrales. T 928 , F 172, S 8, H OR 3016, I/A 35 ( 9.07.21).
30 de Abril de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: TORIBIO CAMARA EMILIANO. Nombramientos. Apo.Manc.: YAMANE MAKI. Apo.Sol.: YAMANEMAKI;GONZALEZ RODRIGUEZ DE SANABRIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 878 , F 195, S 8, H OR 3016, I/A 34 (16.04.21).
15 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 878 , F 195, S 8, H OR 3016, I/A 33 (27.11.20).
04 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: ACEDO NABAL PABLO ANTONIO;PADILLA PEREIRA JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: PADILLAPEREIRA JOSE. Apo.Manc.: PADILLA PEREIRA JOSE. Apo.Sol.: ACEDO NABAL PABLO ANTONIO. Apo.Manc.: ACEDO NABALPABLO ANTONIO. Datos registrales. T 878 , F 194, S 8, H OR 3016, I/A 32 (25.11.20).
24 de Octubre de 2019Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 878 , F 194, S 8, H OR 3016, I/A 31 (14.10.19).
14 de Agosto de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: TORIBIO CAMARA EMILIANO. Apo.Sol.: TORIBIO CAMARA EMILIANO. Nombramientos. Apo.Manc.:TORIBIO CAMARA EMILIANO. Apo.Sol.: TORIBIO CAMARA EMILIANO. Datos registrales. T 878 , F 193, S 8, H OR 3016, I/A 30(24.07.19).
31 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGO SANCHEZ JAVIER. Apo.Manc.: RODRIGO SANCHEZ JAVIER. Datos registrales. T 878 , F193, S 8, H OR 3016, I/A 29 (20.05.19).
16 de Noviembre de 2018Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 878 , F 192, S 8, H OR 3016, I/A 28 ( 7.11.18).
29 de Diciembre de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: TORIBIO CAMARA EMILIANO;LOPEZ DE QUINTANA JAVIER ESTEBAN. Apo.Sol.: LOPEZ DEQUINTANA JAVIER ESTEBAN. Nombramientos. Apo.Sol.: LARA MORA TOMAS. Apo.Manc.: LARA MORA TOMAS;TORIBIOCAMARA EMILIANO. Apo.Sol.: TORIBIO CAMARA EMILIANO. Datos registrales. T 878 , F 191, S 8, H OR 3016, I/A 27 (12.12.17).
29 de Agosto de 2017Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 878 , F 191, S 8, H OR 3016, I/A 26 ( 7.08.17).
07 de Junio de 2017Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: FAURECIA HOLDINGS ESPA脩A SL. Datos registrales. T 878 , F191, S 8, H OR 3016, I/A 25 (25.05.17).
02 de Febrero de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: MAZO GAUTIER JUAN PEDRO;GONZALEZ TIZON JOSE MANUEL. Apo.Sol.: UMBERT MILLETINMACULADA. Apo.Manc.: BAYO CONTEL PABLO. Apo.Sol.: BAYO CONTEL PABLO. Nombramientos. Apo.Sol.: BAYO CONTELPABLO. Apo.Manc.: BAYO CONTEL PABLO. Apo.Sol.: MAZO GAUTIER JUAN PEDRO. Apo.Manc.: MAZO GAUTIER JUAN PEDRO.Apo.Sol.: VILLASANTE FERRANDO JAVIER;GARCIA GONZALEZ MARCOS. Datos registrales. T 878 , F 188, S 8, H OR 3016, I/A24 (19.01.17).
17 de Octubre de 2016Ceses/Dimisiones. Secretario: UMBERT MILLET INMACULADA. Nombramientos. Apo.Sol.: MAULEON LOZANO SANTOS.Secretario: MAULEON LOZANO SANTOS. Apo.Manc.: MAULEON LOZANO SANTOS. Datos registrales. T 867 , F 203, S 8, H OR3016, I/A 22 ( 6.10.16).
Ceses/Dimisiones. Consejero: YVES FAROU PATRICK LUCIEN. Revocaciones. Apo.Sol.: YVES FAROU PATRICK LUCIEN.Apo.Manc.: YVES FAROU PATRICK LUCIEN. Apo.Man.Soli: LARA MORA TOMAS. Nombramientos. Consejero: BAYO CONTELPABLO. Apo.Sol.: GONZALEZ RODRIGUEZ DE SANABRIA JOSE LUIS. Apo.Manc.: GONZALEZ RODRIGUEZ DE SANABRIA JOSELUIS. Otros conceptos: Incorporaci贸n de los art铆culos 8 bis y 10 bis a los Estatutos Sociales relativos a la asistencia telem谩tica delos socios a la Junta General y los Consejeros al Consejo de Administraci贸n y de los acuerdos adoptados por escrito y sin sesi贸n delConsejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 867 , F 204, S 8, H OR 3016, I/A 23 ( 6.10.16).
23 de Febrero de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ DE QUINTANA JAVIER ESTEBAN. Apo.Manc.: LOPEZ DE QUINTANA JAVIER ESTEBAN.Apo.Sol.: GROBA PRESA JOSE ANTONIO. Apo.Manc.: GROBA PRESA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 867 , F 201, S 8, HOR 3016, I/A 21 (10.02.16).
11 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 846 , F 110, S 8, H OR 3016, I/A 20(30.11.15).
30 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. Auditor: LOPEZ R. AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 846, F 110, S 8, H OR 3016, I/A 19 (16.03.15).
27 de Junio de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: GIL CARBO FERNANDO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ HERNANDEZ MIGUELANGEL. Datos registrales. T 846 , F 107, S 8, H OR 3016, I/A 17 (16.06.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LARA MORA TOMAS. Datos registrales. T 846 , F 109, S 8, H OR 3016, I/A 18 (16.06.14).
14 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: MELLADO ARTECHE JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero: YVES FAROU PATRICKLUCIEN. Datos registrales. T 439 , F 6, S 8, H OR 3016, I/A 15 ( 7.02.14).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MELLADO ARTECHE JOSE MANUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: YVES FAROU PATRICK LUCIEN.Apo.Manc.: YVES FAROU PATRICK LUCIEN. Datos registrales. T 439 , F 6, S 8, H OR 3016, I/A 16 ( 7.02.14).
09 de Diciembre de 2013Reelecciones. Auditor: LOPEZ R. AUDITORES SL. Datos registrales. T 439 , F 6, S 8, H OR 3016, I/A 14 (27.11.13).
16 de Julio de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA DOMENECH MARTA. Datos registrales. T 439 , F 6, S 8, H OR 3016, I/A 13 ( 5.07.13).
28 de Enero de 2013Ceses/Dimisiones. Presidente: GINO BOYER HERVE PAUL. Nombramientos. Consejero: CHARLES ANCEY CHRISTOPHE.Presidente: CHARLES ANCEY CHRISTOPHE. Datos registrales. T 439 , F 5, S 8, H OR 3016, I/A 12 (18.01.13).
02 de Octubre de 2012Reelecciones. Auditor: LOPEZ R. AUDITORES SL. Datos registrales. T 439 , F 5, S 8, H OR 3016, I/A 11 (20.09.12).
28 de Febrero de 2012Reelecciones. Auditor: LOPEZ R. AUDITORES SL. Datos registrales. T 439 , F 5, S 8, H OR 3016, I/A 10 ( 7.02.12).
31 de Agosto de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA DOMENECH MARTA. Datos registrales. T 439 , F 4, S 8, H OR 3016, I/A 8 ( 8.08.11).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ ARIAS JOSE CARLOS. Nombramientos. Apo.Manc.: BAYO CONTEL PABLO.Apo.Sol.: BAYO CONTEL PABLO. Datos registrales. T 439 , F 4, S 8, H OR 3016, I/A 9 ( 8.08.11).
05 de Mayo de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA-RENEDO ALVAREZ-HEVIA BEATRIZ. Datos registrales. T 439 , F 4, S 8, H OR 3016, I/A 7(15.04.11).
10 de Febrero de 2011Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: FAURECIA AUTOMOTIVE ESPA脩A SL. Datos registrales. T 439 , F 3, S 8, H OR3016, I/A 6 (28.01.11).
14 de Septiembre de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PEREZ BOUZAS JOSE JAVIER;PEREZ BOUZAS ANGEL JOSE. Nombramientos. Consejero:GINO BOYER HERVE PAUL;MAZO GAUTIER JUAN PEDRO;MELLADO ARTECHE JOSE MANUEL. Presidente: GINO BOYERHERVE PAUL. Secretario: UMBERT MILLET INMACULADA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Otros conceptos: Modificaci贸n de los art铆culos 8 y 10 de los EstatutosSociales como consecuencia del cambio del sistema de administraci贸n. Datos registrales. T 439 , F 1, S 8, H OR 3016, I/A 4(25.08.10).
Nombramientos. Apoderado: GIL CARBO FERNANDO;PADILLA PEREIRA JOSE;RODRIGUEZ ARIAS JOSE CARLOS;ACEDONABAL PABLO ANTONIO;MAZO GAUTIER JUAN PEDRO;MELLADO ARTECHE JOSE MANUEL;TORIBIO CAMARAEMILIANO;GONZALEZ TIZON JOSE MANUEL;UMBERT MILLET INMACULADA. Datos registrales. T 439 , F 2, S 8, H OR 3016, I/A5 (25.08.10).
13 de Febrero de 2009Nombramientos. Auditor: LOPEZ R. AUDITORES SL. Datos registrales. T 439 , F 1, S 8, H OR 3016, I/A 3 (19.01.09).