Actos BORME de Incopack Sa
29 de Marzo de 2023Otros conceptos: RECTIFICADA LA INS 26 POR OMISION DEL ACUERDO DE REVOCACION DE PODERES A DON ENRIQUESERRANO GIL Y A DO脩A MIREYA SERRANO GIL.PUBLICADO EN EL BORME 63/2022 CON REFERENCIA 142600. Datosregistrales. T 44829 , F 155, S 8, H B 154285, I/A 29 (22.03.23).
28 de Marzo de 2023Fe de erratas: En el BORME no.63/2022 y con referencia 142600 SE OMITIO LA REVOCACION DE LOS PODERES A FAVOR DEDON ENRIQUE SERRANO GIL Y DO脩A MIREYA SERRANO GIL. Datos registrales. T 44829 , F 154, S 8, H B 154285, I/A 26(25.03.22).
22 de Junio de 2022Cambio de domicilio social. CL CAN SELLARES Num.20 (SANT ANDREU DE LA BARCA). Datos registrales. T 44829 , F 154, S8, H B 154285, I/A 28 (15.06.22).
20 de Junio de 2022Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 465.371,62 Euros. Desembolsado: 465.371,62 Euros. Resultante Suscrito: 525.481,62 Euros.Resultante Desembolsado: 525.481,62 Euros. Datos registrales. T 44829 , F 154, S 8, H B 154285, I/A 27 ( 9.06.22).
31 de Marzo de 2022Revocaciones. ADM.UNICO: SERRANO GIL ENRIQUE. Nombramientos. ADM.UNICO: MAYOR BELLOSTA MIGUEL ANGEL.Datos registrales. T 44829 , F 154, S 8, H B 154285, I/A 26 (25.03.22).
15 de Octubre de 2021Revocaciones. APODERAD.SOL: RAMIREZ FERNANDEZ MANUEL. Datos registrales. T 44829 , F 154, S 8, H B 154285, I/A 25 (6.10.21).
04 de Agosto de 2021Nombramientos. APODERAD.SOL: MAYOR BELLOSTA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 44829 , F 153, S 8, H B 154285, I/A24 (26.07.21).
01 de Diciembre de 2020Nombramientos. AUDIT.CUENT.: CENTURY AUDITORES SA. Datos registrales. T 44829 , F 152, S 8, H B 154285, I/A 23(23.11.20).
14 de Julio de 2020Nombramientos. APODERAD.SOL: RAMIREZ FERNANDEZ MANUEL. Datos registrales. T 44829 , F 151, S 8, H B 154285, I/A 22( 7.07.20).
12 de Junio de 2020Revocaciones. ADM.UNICO: RAMIREZ FERNANDEZ MANUEL. Nombramientos. ADM.UNICO: SERRANO GIL ENRIQUE. Datosregistrales. T 44829 , F 151, S 8, H B 154285, I/A 21 ( 5.06.20).
13 de Febrero de 2020Otros conceptos: PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL. Datos registrales. T 44829 , F 151, S 8, H B154285, I/A 20 ( 5.02.20).
10 de Octubre de 2017Nombramientos. AUDIT.CUENT.: CENTURY AUDITORES SA. Datos registrales. T 44829 , F 151, S 8, H B 154285, I/A 19 (3.10.17).
03 de Junio de 2015Nombramientos. ADM.UNICO: RAMIREZ FERNANDEZ MANUEL. Datos registrales. T 44829 , F 151, S 8, H B 154285, I/A 18(26.05.15).
25 de Septiembre de 2014Nombramientos. AUDIT.CUENT.: CENTURY AUDITORES SA. Datos registrales. T 29251 , F 142, S 8, H B 154285, I/A 17(17.09.14).
18 de Mayo de 2012Otros conceptos: DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD.SOCIO UNICO:SVOLTA CENTRAL SL. Datos registrales. T 29251 , F142, S 8, H B 154285, I/A 16 ( 7.05.12).
27 de Octubre de 2011Nombramientos. AUDIT.CUENT.: CENTURY AUDITORES SA. Datos registrales. T 29251 , F 142, S 8, H B 154285, I/A 15(17.10.11).
24 de Junio de 2010Revocaciones. ADM.UNICO: SERRANO GIL ENRIQUE. Nombramientos. ADM.UNICO: RAMIREZ FERNANDEZ MANUEL. Datosregistrales. T 29251 , F 142, S 8, H B 154285, I/A 14 (11.06.10).
08 de Junio de 2010Nombramientos. APODERADO: SERRANO GIL MIREYA. Datos registrales. T 29251 , F 141, S 8, H B 154285, I/A 13 (26.05.10).
18 de Enero de 2010Nombramientos. AUDIT.CUENT.: CENTURY AUDITORES SA. Datos registrales. T 29251 , F 140, S 8, H B 154285, I/A 12 (5.01.10).
04 de Agosto de 2009Nombramientos. AUDIT.CUENT.: CENTURY AUDITORES SA. Datos registrales. T 29251 , F 140, S 8, H B 154285, I/A 10(21.07.09).
Cambio de domicilio social. AV GAUDI,12-42 POL.IND.RUBI SUD (RUBI). Datos registrales. T 29251 , F 140, S 8, H B 154285,I/A 11 (21.07.09).