Buscador CIF Logo

Actos BORME Indesign Retail Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Indesign Retail Sl

Actos BORME Indesign Retail Sl - B64846876

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Indesign Retail Sl con CIF B64846876

馃敊 Perfil de Indesign Retail Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Indesign Retail Sl

06 de Abril de 2016
Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 315/2015, AUTOFIRME DE FECHA 07/01/2016, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION. Datos registrales. T 44446 , F 212, S 8, H B 369720,I/A 12 (30.03.16).

16 de Diciembre de 2015
Revocaciones. ADM.UNICO: RUIZ FAUSTO PEDRO ANTONIO. Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA,PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 315/2015, AUTO FIRME DE FECHA 09/10/2015, POR EL QUE SE ACUERDA LAAPERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. Disoluci贸n. Judicial. Datos registrales. T 44446 , F 212, S 8, H B369720, I/A 11 (10.12.15).

25 de Agosto de 2015
Nombramientos. REP.ADM.CONC: ALONSO CUEVILLAS SAYROL JAUME. ADM.CONCURS.: ACG SOCIEDAD PROFESIONALDE ABOGADOS AUDITORES Y E. Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTOABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 315/2015, AUTO FIRME DE FECHA 08/06/2015, DECLARACION DE CONCURSOVOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 44446 , F 211, S 8, H B 369720, I/A 10 (18.08.15).

16 de Diciembre de 2014
Cambio de domicilio social. CL MIQUEL SERVET,40-42, POL.INDUSTRIAL BUFALVENT (MANRESA). Datos registrales. T44446 , F 211, S 8, H B 369720, I/A 9 ( 4.12.14).

09 de Septiembre de 2014
Revocaciones. ADMINISTR.: MASSIMO SCATARREGGIA. Nombramientos. ADM.UNICO: RUIZ FAUSTO PEDRO ANTONIO.Datos registrales. T 40470 , F 139, S 8, H B 369720, I/A 7 ( 2.09.14).

Nombramientos. APODERAD.SOL: MASSIMO SCATTARREGGIA. Datos registrales. T 40470 , F 139, S 8, H B 369720, I/A 8 (2.09.14).

13 de Agosto de 2013
Nombramientos. APODERAD.SOL: ALCANTARA GARCIA MARIA VICTORIA. Datos registrales. T 40470 , F 138, S 8, H B 369720,I/A 6 ( 6.08.13).

01 de Agosto de 2012
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: RUIZ FAUSTO PEDRO ANTONIO. Datos registrales. T 40470 , F 138, S 8, H B 369720, I/A 5(19.07.12).

02 de Noviembre de 2011
Nombramientos. APODERADO: ARGUELLO CERVERA ERIKA. Datos registrales. T 40470 , F 137, S 8, H B 369720, I/A 4(21.10.11).

Nombramientos. APODERADO: KATJA SCATTARREGIA. Datos registrales. T 40470 , F 135, S 8, H B 369720, I/A 3 (21.10.11).

14 de Agosto de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 100.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 200.000,00 Euros. Datos registrales. T 40470 , F 135, S 8,H B 369720, I/A 2 ( 4.08.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n