Actos BORME de Industrial Carrocera Arbuciense Sa
23 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apoderado: FABIO PANNOLI. Datos registrales. T 3151 , F 52, S 8, H GI 11936, I/A 40 (17.11.23).
06 de Julio de 2022Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: MELANIE QUERALT MIRBELLE;GAEL QUERALT MIRBELLE. Nombramientos. Cons.Del.Sol:GAEL QUERALT MIRBELLE;MELANIE QUERALT MIRBELLE. Reelecciones. SecreNoConsj: CARLES FERNANDEZ SOTERAS.Vicepresid.: MELANIE QUERALT MIRBELLE. Consejero: MELANIE QUERALT MIRBELLE;JULIO GALAN ROMERO;FRANCOISEMIRBELLE;ROSA MARIA QUERALT MONFORTE. Presidente: GAEL QUERALT MIRBELLE. Consejero: GAEL QUERALT MIRBELLE.Datos registrales. T 3151 , F 52, S 8, H GI 11936, I/A 38 (29.06.22).
18 de Agosto de 2021Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 30潞 de los estatutos sociales. . Datos registrales. T 3151 , F 52, S 8, H GI11936, I/A 37 (11.08.21).
15 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: AUDITORIA I CONTROL AUDITORS SLP. Datos registrales. T 3151 , F 51, S 8, H GI 11936, I/A 36 (3.12.20).
16 de Agosto de 2018Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 968.086,70 Euros. Desembolsado: 968.086,70 Euros. Resultante Suscrito: 1.030.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.030.000,00 Euros. Datos registrales. T 3151 , F 51, S 8, H GI 11936, I/A 35 ( 7.08.18).
08 de Junio de 2018Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.803,30 Euros. Desembolsado: 1.803,30 Euros. Resultante Suscrito: 61.913,30 Euros. ResultanteDesembolsado: 61.913,30 Euros. Datos registrales. T 3151 , F 51, S 8, H GI 11936, I/A 34 (31.05.18).
29 de Septiembre de 2017Reelecciones. Auditor: AUDITORIA I CONTROL AUDITORS SLP. Datos registrales. T 3151 , F 51, S 8, H GI 11936, I/A 33(22.09.17).
18 de Julio de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: GAEL QUERALT MIRBELLE. Presidente: GAEL QUERALT MIRBELLE. Consejero: ROSA MARIAQUERALT MONFORTE. Vicepresid.: ROSA MARIA QUERALT MONFORTE. Consejero: JULIO GALAN ROMERO;FRANCOISEMIRBELLE;MELAINE QUERALT MIRBELLE. Cons.Del.Sol: GAEL QUERALT MIRBELLE;FRANCOISE MIRBELLE;ROSA MARIAQUERALT MONFORTE;JULIO GALAN ROMERO;MELAINE QUERALT MIRBELLE. Nombramientos. Consejero: GAEL QUERALTMIRBELLE;ROSA MARIA QUERALT MONFORTE;FRANCOISE MIRBELLE;JULIO GALAN ROMERO;MELANIE QUERALTMIRBELLE. Presidente: GAEL QUERALT MIRBELLE. Vicepresid.: MELANIE QUERALT MIRBELLE. Cons.Del.Sol: GAEL QUERALTMIRBELLE;MELANIE QUERALT MIRBELLE. Reelecciones. SecreNoConsj: CARLES FERNANDEZ SOTERAS. Ampliacion delobjeto social. Fabricaci贸n, montaje y reparaci贸n de toda clase de carrocer铆as, volquetes y similares, para todo tipo de veh铆culos; sucompraventa y comercializaci贸n. Alquiler de veh铆culos sin conductor y fabricaci贸n de autobuses en general. Datos registrales. T 617 ,F 181, S 8, H GI 11936, I/A 32 (11.07.17).
11 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: AUDITORIA I CONTROL AUDITORS SLP. Datos registrales. T 617 , F 181, S 8, H GI 11936, I/A 31 (2.12.14).
27 de Marzo de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: GAEL QUERALT MIRBELLE. Presidente: GAEL QUERALT MIRBELLE. Consejero: ROSA MARIAQUERALT MONFORTE. Vicepresid.: ROSA MARIA QUERALT MONFORTE. Consejero: JULIO GALAN ROMERO;FRANCOISEMIRBELLE;MELAINE QUERALT MIRBELLE. Cons.Del.Sol: GAEL QUERALT MIRBELLE;ROSA MARIA QUERALT
04 de Octubre de 2011Revocaciones. Apoderado: VICENTE MARTINEZ GARCIA;LUIS ANTONIO MARTINEZ LORENZO. Datos registrales. T 617 , F
Revocaciones. Apoderado: GARCIA LEDESMA PEDRO. Datos registrales. T 617 , F 181, S 8, H GI 11936, I/A 29 (22.09.11).
08 de Abril de 2011Reelecciones. Auditor: AUDITORIA I CONTROL AUDITORS SLP. Datos registrales. T 617 , F 181, S 8, H GI 11936, I/A 27(29.03.11).