Actos BORME de Industrias Carnicas Villar Sociedad Anonima
23 de Mayo de 2023Nombramientos. Apoderado: MARIA NIEVES VILLAR MIGUEL. Datos registrales. T 225, L 174, F 81, S 8, H SO 454, I/A 42(16.05.23).
10 de Mayo de 2023Revocaciones. Apoderado: FRANCISCO JAVIER GOMEZ PRIETO. Datos registrales. T 225, L 174, F 81, S 8, H SO 454, I/A 41 (4.05.23).
14 de Junio de 2022Nombramientos. Apoderado: FRANCISCO JAVIER GOMEZ PRIETO. Datos registrales. T 173, L 122, F 182, S 8, H SO 454, I/A 40( 7.06.22).
27 de Mayo de 2021Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL. Datos registrales. T 173, L 122, F 182, S 8, HSO 454, I/A 39 (20.05.21).
30 de Diciembre de 2020Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: MOORE STEPHENS LP SL. Nombramientos. Auditor: CGM AUDITORESSL. Datos registrales. T 173, L 122, F 182, S 8, H SO 454, I/A 38 (22.12.20).
16 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: FLORENTINO VILLAR MIGUEL;VILLAR GASSOL FLORENTINO;VILLAR MIGUEL MARIANIEVES;DANIEL DAVID VILLAR GASSOL;RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO. Presidente: VILLAR MIGUEL FLORENTINO.Vicepresid.: VILLAR GASSOL FLORENTINO. Secretario: VILLAR MIGUEL MARIA NIEVES. Con.Delegado: RODRIGUEZ GARCIAFERNANDO. Nombramientos. Adm. Unico: GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 173, L 122, F 177, S 8, H SO 454, I/A 35 (8.01.19).
Revocaciones. Apoderado: VILLAR MIGUEL FLORENTINO;RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO;VILLAR MIGUELFLORENTINO;VILLAR MIGUEL MARIA NIEVES. Apo.Sol.: VILLAR MIGUEL FLORENTINO;VILLAR MIGUEL MARIA NIEVES. Datosregistrales. T 173, L 122, F 181, S 8, H SO 454, I/A 36 ( 8.01.19).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 173, L 122, F 181, S 8, H SO 454, I/A 37 (8.01.19).
27 de Noviembre de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 54.805,19 Euros. Resultante Suscrito: 3.040.020,27 Euros. Datos registrales. T 173, L122, F 177, S 8, H SO 454, I/A 34 (20.11.18).
11 de Octubre de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 39.629,94 Euros. Resultante Suscrito: 3.094.825,46 Euros. Datos registrales. T 173, L122, F 176, S 8, H SO 454, I/A 33 ( 1.10.18).
03 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS LP SL. Datos registrales. T 173, L 122, F 176, S 8, H SO 454, I/A 32 (14.12.17).
29 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLAR HERNANDEZ ROGELIO. Presidente: VILLAR HERNANDEZ ROGELIO. Secretario: VILLARMIGUEL FLORENTINO. Con.Delegado: VILLAR HERNANDEZ ROGELIO. Nombramientos. Secretario: VILLAR MIGUEL MARIANIEVES. Presidente: VILLAR MIGUEL FLORENTINO. Reelecciones. Consejero: VILLAR MIGUEL FLORENTINO;VILLAR GASSOLFLORENTINO;VILLAR MIGUEL MARIA NIEVES;RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO;VILLAR GASSOL DANIEL. Vicepresid.: VILLARGASSOL FLORENTINO. Con.Delegado: RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 173, L 122, F 175, S 8, H SO 454,I/A 31 (20.07.16).
18 de Septiembre de 2014Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS LP SL. Datos registrales. T 173, L 122, F 175, S 8, H SO 454, I/A 30 (26.08.14).
18 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO. Reelecciones. Consejero: VILLAR HERNANDEZROGELIO. Presidente: VILLAR HERNANDEZ ROGELIO. Consejero: VILLAR MIGUEL FLORENTINO. Secretario: VILLAR MIGUELFLORENTINO. Consejero: VILLAR GASSOL FLORENTINO;VILLAR MIGUEL MARIA NIEVES;RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO.Con.Delegado: VILLAR HERNANDEZ ROGELIO. Consejero: VILLAR GASSOL DANIEL. Vicepresid.: VILLAR GASSOL FLORENTINO.Datos registrales. T 173, L 122, F 175, S 8, H SO 454, I/A 28 (30.07.14).
Nombramientos. Con.Delegado: RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 173, L 122, F 175, S 8, H SO 454, I/A 29(30.07.14).
26 de Junio de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: VILLAR MIGUEL FLORENTINO;VILLAR MIGUEL MARIA NIEVES. Datos registrales. T 173, L 122, F174, S 8, H SO 454, I/A 27 (11.06.14).
12 de Noviembre de 2012Modificaciones estatutarias. 10. Acciones/Participaciones.-. 10 bis. Acciones/Participaciones.-. 35. Otros.-. Datos registrales. T173, L 122, F 173, S 8, H SO 454, I/A 26 (10.10.12).
21 de Agosto de 2012Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS LP SL. Datos registrales. T 173, L 122, F 173, S 8, H SO 454, I/A 25 ( 3.08.12).
21 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 173, L 122, F 171, S 8, H SO 454, I/A 22(24.04.12).
Nombramientos. Apoderado: VILLAR MIGUEL FLORENTINO. Datos registrales. T 173, L 122, F 172, S 8, H SO 454, I/A 23(24.04.12).
Nombramientos. Apoderado: VILLAR MIGUEL MARIA NIEVES. Datos registrales. T 173, L 122, F 173, S 8, H SO 454, I/A 24(24.04.12).
02 de Noviembre de 2010Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: SABORES DE LA DEHESA SL. Datos registrales. T 173, L 122, F 171, S 8, H SO454, I/A 21 ( 1.10.10).
06 de Agosto de 2009Reelecciones. Consejero: VILLAR HERNANDEZ ROGELIO. Presidente: VILLAR HERNANDEZ ROGELIO. Consejero: VILLARMIGUEL FLORENTINO. Secretario: VILLAR MIGUEL FLORENTINO. Consejero: VILLAR GASSOL FLORENTINO;VILLAR MIGUELMARIA NIEVES;RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO. Con.Delegado: VILLAR HERNANDEZ ROGELIO. Consejero: VILLAR GASSOLDANIEL. Vicepresid.: VILLAR GASSOL FLORENTINO. Datos registrales. T 173, L 122, F 171, S 8, H SO 454, I/A 19 (17.07.09).
Reelecciones. Con.Delegado: RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 173, L 122, F 171, S 8, H SO 454, I/A 20(17.07.09).