Actos BORME de Industrias Del Fenar Sa
04 de Mayo de 2023Nombramientos. Apoderado: DIEZ VALCARCEL ELOY. Datos registrales. T 1259 , F 130, S 8, H LE 1686, I/A 101 (26.04.23).
04 de Febrero de 2022Revocaciones. Apoderado: PESQUERA MATEO MARIANO. Datos registrales. T 1259 , F 130, S 8, H LE 1686, I/A 100 (31.01.22).
04 de Agosto de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: AGUADO BURGAZ MANUEL-JUAN. Secretario: AGUADO BURGAZ MANUEL-JUAN. Cons.Del.Sol:AGUADO BURGAZ MANUEL-JUAN. Datos registrales. T 1259 , F 83, S 8, H LE 1686, I/A 98 (29.07.21).
Nombramientos. Consejero: AGUADO ROLANDI MANUEL. Secretario: AGUADO ROLANDI MANUEL. Cons.Del.Sol: AGUROLGESTION SL. Reelecciones. Presidente: TRABA AGUADO AVELINO. Cons.Del.Sol: TRABA AGUADO AVELINO. Datosregistrales. T 1259 , F 83, S 8, H LE 1686, I/A 99 (29.07.21).
15 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: PESQUERA MATEO MARIANO. Datos registrales. T 1259 , F 81, S 8, H LE 1686, I/A 96 ( 9.07.21).
Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ LLORENTE JORGE. Datos registrales. T 1259 , F 82, S 8, H LE 1686, I/A 97 ( 9.07.21).
28 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: DE POZUELO TRABA CRISTINA MARTIN;GARCIA PEREZ MIRIAM;VELASCO REYESVICTORIANO;ALVAREZ MACIA LUIS MIGUEL;ALONSO MARTIN MIGUEL ANGEL;TRABA ALVA MONICA PATRICIA. Datosregistrales. T 1259 , F 81, S 8, H LE 1686, I/A 95 (22.06.21).
07 de Abril de 2021Nombramientos. Consejero: AGUROL GESTION SL. Datos registrales. T 1258 , F 225, S 8, H LE 1686, I/A 93 (30.03.21).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 500.000,00 Euros. Desembolsado: 500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.184.040,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.184.040,00 Euros. Datos registrales. T 1259 , F 80, S 8, H LE 1686, I/A 94 (30.03.21).
24 de Diciembre de 2020Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: AUDILEX AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: CARRERO LANCHOAUDITORES SL. Datos registrales. T 1258 , F 225, S 8, H LE 1686, I/A 92 (18.12.20).
17 de Junio de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: BURGAZ RUIZ LEONOR. Datos registrales. T 1258 , F 224, S 8, H LE 1686, I/A 90 (11.06.20).
Cambio de domicilio social. C/ FONTANILLAS 5 - TROBAJO DEL CAMINO (SAN ANDRES DEL RABANEDO). Fe de erratas:Subsanado el error material producido en la escritura de cargos que origin贸 la inscripci贸n 87陋 en cuanto al D.N.I. del nombradoCONSEJERO de la Sociedad don AVELINO TRABA AGUADO, con D.N.I. n煤mero 50.396.902-C, cuando en realidad su n煤mero deD.N.I. es 50.396.907-C. Datos registrales. T 1258 , F 224, S 8, H LE 1686, I/A 91 (11.06.20).
26 de Diciembre de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.244.335,24 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:684.040,00 Euros. Desembolsado: 684.040,00 Euros. Resultante Suscrito: 684.040,00 Euros. Resultante Desembolsado: 684.040,00Euros. Datos registrales. T 1258 , F 218, S 8, H LE 1686, I/A 89 (19.12.19).
20 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: MANZANARES PLA-FONT JORGE. Presidente: MANZANARES PLA-FONT JORGE. SecreNoConsj:GALDOS MARTINEZ NATALIA. Nombramientos. Consejero: GRUPO EMPRESARIAL MAT SL. SecreNoConsj: AGUADO BURGAZMANUEL-JUAN. Presidente: GRUPO EMPRESARIAL MAT SL. Cons.Del.Sol: GRUPO EMPRESARIAL MAT SL;DIEZ VALCARCELELOY. Datos registrales. T 1258 , F 215, S 8, H LE 1686, I/A 86 (14.06.19).
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: AGUADO BURGAZ MANUEL-JUAN. Consejero: DIEZ VALCARCEL ELOY;DEL VALLE LOVELLEJOSE-MARIA. Vicepresid.: DEL VALLE LOVELLE JOSE-MARIA. Con.Delegado: DIEZ VALCARCEL ELOY. Consejero: GRUPOEMPRESARIAL MAT SL. Presidente: GRUPO EMPRESARIAL MAT SL. Cons.Del.Sol: GRUPO EMPRESARIAL MAT SL;DIEZVALCARCEL ELOY. Nombramientos. Consejero: TRABA AGUADO AVELINO. Presidente: TRABA AGUADO AVELINO. Consejero:AGUADO BURGAZ MANUEL-JUAN. Secretario: AGUADO BURGAZ MANUEL-JUAN. Cons.Del.Sol: TRABA AGUADOAVELINO;AGUADO BURGAZ MANUEL-JUAN. Consejero: TRABA AGUADO MARIA-CRISTINA;BURGAZ RUIZ LEONOR.Reelecciones. Auditor: AUDILEX AUDITORES SL. Datos registrales. T 1258 , F 216, S 8, H LE 1686, I/A 87 (14.06.19).
Nombramientos. Apoderado: DIEZ VALCARCEL ELOY. Datos registrales. T 1258 , F 217, S 8, H LE 1686, I/A 88 (14.06.19).
13 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: CEBALLOS PEREDA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 1258 , F 214, S 8, H LE 1686, I/A 84 (7.05.19).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.923.715,92 Euros. Desembolsado: 1.923.715,92 Euros. Resultante Suscrito: 2.244.335,24 Euros.Resultante Desembolsado: 2.244.335,24 Euros. Datos registrales. T 1258 , F 215, S 8, H LE 1686, I/A 85 ( 7.05.19).
08 de Octubre de 2018Reelecciones. Auditor: AUDILEX AUDITORES SL. Datos registrales. T 1258 , F 214, S 8, H LE 1686, I/A 83 ( 1.10.18).
22 de Noviembre de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.049.903,68 Euros. Resultante Suscrito: 320.619,32 Euros. Datos registrales. T 1258 , F89, S 8, H LE 1686, I/A 82 (15.11.17).
10 de Octubre de 2017Reelecciones. Auditor: AUDILEX AUDITORES SL. Datos registrales. T 1258 , F 89, S 8, H LE 1686, I/A 81 ( 3.10.17).
04 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: MANZANARES PLA-FONT JORGE;VALLE ALONSO MIGUEL DEL;DIEZ VALCARCEL ELOY.Con.Delegado: DIEZ VALCARCEL ELOY. Secretario: VALLE ALONSO MIGUEL DEL. Vicepresid.: MANZANARES PLA-FONTJORGE. Nombramientos. Consejero: MANZANARES PLA-FONT JORGE;DIEZ VALCARCEL ELOY;CEBALLOS PEREDA JOSE-LUIS;DEL VALLE LOVELLE JOSE-MARIA. Reelecciones. Auditor: AUDILEX AUDITORES SL. Otros conceptos: MODIFICACIONdel Art铆culo 18潞 de los Estatutos Sociales, relativo al n煤mero m铆nimo y m谩ximo de integrantes del Consejo de Administraci贸n.Establecimiento en CUATRO el n煤mero de miembros del Consejo de Administraci贸n,. Datos registrales. T 1258 , F 88, S 8, H LE1686, I/A 79 (28.12.16).
Nombramientos. Presidente: MANZANARES PLA-FONT JORGE. Vicepresid.: DEL VALLE LOVELLE JOSE-MARIA. SecreNoConsj:GALDOS MARTINEZ NATALIA. Con.Delegado: DIEZ VALCARCEL ELOY. Apo.Sol.: MANZANARES PLA-FONT JORGE;DEL VALLELOVELLE JOSE-MARIA. Apo.Manc.: MANZANARES PLA-FONT JORGE;DEL VALLE LOVELLE JOSE-MARIA. Datos registrales. T1258 , F 88, S 8, H LE 1686, I/A 80 (28.12.16).
05 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL VALLE RAMIREZ DE VERGER JOSE MANUEL;DIEZ-ROBLES FERNANDEZ JUANFRANCISCO. Presidente: DEL VALLE RAMIREZ DE VERGER JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1258 , F 87, S 8, H LE 1686, I/A78 (30.08.16).
15 de Junio de 2016Revocaciones. Apoderado: MORENO PEREZ ANA MARIA. Datos registrales. T 1258 , F 87, S 8, H LE 1686, I/A 77 ( 9.06.16).
26 de Abril de 2016Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 248.523,00 Euros. Desembolsado: 248.523,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.370.523,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.370.523,00 Euros. Datos registrales. T 1258 , F 86, S 8, H LE 1686, I/A 76 (19.04.16).
21 de Agosto de 2015Reelecciones. Auditor: AUDILEX AUDITORES SL. Otros conceptos: Constatacion del C贸digo CNAE de su actividad principal es el4941 Cambio del sistema retributivo del organo de administraci贸n y en consecuencia modificaci贸n del Articulo 24 de los EstatutosSociales. Datos registrales. T 1258 , F 85, S 8, H LE 1686, I/A 75 (14.08.15).
23 de Enero de 2015Revocaciones. Apoderado: GARCIA SANCHEZ JOSE-LUIS;GUTIERREZ MARTINEZ DANIEL;DEL VALLE ALONSO ANTONIO-JOSE Datos registrales. T 1258 , F 85, S 8, H LE 1686, I/A 74 (16.01.15).
06 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Presidente: DEL VALLE RAMIREZ DE VERGER JOSE MANUEL. Vicepresid.: MANZANARES PLA-FONTJORGE. Secretario: VALLE ALONSO MIGUEL DEL. Con.Delegado: DIEZ VALCARCEL ELOY. Nombramientos. Con.Delegado:DIEZ VALCARCEL ELOY. Secretario: VALLE ALONSO MIGUEL DEL. Presidente: DEL VALLE RAMIREZ DE VERGER JOSEMANUEL. Vicepresid.: MANZANARES PLA-FONT JORGE. Reelecciones. Consejero: DEL VALLE RAMIREZ DE VERGER JOSEMANUEL;MANZANARES PLA-FONT JORGE;VALLE ALONSO MIGUEL DEL;DIEZ-ROBLES FERNANDEZ JUAN FRANCISCO;DIEZVALCARCEL ELOY. Datos registrales. T 449 , F 129, S 8, H LE 1686, I/A 73 (30.07.13).
15 de Abril de 2013Nombramientos. Apoderado: MORENO PEREZ ANA MARIA. Datos registrales. T 449 , F 129, S 8, H LE 1686, I/A 72 ( 8.04.13).
31 de Diciembre de 2012Reelecciones. Auditor: AUDILEX AUDITORES SL. Otros conceptos: Se modifican los Art铆culos 1 y 6 de los EstatutosSociales,para sustituir las referencias a la Ley de Sociedades An贸nimas por referencias a la Ley de Sociedades de Capital.Se modificael Art铆culo 2 de los Estatutos Sociales que contempla la sede electr贸nica de la Sociedad y prevee la convocatoria de la Junta General atrav茅s de la p谩gina web.Se modifica elArt铆culo 22 de los Estatutos Sociales para adaptar a la Leyde Sociedades de Capital laconvocatoria del Consejo. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.fenar.com. Datos registrales.T 449 , F 128, S 8, H LE 1686, I/A 71 (21.12.12).
24 de Mayo de 2012Otros conceptos: Se sustituyen los dos mil t铆tulos representativos de las acciones actualmente existentes, mediante la emisi贸n deotros nuevos con el nuevo valor nominal de 561 euros por acci贸n.Identificaci贸n por la notario de La Robla -Le贸n- do帽a LAURAGARCIAVILLAR de las firmas de los Consejeros don JOSE-MANUEL DEL VALLE RAMIREZ DE VERGER y don ELOY DIEZ VALCARCEL,reproducidas mec谩nicamente en los nuevos t铆tulos (Art. 137 R.R.M.). Datos registrales. T 449 , F 127, S 8, H LE 1686, I/A 70(15.05.12).
14 de Septiembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.001.800,00 Euros. Desembolsado: 1.001.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.122.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.122.000,00 Euros. Datos registrales. T 449 , F 127, S 8, H LE 1686, I/A 69 ( 2.09.11).
31 de Agosto de 2009Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: AUDILEX AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: AUDILEXAUDITORES SL. Datos registrales. T 449 , F 127, S 8, H LE 1686, I/A 68 (20.08.09).