Buscador CIF Logo

Actos BORME Industrias Hidraulicas Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Industrias Hidraulicas Sa

Actos BORME Industrias Hidraulicas Sa - A99329328

Tenemos registrados 17 Actos BORME del Registro Mercantil de Zaragoza para Industrias Hidraulicas Sa con CIF A99329328

馃敊 Perfil de Industrias Hidraulicas Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Zaragoza

Actos BORME de Industrias Hidraulicas Sa

09 de Octubre de 2023
Reelecciones. Consejero: CLAVEL GUALLAR MIGUEL ANGEL;CLAVEL GUALLAR MARIA CONCEPCION. Presidente: CLAVELGUALLAR MIGUEL ANGEL. Secretario: CLAVEL GUALLAR MARIA CONCEPCION. Con.Delegado: CLAVEL GUALLAR MIGUELANGEL. Datos registrales. T 3880 , F 202, S 8, H Z 52561, I/A 12 ( 2.10.23).

25 de Noviembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: CLAVEL GUALLAR JOSE CLEMENTE;GUALLAR GRACIA CECILIA. Vicepresid.: CLAVEL GUALLARJOSE CLEMENTE. Nombramientos. Consejero: CLAVEL HERNANDO JOSE ANTONIO;ORNA ASENSIO JOSE MARIA. Datos

15 de Febrero de 2021
Nombramientos. Auditor: POSTIGO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3880 , F 202, S 8, H Z 52561, I/A 10 ( 8.02.21).

24 de Enero de 2020
Revocaciones. Apoderado: CLAVEL HERNANDO MARIA-CECILIA. Datos registrales. T 3880 , F 201, S 8, H Z 52561, I/A 7(17.01.20).

Nombramientos. Apoderado: ESTEBAN SIERRA DANIEL. Datos registrales. T 3880 , F 201, S 8, H Z 52561, I/A 8 (17.01.20).

Nombramientos. Consejero: CLAVEL CONGET MARCOS MIGUEL. Datos registrales. T 3880 , F 201, S 8, H Z 52561, I/A 9(17.01.20).

13 de Febrero de 2018
Nombramientos. Auditor: MAYNE AND WORD SLP. Datos registrales. T 3880 , F 200, S 8, H Z 52561, I/A 6 ( 7.02.18).

07 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: CLAVEL GUALLAR MIGUEL ANGEL. Presidente: CLAVEL GUALLAR MIGUEL ANGEL. Consejero:CLAVEL GUALLAR JOSE CLEMENTE. Vicepresid.: CLAVEL GUALLAR JOSE CLEMENTE. Consejero: CLAVEL GUALLAR MARIACONCEPCION. Secretario: CLAVEL GUALLAR MARIA CONCEPCION. Consejero: GUALLAR GRACIA CECILIA. Con.Delegado:CLAVEL GUALLAR MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: CLAVEL GUALLAR MIGUEL ANGEL;CLAVEL GUALLAR JOSECLEMENTE;CLAVEL GUALLAR MARIA CONCEPCION;GUALLAR GRACIA CECILIA. Presidente: CLAVEL GUALLAR MIGUELANGEL. Vicepresid.: CLAVEL GUALLAR JOSE CLEMENTE. Secretario: CLAVEL GUALLAR MARIA CONCEPCION. Con.Delegado:CLAVEL GUALLAR MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 3880 , F 200, S 8, H Z 52561, I/A 5 (28.11.17).

11 de Febrero de 2015
Reelecciones. Auditor: MAYNE AND WORD SLP. Datos registrales. T 3880 , F 200, S 8, H Z 52561, I/A 4 ( 2.02.15).

25 de Septiembre de 2012
Nombramientos. Auditor: MAYNE AND WORD SLP. Datos registrales. T 3880 , F 200, S 8, H Z 52561, I/A 3 (14.09.12).

20 de Abril de 2012
Nombramientos. Apoderado: CLAVEL HERNANDO MARIA-CECILIA. Datos registrales. T 3880 , F 199, S 8, H Z 52561, I/A 2(11.04.12).

11 de Enero de 2012
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 3.11.11. Objeto social: Fabricaci贸n, reparaci贸n y venta de maquinaria de cualquier clase. Lacomercializaci贸n de maquinaria y accesorios. El objeto social podr谩 ser desarrollado total o parcialmente, mediante la titularidad deacciones o participaciones sociales en otras Sociedades de id茅ntico o an谩logo objeto. Para poder. Domicilio: POLIG INDUSTRIALMALPICA. CALLE E 54 (ZARAGOZA). Capital suscrito: 5.459.303,70 Euros. Desembolsado: 5.459.303,70 Euros. Nombramientos.Consejero: CLAVEL GUALLAR MIGUEL ANGEL. Presidente: CLAVEL GUALLAR MIGUEL ANGEL. Consejero: CLAVEL GUALLARJOSE CLEMENTE. Vicepresid.: CLAVEL GUALLAR JOSE CLEMENTE. Consejero: CLAVEL GUALLAR MARIA CONCEPCION.Secretario: CLAVEL GUALLAR MARIA CONCEPCION. Consejero: GUALLAR GRACIA CECILIA. Con.Delegado: CLAVEL GUALLARMIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 3880 , F 197, S 8, H Z 52561, I/A 1 (30.12.11).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CLAVEL GUALLAR MIGUEL ANGEL. Presidente: CLAVEL GUALLAR MIGUEL ANGEL.Con.Delegado: CLAVEL GUALLAR MIGUEL ANGEL. Consejero: CLAVEL GUALLAR JOSE CLEMENTE. Vicepresid.: CLAVELGUALLAR JOSE CLEMENTE. Consejero: CLAVEL GUALLAR MARIA CONCEPCION. Secretario: CLAVEL GUALLAR MARIACONCEPCION. Consejero: GUALLAR GRACIA CECILIA. Revocaciones. Apoderado: CLAVEL GUALLAR JOSECLEMENTE;CLAVEL GUALLAR MIGUEL ANGEL;CLAVEL GUALLAR MIGUEL ANGEL;CLAVEL HERNANDO MARIA-CECILIA.Escisi贸n total. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: INDUSTRIAS HIDRAULICAS SA. SALDUVIA INVERSIONES SL.Extinci贸n. Datos registrales. T 3566 , F 109, S 8, H Z 9245, I/A 23 (30.12.11).

21 de Noviembre de 2011
Reelecciones. Auditor: MAYNE AND WORD SL. Datos registrales. T 3566 , F 108, S 8, H Z 9245, I/A 22 (10.11.11).

05 de Enero de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: CLAVEL GUALLAR MIGUEL ANGEL. Presidente: CLAVEL GUALLAR MIGUEL ANGEL. Consejero:CLAVEL GUALLAR JOSE CLEMENTE;CLAVEL GUALLAR MARIA CONCEPCION. Vicepresid.: CLAVEL GUALLAR JOSECLEMENTE. Secretario: CLAVEL GUALLAR MARIA CONCEPCION. Cons.Del.Sol: CLAVEL GUALLAR MIGUEL ANGEL. Consejero:GUALLAR GRACIA CECILIA. Nombramientos. Consejero: CLAVEL GUALLAR MIGUEL ANGEL. Presidente: CLAVEL GUALLARMIGUEL ANGEL. Con.Delegado: CLAVEL GUALLAR MIGUEL ANGEL. Consejero: CLAVEL GUALLAR JOSE CLEMENTE.Vicepresid.: CLAVEL GUALLAR JOSE CLEMENTE. Consejero: CLAVEL GUALLAR MARIA CONCEPCION. Secretario: CLAVELGUALLAR MARIA CONCEPCION. Consejero: GUALLAR GRACIA CECILIA. Datos registrales. T 3566 , F 108, S 8, H Z 9245, I/A 21(24.12.10).

12 de Agosto de 2009
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 12.230,35 Euros. Resultante Suscrito: 303.294,65 Euros. Datos registrales. T 3566 , F108, S 8, H Z 9245, I/A 20 ( 3.08.09).

23 de Enero de 2009
Nombramientos. Auditor: MAYNE AND WORD SL. Datos registrales. T 3566 , F 108, S 8, H Z 9245, I/A 19 (13.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n