Actos BORME de Industrias Kolmer Sa
08 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ CONTRERAS JOSE MARIA;CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS;RUIZ CONTRERASANGEL.Secretario: RUIZ CONTRERAS JOSE MARIA. Presidente: CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Con.Delegado:CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Vicepresid.: RUIZ CONTRERAS ANGEL. Nombramientos. Vicepresid.: RUIZCONTRERAS ANGEL. Consejero: RUIZ VICO JOAQUIN;RUIZ CONTRERAS ANGEL;RUIZ CONTRERAS JOSE MARIA. Presidente:RUIZ VICO JOAQUIN. Secretario: RUIZ CONTRERAS JOSE MARIA. Con.Delegado: RUIZ CONTRERAS JOSE MARIA. Datosregistrales. T 1634 , F 44, S 8, H GR 1945, I/A 57 (29.10.21).
15 de Octubre de 2021Revocaciones. Apoderado: MAROTO RAMIREZ JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 1634 , F 44, S 8, H GR 1945, I/A 56 (8.10.21).
19 de Septiembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ CONTRERAS ANGEL;MAROTO RAMIREZ JUAN ANTONIO;RUIZ CONTRERAS JOSEMARIA;BUENO TOSCA EVA MARIA;CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Presidente: CONTRERAS MOLINA MARIAANGUSTIAS. Vicepresid.: RUIZ CONTRERAS ANGEL. Secretario: BUENO TOSCA EVA MARIA. Con.Delegado: CONTRERASMOLINA MARIA ANGUSTIAS. Nombramientos. Consejero: CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS;RUIZ CONTRERASANGEL;RUIZ CONTRERAS JOSE MARIA.Presidente: CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Secretario: RUIZ CONTRERASJOSE MARIA. Vicepresid.: RUIZ CONTRERAS ANGEL. Con.Delegado: CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Modificacionesestatutarias. Se crea el art. 4潞bis y se modifica el art. 11潞 estatutario a fin de establecer la existencia de convocatoria por la webcorporativa. Se modifica el art. 17潞 a fin de establecer el caracter retribuido del organo de administraci贸n y se deroga el art. 28潞estatuario. Datos registrales. T 1634 , F 43, S 8, H GR 1945, I/A 55 (12.09.19).
25 de Septiembre de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 33.894,00 Euros. Resultante Suscrito: 746.106,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importereducci贸n: 552.862,00 Euros. Resultante Suscrito: 193.244,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 552.862,00 Euros.Desembolsado: 552.862,00 Euros. Resultante Suscrito: 746.106,00 Euros. Resultante Desembolsado: 746.106,00 Euros. Otrosconceptos: La reducci贸n de capital se efectua mediante la amortizaci贸n de 5.649 acciones propias de 6 Euros de valor nominal cadauna. Escisi贸n parcial. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: KOLMER PROPERTIES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales.T 1113 , F 34, S 8, H GR 1945, I/A 52 (14.09.17).
Ceses/Dimisiones. Consejero: BUENO TOSCA EVA MARIA;RUIZ VICO JOAQUIN;CONTRERAS MOLINA MARIAANGUSTIAS;MAROTO RAMIREZ JUAN ANTONIO;RUIZ CONTRERAS ANGEL;RUIZ CONTRERAS JOSE MARIA. Presidente: RUIZVICO JOAQUIN. Cons.Del.Sol: RUIZ VICO JOAQUIN;CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Secretario: BUENO TOSCA EVAMARIA. Vicepresid.: CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Nombramientos. Consejero: RUIZ CONTRERASANGEL;MAROTO RAMIREZ JUAN ANTONIO;RUIZ CONTRERAS JOSE MARIA;BUENO TOSCA EVA MARIA;CONTRERAS MOLINAMARIA ANGUSTIAS. Presidente: CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Vicepresid.: RUIZ CONTRERAS ANGEL. Secretario:BUENO TOSCA EVA MARIA. Con.Delegado: CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Datos registrales. T 1113 , F 35, S 8, HGR 1945, I/A 53 (14.09.17).
Cambio de objeto social. La fabricaci贸n, el comercio al por mayor y/o menor, la distribuci贸n y aplicacion de todo tipo de pinturas,barnices y revestimientos. Datos registrales. T 1113 , F 35, S 8, H GR 1945, I/A 54 (14.09.17).
27 de Mayo de 2016Ampliacion del objeto social. Promoci贸n, construcci贸n y comercializaci贸n de obras. La compra, venta y arrendamiento de inmueblesy de terrenos r煤sticos y urbanos. Datos registrales. T 1113 , F 34, S 8, H GR 1945, I/A 51 (23.05.16).
23 de Diciembre de 2015Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: GESLOCAL AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: MARTINCASTELLANO R. A AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1113 , F 33, S 8, H GR 1945, I/A 50 (16.12.15).
13 de Septiembre de 2012Reelecciones. Auditor: GESLOCAL AUDITORES SL. Datos registrales. T 1113 , F 33, S 8, H GR 1945, I/A 49 ( 5.09.12).
01 de Agosto de 2012Reelecciones. Consejero: BUENO TOSCA EVA MARIA;RUIZ VICO JOAQUIN;CONTRERAS MOLINA MARIAANGUSTIAS;MAROTO RAMIREZ JUAN ANTONIO;RUIZ CONTRERAS ANGEL;RUIZ CONTRERAS JOSE MARIA. Presidente: RUIZVICO JOAQUIN. Cons.Del.Sol: RUIZ VICO JOAQUIN;CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Secretario: BUENO TOSCA EVAMARIA. Vicepresid.: CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Datos registrales. T 1113 , F 33, S 8, H GR 1945, I/A 48(20.07.12).
28 de Febrero de 2012Modificaciones estatutarias. ARTICULO 17. Modificado en el sentido de que los consejerospodr谩n desempe帽ar cualquier actividadlaboral para la sociedad, que ser谩 retribuida en funci贸n de la categor铆a y funciones que desempe帽en. Datos registrales. T 1113 , F33, S 8, H GR 1945, I/A 47 (17.02.12).
19 de Julio de 2011Nombramientos. Apoderado: RUIZ CONTRERAS ANGEL. Datos registrales. T 1113 , F 32, S 8, H GR 1945, I/A 46 ( 8.07.11).
18 de Junio de 2010Nombramientos. Apoderado: RUIZ CONTRERAS JOSE MARIA. Datos registrales. T 1113 , F 32, S 8, H GR 1945, I/A 45 (9.06.10).
04 de Enero de 2010Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: DE ECHEGARAY DEL CAMPO FRANCISCO JAVIER. Aud.Supl.:FERNANDEZ CLARES ANTONIO. Nombramientos. Auditor: GESLOCAL AUDITORES SL. Datos registrales. T 1113 , F 31, S 8, HGR 1945, I/A 44 (22.12.09).