Buscador CIF Logo

Actos BORME Industrias Kolmer Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Industrias Kolmer Sa

Actos BORME Industrias Kolmer Sa - A18006569

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Granada para Industrias Kolmer Sa con CIF A18006569

馃敊 Perfil de Industrias Kolmer Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Granada

Actos BORME de Industrias Kolmer Sa

08 de Noviembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ CONTRERAS JOSE MARIA;CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS;RUIZ CONTRERASANGEL.Secretario: RUIZ CONTRERAS JOSE MARIA. Presidente: CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Con.Delegado:CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Vicepresid.: RUIZ CONTRERAS ANGEL. Nombramientos. Vicepresid.: RUIZCONTRERAS ANGEL. Consejero: RUIZ VICO JOAQUIN;RUIZ CONTRERAS ANGEL;RUIZ CONTRERAS JOSE MARIA. Presidente:RUIZ VICO JOAQUIN. Secretario: RUIZ CONTRERAS JOSE MARIA. Con.Delegado: RUIZ CONTRERAS JOSE MARIA. Datosregistrales. T 1634 , F 44, S 8, H GR 1945, I/A 57 (29.10.21).

15 de Octubre de 2021
Revocaciones. Apoderado: MAROTO RAMIREZ JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 1634 , F 44, S 8, H GR 1945, I/A 56 (8.10.21).

19 de Septiembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ CONTRERAS ANGEL;MAROTO RAMIREZ JUAN ANTONIO;RUIZ CONTRERAS JOSEMARIA;BUENO TOSCA EVA MARIA;CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Presidente: CONTRERAS MOLINA MARIAANGUSTIAS. Vicepresid.: RUIZ CONTRERAS ANGEL. Secretario: BUENO TOSCA EVA MARIA. Con.Delegado: CONTRERASMOLINA MARIA ANGUSTIAS. Nombramientos. Consejero: CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS;RUIZ CONTRERASANGEL;RUIZ CONTRERAS JOSE MARIA.Presidente: CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Secretario: RUIZ CONTRERASJOSE MARIA. Vicepresid.: RUIZ CONTRERAS ANGEL. Con.Delegado: CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Modificacionesestatutarias. Se crea el art. 4潞bis y se modifica el art. 11潞 estatutario a fin de establecer la existencia de convocatoria por la webcorporativa. Se modifica el art. 17潞 a fin de establecer el caracter retribuido del organo de administraci贸n y se deroga el art. 28潞estatuario. Datos registrales. T 1634 , F 43, S 8, H GR 1945, I/A 55 (12.09.19).

25 de Septiembre de 2017
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 33.894,00 Euros. Resultante Suscrito: 746.106,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importereducci贸n: 552.862,00 Euros. Resultante Suscrito: 193.244,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 552.862,00 Euros.Desembolsado: 552.862,00 Euros. Resultante Suscrito: 746.106,00 Euros. Resultante Desembolsado: 746.106,00 Euros. Otrosconceptos: La reducci贸n de capital se efectua mediante la amortizaci贸n de 5.649 acciones propias de 6 Euros de valor nominal cadauna. Escisi贸n parcial. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: KOLMER PROPERTIES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales.T 1113 , F 34, S 8, H GR 1945, I/A 52 (14.09.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BUENO TOSCA EVA MARIA;RUIZ VICO JOAQUIN;CONTRERAS MOLINA MARIAANGUSTIAS;MAROTO RAMIREZ JUAN ANTONIO;RUIZ CONTRERAS ANGEL;RUIZ CONTRERAS JOSE MARIA. Presidente: RUIZVICO JOAQUIN. Cons.Del.Sol: RUIZ VICO JOAQUIN;CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Secretario: BUENO TOSCA EVAMARIA. Vicepresid.: CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Nombramientos. Consejero: RUIZ CONTRERASANGEL;MAROTO RAMIREZ JUAN ANTONIO;RUIZ CONTRERAS JOSE MARIA;BUENO TOSCA EVA MARIA;CONTRERAS MOLINAMARIA ANGUSTIAS. Presidente: CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Vicepresid.: RUIZ CONTRERAS ANGEL. Secretario:BUENO TOSCA EVA MARIA. Con.Delegado: CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Datos registrales. T 1113 , F 35, S 8, HGR 1945, I/A 53 (14.09.17).

Cambio de objeto social. La fabricaci贸n, el comercio al por mayor y/o menor, la distribuci贸n y aplicacion de todo tipo de pinturas,barnices y revestimientos. Datos registrales. T 1113 , F 35, S 8, H GR 1945, I/A 54 (14.09.17).

27 de Mayo de 2016
Ampliacion del objeto social. Promoci贸n, construcci贸n y comercializaci贸n de obras. La compra, venta y arrendamiento de inmueblesy de terrenos r煤sticos y urbanos. Datos registrales. T 1113 , F 34, S 8, H GR 1945, I/A 51 (23.05.16).

23 de Diciembre de 2015
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: GESLOCAL AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: MARTINCASTELLANO R. A AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1113 , F 33, S 8, H GR 1945, I/A 50 (16.12.15).

13 de Septiembre de 2012
Reelecciones. Auditor: GESLOCAL AUDITORES SL. Datos registrales. T 1113 , F 33, S 8, H GR 1945, I/A 49 ( 5.09.12).

01 de Agosto de 2012
Reelecciones. Consejero: BUENO TOSCA EVA MARIA;RUIZ VICO JOAQUIN;CONTRERAS MOLINA MARIAANGUSTIAS;MAROTO RAMIREZ JUAN ANTONIO;RUIZ CONTRERAS ANGEL;RUIZ CONTRERAS JOSE MARIA. Presidente: RUIZVICO JOAQUIN. Cons.Del.Sol: RUIZ VICO JOAQUIN;CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Secretario: BUENO TOSCA EVAMARIA. Vicepresid.: CONTRERAS MOLINA MARIA ANGUSTIAS. Datos registrales. T 1113 , F 33, S 8, H GR 1945, I/A 48(20.07.12).

28 de Febrero de 2012
Modificaciones estatutarias. ARTICULO 17. Modificado en el sentido de que los consejerospodr谩n desempe帽ar cualquier actividadlaboral para la sociedad, que ser谩 retribuida en funci贸n de la categor铆a y funciones que desempe帽en. Datos registrales. T 1113 , F33, S 8, H GR 1945, I/A 47 (17.02.12).

19 de Julio de 2011
Nombramientos. Apoderado: RUIZ CONTRERAS ANGEL. Datos registrales. T 1113 , F 32, S 8, H GR 1945, I/A 46 ( 8.07.11).

18 de Junio de 2010
Nombramientos. Apoderado: RUIZ CONTRERAS JOSE MARIA. Datos registrales. T 1113 , F 32, S 8, H GR 1945, I/A 45 (9.06.10).

04 de Enero de 2010
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: DE ECHEGARAY DEL CAMPO FRANCISCO JAVIER. Aud.Supl.:FERNANDEZ CLARES ANTONIO. Nombramientos. Auditor: GESLOCAL AUDITORES SL. Datos registrales. T 1113 , F 31, S 8, HGR 1945, I/A 44 (22.12.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n