Actos BORME de Industrias Tecnologicas De Mecanizacion Y Automatizacion Sa
17 de Abril de 2023Nombramientos. AUDIT.CUENT.: UHY FAY&CO AUDITORES Y ASESORES SLP. Datos registrales. T 42876 , F 8, S 8, H B133957, I/A 27 ( 5.04.23).
12 de Julio de 2021Revocaciones. ADM.UNICO: MIRTHA DEVELOPMENT SL. REPR.143 RRM: RIOS LOPEZ AMALIA. Nombramientos.CONSEJERO: GONZALEZ COFRECES MANUEL. APOD.SOL/MAN: GONZALEZ COFRECES MANUEL. CONSEJERO: GONZALEZPORTERO ANA;THOMAS BECKER. PRESIDENTE: THOMAS BECKER. APOD.MANCOMU: THOMAS BECKER. CONSEJERO:SERGIO MARZO;BERND GERHARD SCHOBER. SECR.NO CONS: POCH BASAS LAIA. Modificaciones estatutarias.MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 9 BIS, 13, 23, 25 Y 28 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y ADICION DEL ARTICULO 18 BIS ALOS MISMOS. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO. Datos registrales. T 42876 , F 5, S 8, H B 133957, I/A 26 (30.06.21).
21 de Diciembre de 2020Nombramientos. AUDIT.CUENT.: UHY FAY&CO AUDITORES Y ASESORES SLP. Datos registrales. T 42876 , F 5, S 8, H B133957, I/A 25 (14.12.20).
05 de Noviembre de 2020Modificaciones estatutarias. ART.7.- CONVERSION DE LAS ACCIONES EN ACCIONES NOMINATIVAS. MODIFICACION ART.19Y ADICION ART.9 BIS. Datos registrales. T 42876 , F 5, S 8, H B 133957, I/A 24 (28.10.20).
07 de Octubre de 2019Revocaciones. ADM.UNICO: RIOS LOPEZ AMALIA. Nombramientos. ADM.UNICO: MIRTHA DEVELOPMENT SL. REPR.143RRM: RIOS LOPEZ AMALIA. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 16.251,04 Euros. Desembolsado: 16.251,04 Euros. ResultanteSuscrito: 81.279,24 Euros. Resultante Desembolsado: 81.279,24 Euros. Datos registrales. T 42876 , F 4, S 8, H B 133957, I/A 23(27.09.19).
24 de Abril de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 37.141,80 Euros. Resultante Suscrito: 65.028,20 Euros. Datos registrales. T 42876 , F 4,S 8, H B 133957, I/A 22 (16.04.18).
02 de Febrero de 2018Nombramientos. AUDIT.CUENT.: UHY FAY&CO AUDITORES Y ASESORES SLP. Datos registrales. T 42876 , F 3, S 8, H B133957, I/A 21 (26.01.18).
22 de Febrero de 2016Modificaciones estatutarias. ARTICULO 28: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datosregistrales. T 42876 , F 3, S 8, H B 133957, I/A 20 (11.02.16).
09 de Diciembre de 2013Revocaciones. ADM.UNICO: OLIVER JOHANNES VAN OORSCHOT. Nombramientos. ADM.UNICO: RIOS LOPEZ AMALIA.Datos registrales. T 42876 , F 3, S 8, H B 133957, I/A 19 (29.11.13).
13 de Marzo de 2013Revocaciones. ADM.UNICO: CANOS VIDRE JUAN. Nombramientos. ADM.UNICO: OLIVER JOHANNES VAN OORSCHOT.Datos registrales. T 42876 , F 3, S 8, H B 133957, I/A 18 ( 4.03.13).
29 de Junio de 2012Nombramientos. APODERADO: COLLADO CAPARROS ELISABET. Datos registrales. T 42876 , F 1, S 8, H B 133957, I/A 17(19.06.12).
19 de Abril de 2012Revocaciones. APODERADO: CANOS LUMBRERAS OSCAR. Datos registrales. T 42876 , F 1, S 8, H B 133957, I/A 16 (10.04.12).
14 de Diciembre de 2011Nombramientos. ADM.UNICO: CANOS VIDRE JUAN. Datos registrales. T 28368 , F 225, S 8, H B 133957, I/A 15 (30.11.11).
30 de Marzo de 2011Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 8 BARCELONA, PROC.ORDINARIO 288/2010,PARTE DEMANDANTE JOSE MANUELDOUTON CARREIRA, SENTENCIA FIRME DE13 DE JULIO DE 2010, DECLARA NULIDAD JUNTA 15 DE ENERO DE 2010(CANCELACION DEPOSITO DE CUENTAS EJERCICIO 2008). Datos registrales. T 28368 , F 225, S 8, H B 133957, I/A 14(15.03.11).
02 de Septiembre de 2010Modificaciones estatutarias. MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. TRANSFORMACION DELCARACTER DE LAS ACCIONES DE NOMINATIVAS AL PORTADOR. Datos registrales. T 28368 , F 222, S 8, H B 133957, I/A 13(19.08.10).
14 de Diciembre de 2009Revocaciones. APODERADO: DOUTON CARREIRA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 28368 , F 222, S 8, H B 133957, I/A 11 (1.12.09).
Nombramientos. APODERADO: CANOS LUMBRERAS OSCAR. Datos registrales. T 28368 , F 222, S 8, H B 133957, I/A 12 (1.12.09).