Actos BORME de Industrias Y Almacenes Pablos Sa
06 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 42517 , F 63, S 8, H M88575, I/A 109 (27.10.23).
11 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ SANCHEZ FERNANDO. Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 103陋 larevocaci贸n del poder otorgado por la 93陋 a CARNICER GARCIA CESAR LUIS, siendo lo correcto la revocaci贸n del poder otorgado aALVAREZ SANCHEZ FERNANDO por la 85陋. Datos registrales. T 11997 , F 225, S 8, H M 88575, I/A 103 (19.10.21).
25 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 42517 , F 63, S 8, H M88575, I/A 108 (18.11.22).
21 de Abril de 2022Ceses/Dimisiones. Presidente: TAUT SL. Vicepresid.: DEVON HOLDING SL. Consejero: DEVON HOLDING SL;TAUT SL;GOMEZPESO IGNACIO. Secretario: GOMEZ PESO IGNACIO. Presidente: DEVON HOLDING SL. Vicepresid.: TAUT SL. Representan:PABLOS ALONSO EZEQUIEL;PABLOS ALONSO FERNANDO. Nombramientos. Consejero: DEVON HOLDING SL. Presidente:DEVON HOLDING SL. Consejero: TAUT SL. Presidente: TAUT SL. Vicepresid.: TAUT SL;DEVON HOLDING SL. Consejero: PABLOSGARCIA JORGE;HERNANDEZ MARCOS FRANCISCO;LAZARO GONZALEZ JUAN CELESTINO. Representan: PABLOS ALONSOEZEQUIEL;PABLOS ALONSO FERNANDO. SecreNoConsj: ARGUELLO ALVAREZ LUIS. Datos registrales. T 42517 , F 62, S 8, HM 88575, I/A 107 (12.04.22).
21 de Febrero de 2022Modificaciones estatutarias. INCLUSION DEL ARTICULO 15 BIS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y MODIFICACION DELARTICULO 23 DE LOS ESTATUTOS. Datos registrales. T 42517 , F 61, S 8, H M 88575, I/A 106 (14.02.22).
27 de Octubre de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 11997 , F 225, S 8, H M88575, I/A 104 (20.10.21).
Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ PEREZ BEGO脩A;SERRANO LUIS ROBERTO;MARTINEZ DIEZ RUBEN. Datosregistrales. T 11997 , F 225, S 8, H M 88575, I/A 105 (20.10.21).
26 de Octubre de 2021Revocaciones. Apoderado: CARNICER GARCIA CESAR LUIS. Datos registrales. T 11997 , F 225, S 8, H M 88575, I/A 103(19.10.21).
18 de Agosto de 2020Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 11997 , F 225, S 8, H M88575, I/A 102 (11.08.20).
09 de Marzo de 2020Nombramientos. Consejero: GOMEZ PESO IGNACIO. Secretario: GOMEZ PESO IGNACIO. Datos registrales. T 11997 , F 224, S8, H M 88575, I/A 101 ( 2.03.20).
26 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: LUMBRERAS DE AZANZA JUAN CARLOS. Secretario: LUMBRERAS DE AZANZA JUAN CARLOS.Datos registrales. T 11997 , F 224, S 8, H M 88575, I/A 100 (18.12.19).
21 de Agosto de 2019Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 11997 , F 224, S 8, H M88575, I/A 99 (13.08.19).
22 de Febrero de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: TAUT SL;DEVON HOLDING SL. Representan: PABLOS ALONSO FERNANDO;PABLOS
21 de Noviembre de 2018Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 11997 , F 222, S 8, H M88575, I/A 97 (13.11.18).
17 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 11997 , F 222, S 8, H M88575, I/A 96 ( 9.01.18).
17 de Agosto de 2017Revocaciones. Apoderado: SANTAMARIA DEL REY PRUDENCIO. Datos registrales. T 11997 , F 221, S 8, H M 88575, I/A 95 (9.08.17).
21 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: CARNICER GARCIA CESAR LUIS. Datos registrales. T 11997 , F 220, S 8, H M 88575, I/A 93(12.07.17).
Revocaciones. Apoderado: BASCU脩AN HERRERA LUIS NICOLAS. Datos registrales. T 11997 , F 221, S 8, H M 88575, I/A 94(12.07.17).
09 de Enero de 2017Revocaciones. Apoderado: PABLOS ALONSO EZEQUIEL. Datos registrales. T 11997 , F 219, S 8, H M 88575, I/A 92 (29.12.16).
04 de Octubre de 2016Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 11997 , F 219, S 8, H M88575, I/A 91 (22.09.16).
13 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apoderado: BASCU脩AN HERRERA LUIS NICOLAS. Datos registrales. T 11997 , F 218, S 8, H M 88575, I/A 90 (2.09.16).
26 de Mayo de 2016Otros conceptos: LUIS NICOLAS BASCU脩AN HERRERA RENUNCIA A LOS PODERES QUE LE FUERON CONFERIDOSMEDIANTE ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 85&. Datos registrales. T 11997 , F 218, S 8, H M 88575, I/A 89(18.05.16).
07 de Septiembre de 2015Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 11997 , F 217, S 8, H M88575, I/A 88 (21.08.15).
12 de Agosto de 2015Revocaciones. Apoderado: BECERRA AMOR ANGEL MIGUEL;DIEZ MARTINEZ ANGEL;FERNANDEZ DIEZ JUAN JOSE;JIMENEZMORAL FRANCISCO;SABADELL CUETO MANRIQUE;SANTAMARIA REY PRUDENCIO;TEJERINA GARCIA EUGENIOJULIAN;BASCU脩AN HERRERA LUIS NICOLAS;DIEZ RAMOS HILARIO;CEPEDA DOMINGUEZ ANGEL JOSE. Otros conceptos:REVOCADOS PODERES CONFERIDOS A FAVOR DE DON LUIS BASCU脩AN HERRERA, DON PRUDENCIO SANTAMARIA REY YDON MAXIMO RAMON LINACERO FERNANDEZ, MEDIANTE ESC AUTORIZADA POR EL NOTARIO DE MADRID DON JESUSFRANCH VALVERDE, DE FECHA 23/11/1989, CON NUMERO 3911 DE PROT, INS 44&. Datos registrales. T 11997 , F 217, S 8, HM 88575, I/A 87 ( 3.08.15).
06 de Agosto de 2015Reelecciones. Adm. Mancom.: TAUT SL;DEVON HOLDING SL. Representan: PABLOS ALONSO FERNANDO;PABLOS ALONSOEZEQUIEL. Datos registrales. T 11997 , F 217, S 8, H M 88575, I/A 86 (29.07.15).
13 de Julio de 2015Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ SANCHEZ FERNANDO;BASCU脩AN HERRERA LUIS NICOLAS;CRUZ ROJO ELVIRA;DIEZRAMOS HILARIO;GARCIA GONZALEZ JUAN MANUEL;SANTAMARIA DEL REY PRUDENCIO. Datos registrales. T 11997 , F 215,S 8, H M 88575, I/A 85 ( 6.07.15).
19 de Marzo de 2013Otros conceptos: Don M谩ximo Ram贸n Linacero Fern谩ndez, RENUNCIA a todos los poderes conferidos por la Sociedad a su favor yque constabaninscritos en las inscripciones 43&, 55&, 62&, 64&, 65& de lahoja social. Datos registrales. T 11997 , F 215, S 8, H M88575, I/A 84 ( 8.03.13).
05 de Diciembre de 2012Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 11997 , F 214, S 8, HM 88575, I/A 83 (27.11.12).
28 de Septiembre de 2011Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 11997 , F 214, S 8, H M88575, I/A 82 (15.09.11).
07 de Diciembre de 2010Reelecciones. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 11997 , F 214, S 8, H M88575, I/A 81 (22.11.10).
26 de Agosto de 2010Reelecciones. Representan: PABLOS ALONSO FERNANDO;PABLOS ALONSO EZEQUIEL. Adm. Mancom.: TAUT SL;DEVONHOLDING SL. Datos registrales. T 11997 , F 214, S 8, H M 88575, I/A 80 (16.08.10).
10 de Noviembre de 2009Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 11997 , F 213, S 8, H M88575, I/A 79 (28.10.09).
07 de Octubre de 2009Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 17潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EN CUANTO A LARETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES.. Datos registrales. T 11997 , F 213, S 8, H M 88575, I/A 78 (28.09.09).