Actos BORME de Influence Crypto Systems Sl
20 de Noviembre de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 13.883,00 Euros. Resultante Suscrito: 13.883,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n:3.548,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Datos registrales. T 34841 , F 91, S 8, H M 626654, I/A 13 (13.11.18).
13 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: GORDILLO LOPEZ FRANCISCO MANUEL. Datos registrales. T 34841 , F 91, S 8, H M 626654, I/A12 ( 6.08.18).
21 de Septiembre de 2017Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GORDILLO LOPEZ FRANCISCO MANUEL. Revocaciones. Apoderado: GORDILLO LOPEZFRANCISCO MANUEL;PONS GARCIA-CASTRILLON LAURA CLAUDINE. Nombramientos. Cons.Del.Man: VELAZQUEZ DECUELLAR PARACCHI FRANCISCO MIGUEL;DE LEON CASTILLEJO ALFONSO JUAN. Datos registrales. T 34841 , F 67, S 8, H M626654, I/A 10 (12.09.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: DE LEON CASTILLEJO ALFONSO JUAN;VELAZQUEZ DE CUELLAR PARACCHI FRANCISCOMIGUEL;DIAZ MARTIN RUBEN. Datos registrales. T 34841 , F 67, S 8, H M 626654, I/A 11 (12.09.17).
12 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: PONS GARCIA-CASTRILLON LAURA CLAUDINE;VELAZQUEZ DE CUELLAR PARACCHIFRANCISCO MIGUEL;DE LEON CASTILLEJO ALFONSO. Datos registrales. T 34841 , F 65, S 8, H M 626654, I/A 9 (31.08.17).
12 de Julio de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 92,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.548,00 Euros. Datos registrales. T 34841 , F 65, S 8, H M626654, I/A 8 ( 4.07.17).
20 de Abril de 2017Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: SAINZ STUYCK BEATRIZ. Nombramientos. SecreNoConsj: SALVADOR OLEA ENRIQUE.Datos registrales. T 34841 , F 64, S 8, H M 626654, I/A 7 ( 7.04.17).
31 de Enero de 2017Cambio de domicilio social. C/ SAGASTA 18 - 3陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 34841 , F 64, S 8, H M 626654, I/A 6(24.01.17).
11 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Secretario: SANTAELLA VALLEJO PABLO. Nombramientos. SecreNoConsj: SAINZ STUYCK BEATRIZ.Datos registrales. T 34841 , F 64, S 8, H M 626654, I/A 5 ( 2.01.17).
09 de Enero de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 115,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.456,00 Euros. Datos registrales. T 34841 , F 63, S 8, H M626654, I/A 4 (29.12.16).
30 de Septiembre de 2016Nombramientos. Consejero: CONY & BROWN SL. Representan: RAJWANI MAHTANI NARISH-PRAKASH. Ampliaci贸n de capital.Capital: 335,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.341,00 Euros. Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 25 DE LOSESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 34841 , F 62, S 8, H M 626654, I/A 3 (23.09.16).
01 de Agosto de 2016Nombramientos. Apoderado: DE LEON CASTILLEJO ALFONSO;VELAZQUEZ DE CUELLAR FRANCISCO;GORDILLO LOPEZFRANCISCO MANUEL. Datos registrales. T 34841 , F 61, S 8, H M 626654, I/A 2 (20.07.16).
28 de Junio de 2016Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 20.05.16. Objeto social: El desarrollo y comercializaci贸n de plataformas web y gesti贸n deconocimiento; la realizaci贸n de todo tipo de trabajos inform谩ticos, incluidos los de asesoramiento, estudio, promoci贸n instalaci贸n,gesti贸n y control de los procedimientos y medios de informatizaci贸n de los sistemas de administraci贸n. Domicilio: C/ JOSE ORTEGA YGASSET 25 (MADRID). Capital: 3.006,00 Euros. Nombramientos. Consejero: VELAZQUEZ DE CUELLAR PARACCHI FRANCISCOMIGUEL;DE LEON CASTILLEJO ALFONSO JUAN. Presidente: DE LEON CASTILLEJO ALFONSO JUAN. Consejero: GORDILLOLOPEZ FRANCISCO MANUEL. Con.Delegado: GORDILLO LOPEZ FRANCISCO MANUEL. Secretario: SANTAELLA VALLEJO