Buscador CIF Logo

Actos BORME Informacion Control Y Planificacion Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Informacion Control Y Planificacion Sa

Actos BORME Informacion Control Y Planificacion Sa - A81209678

Tenemos registrados 26 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Informacion Control Y Planificacion Sa con CIF A81209678

🔙 Perfil de Informacion Control Y Planificacion Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Informacion Control Y Planificacion Sa

19 de Diciembre de 2022
Cambio de objeto social. Ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos. Oficina de estudios técnicos y proyectos, ingenieríaindustrial y electrónica. Aplicación de los desarrollos de ingeniería, sus programas informáticos y equipos de hardware accesorios atodo tipo de procesos mercantiles. Quedan excluidas todas aquell. Datos registrales. T 35871 , F 78, S 8, H M 170409, I/A 37(12.12.22).

04 de Febrero de 2022
Reelecciones. Consejero: TORO ARRUE IGNACIO. Presidente: LUSARRETA RIPA RAFAEL ENRIQUE. Vicepresid.: DEL TOROASTOBIZA GABRIEL GABINO. Secretario: GONZALEZ DE BETOLAZA TORO BEGOÑA. Consejero: GONZALEZ DE BETOLAZATORO BEGOÑA;DEL TORO ASTOBIZA GABRIEL GABINO;LUSARRETA RIPA RAFAEL ENRIQUE. Cons.Del.Sol: LUSARRETARIPA RAFAEL ENRIQUE;DEL TORO ASTOBIZA GABRIEL GABINO. Consejero: LUSARRETA VELASCO VICTORIA;LUSARRETAVELASCO BORJA. Vicesecret.: LUSARRETA VELASCO VICTORIA. Datos registrales. T 35871 , F 78, S 8, H M 170409, I/A 36(28.01.22).

15 de Noviembre de 2021
Otros conceptos: Modificacion de plazo en la concesion de Incentivos Regionales correspondiente al expediente GU/247/P03, el cualfinalizará el 27/05/2023. Datos registrales. T 10781 , F 46, S 8, H M 170409, I/A 1-M ( 5.11.21).

14 de Julio de 2021
Nombramientos. Auditor: GALVEZ AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35871 , F 77, S 8, H M 170409, I/A 34 ( 7.07.21).

Nombramientos. Aud.C.Con.: GALVEZ AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35871 , F 77, S 8, H M 170409, I/A 35 ( 7.07.21).

05 de Octubre de 2020
Reelecciones. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Datos registrales. T 35871 , F 76, S 8, H M 170409, I/A 32(28.09.20).

Reelecciones. Aud.C.Con.: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Datos registrales. T 35871 , F 77, S 8, H M 170409,I/A 33 (28.09.20).

06 de Febrero de 2020
Otros conceptos: Concesión de incentivos Regionales de fecha 18 de noviembre de 2019. El proyecto de inversión se realizará enCHILOECHES, provincia de Guadalajara y su actividad será: Gestión logística integral. El plazo de vigencia de la concesión finalizaráel 27 de noviembre de 2021. Datos registrales. T 10781 , F 45, S 8, H M 170409, I/A 1M (30.01.20).

25 de Junio de 2019
Reelecciones. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Datos registrales. T 35871 , F 76, S 8, H M 170409, I/A 30

Reelecciones. Aud.C.Con.: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Datos registrales. T 35871 , F 76, S 8, H M 170409,I/A 31 (18.06.19).

23 de Mayo de 2018
Reelecciones. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 35871 , F 75, S 8, HM 170409, I/A 28 (14.05.18).

Reelecciones. Aud.C.Con.: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 35871 , F 76, S8, H M 170409, I/A 29 (14.05.18).

03 de Mayo de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: VELASCO CABREDO MIRIAM ANTONIA. Vicesecret.: VELASCO CABREDO MIRIAM ANTONIA.Nombramientos. Consejero: LUSARRETA VELASCO BORJA. Vicesecret.: LUSARRETA VELASCO VICTORIA. Datos registrales.T 35871 , F 75, S 8, H M 170409, I/A 26 (23.04.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: DIAZ MADRID YOLANDA. Datos registrales. T 35871 , F 75, S 8, H M 170409, I/A 27 (23.04.18).

24 de Julio de 2017
Reelecciones. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 10781 , F 58, S 8, HM 170409, I/A 25 (14.07.17).

21 de Marzo de 2017
Reelecciones. Consejero: TORO ARRUE IGNACIO. Presidente: LUSARRETA RIPA RAFAEL ENRIQUE. Vicepresid.: DEL TOROASTOBIZA GABRIEL GABINO. Secretario: GONZALEZ DE BETOLAZA TORO BEGOÑA. Vicesecret.: VELASCO CABREDO MIRIAMANTONIA. Consejero: GONZALEZ DE BETOLAZA TORO BEGOÑA;DEL TORO ASTOBIZA GABRIEL GABINO;LUSARRETA RIPARAFAEL ENRIQUE;VELASCO CABREDO MIRIAM ANTONIA. Cons.Del.Sol: LUSARRETA RIPA RAFAEL ENRIQUE;DEL TOROASTOBIZA GABRIEL GABINO. Consejero: LUSARRETA VELASCO VICTORIA. Datos registrales. T 10781 , F 58, S 8, H M 170409,I/A 24 (10.03.17).

11 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 10781 , F 58, S 8,H M 170409, I/A 23 (28.10.16).

10 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 10781 , F 57, S 8,H M 170409, I/A 21 (27.10.16).

Nombramientos. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 10781 , F 57, S 8,H M 170409, I/A 22 (27.10.16).

03 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Aud.C.Con.: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 10781 , F 57,S 8, H M 170409, I/A 20 (25.10.16).

11 de Enero de 2013
Reelecciones. Auditor: ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Datos registrales. T 10781 , F 57, S 8, H M 170409, I/A 19 (2.01.13).

01 de Junio de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL TORO ARRUE GERARDO. Nombramientos. Consejero: TORO ARRUE IGNACIO.Reelecciones. Presidente: LUSARRETA RIPA RAFAEL ENRIQUE. Vicepresid.: DEL TORO ASTOBIZA GABRIEL GABINO.Secretario: GONZALEZ DE BETOLAZA TORO BEGOÑA. Vicesecret.: VELASCO CABRERO MIRIAM. Consejero: GONZALEZ DEBETOLAZA TORO BEGOÑA;DEL TORO ASTOBIZA GABRIEL GABINO;LUSARRETA RIPA RAFAEL ENRIQUE;VELASCOCABRERO MIRIAM. Cons.Del.Sol: LUSARRETA RIPA RAFAEL ENRIQUE;DEL TORO ASTOBIZA GABRIEL GABINO. Consejero:LUSARRETA VELASCO VICTORIA. Datos registrales. T 10781 , F 56, S 8, H M 170409, I/A 18 (22.05.12).

21 de Julio de 2011
Ampliación de capital. Suscrito: 419.746,85 Euros. Desembolsado: 419.746,85 Euros. Resultante Suscrito: 600.050,48 Euros.Resultante Desembolsado: 600.050,48 Euros. Datos registrales. T 10781 , F 55, S 8, H M 170409, I/A 17 ( 8.07.11).

12 de Julio de 2011
Nombramientos. Auditor: ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SLP. Datos registrales. T 10781 , F 55, S 8, H M 170409, I/A 16(30.06.11).

10 de Febrero de 2011
Cambio de domicilio social. C/ MARTE, Nº 40 (MECO). Datos registrales. T 10781 , F 55, S 8, H M 170409, I/A 15 (28.01.11).

08 de Noviembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: LUSARRETA RIPA MIGUEL. Nombramientos. Consejero: LUSARRETA VELASCO VICTORIA.Datos registrales. T 10781 , F 54, S 8, H M 170409, I/A 14 (26.10.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información