Buscador CIF Logo

Actos BORME Informacion Y Desarrollo De Albacete Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Informacion Y Desarrollo De Albacete Sociedad Limitada

Actos BORME Informacion Y Desarrollo De Albacete Sociedad Limitada - B02342384

Tenemos registrados 15 Actos BORME del Registro Mercantil de Albacete para Informacion Y Desarrollo De Albacete Sociedad Limitada con CIF B02342384

馃敊 Perfil de Informacion Y Desarrollo De Albacete Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Albacete

Actos BORME de Informacion Y Desarrollo De Albacete Sociedad Limitada

20 de Octubre de 2014
Ceses/Dimisiones. Liquidador: GESTION DE SUELO RODRIGUEZ DELGADO SOCIEDAD LIMITA. Extinci贸n. Datos registrales.T 945, L 709, F 137, S 8, H AB 12181, I/A 39 (13.10.14).

11 de Julio de 2014
Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ PERETE FEDERICO. Datos registrales. T 930, L 694, F 30, S 8, H AB 12181, I/A 37 (4.07.14).

08 de Abril de 2013
Nombramientos. Apoderado: CIFUENTES OVEJERO JUAN MACARIO. Datos registrales. T 927, L 691, F 202, S 8, H AB 12181,I/A 35 ( 1.04.13).

Nombramientos. Apoderado: CANUTO CHINCHILLA PEDRO JAVIER. Datos registrales. T 927, L 691, F 202, S 8, H AB 12181, I/A36 ( 1.04.13).

06 de Febrero de 2013
Revocaciones. Apoderado: VELASCO JIMENEZ CARLOS. Datos registrales. T 922, L 686, F 39, S 8, H AB 12181, I/A 34(30.01.13).

22 de Enero de 2013
Nombramientos. Apoderado: ALARCON TAUSTE JESUS. Datos registrales. T 922, L 686, F 39, S 8, H AB 12181, I/A 33(15.01.13).

11 de Octubre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ MARTINEZ JOSE MANUEL;SANCHEZ HERRAEZ ADORACION;MARTINEZ SANCHEZCONSUELO;MARTINEZ SANCHEZ JOSE MANUEL;MARTINEZ SANCHEZ NOELIA MARIA. Presidente: MARTINEZ MARTINEZJOSE MANUEL. Vicepresid.: MARTINEZ SANCHEZ JOSE MANUEL. Secretario: MARTINEZ SANCHEZ CONSUELO. Con.Delegado:MARTINEZ MARTINEZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Adm. Unico: CORPORACION HMS HERMASAN SOCIEDAD LIMITADA.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. ARTICULO11. La convocatoria de la Junta General de a Sociedad ser har谩 mediante =贸ANUNCIO ENLA PAGINA WEB DE LA MISMA潞=,oblig谩ndose los administradores a mantenerlo insertado en la p谩gina web durante el t茅rminoexigido por la Ley. Con car谩cter voluntarioy adicional se podr谩 realizar tambi茅n la. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa:www.elpueblodealbacete.com. Datos registrales. T 903, L 667, F 10, S 8, H AB 12181, I/A 32 ( 2.10.12).

26 de Enero de 2011
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 899, L 663, F 121, S 8, H AB 12181, I/A31 (17.01.11).

27 de Septiembre de 2010
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ CONSUELO. Datos registrales. T 891, L 655, F 116, S 8, H AB 12181, I/A 30(17.09.10).

11 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTINEZ MARTINEZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ MARTINEZJOSE MANUEL;SANCHEZ HERRAEZ ADORACION;MARTINEZ SANCHEZ CONSUELO;MARTINEZ SANCHEZ JOSEMANUEL;MARTINEZ SANCHEZ NOELIA MARIA. Presidente: MARTINEZ MARTINEZ JOSE MANUEL. Vicepresid.: MARTINEZSANCHEZ JOSE MANUEL. Secretario: MARTINEZ SANCHEZ CONSUELO. Con.Delegado: MARTINEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datosregistrales. T 891, L 655, F 116, S 8, H AB 12181, I/A 29 ( 2.08.10).

25 de Febrero de 2010
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CORPORACION HMS HERMASAN SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T891, L 655, F 116, S 8, H AB 12181, I/A 28 (16.02.10).

14 de Enero de 2010
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 599.182,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:775.412,00 Euros. Resultante Suscrito: 775.412,00 Euros. Datos registrales. T 881, L 645, F 32, S 8, H AB 12181, I/A 27 ( 4.01.10).

03 de Junio de 2009
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ MARTINEZ GINES. Datos registrales. T 881, L 645, F 32, S 8, H AB 12181, I/A 26(25.05.09).

17 de Febrero de 2009
Nombramientos. Apoderado: GIMENEZ MURCIA JESUS MARIA. Datos registrales. T 881, L 645, F 32, S 8, H AB 12181, I/A 25 (6.02.09).

16 de Febrero de 2009
Nombramientos. Apoderado: VELASCO JIMENEZ CARLOS. Datos registrales. T 855, L 619, F 159, S 8, H AB 12181, I/A 24 (6.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n