Buscador CIF Logo

Actos BORME Infraestructura Tecnologica Cgae Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Infraestructura Tecnologica Cgae Sl

Actos BORME Infraestructura Tecnologica Cgae Sl - B84215342

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Infraestructura Tecnologica Cgae Sl con CIF B84215342

馃敊 Perfil de Infraestructura Tecnologica Cgae Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Infraestructura Tecnologica Cgae Sl

31 de Marzo de 2023
Ceses/Dimisiones. Secretario: ALBAREDA CA脩ADELL JORDI. Nombramientos. Secretario: GONZALEZ MARTIN SALVADOR.Datos registrales. T 30961 , F 202, S 8, H M 371549, I/A 21 (24.03.23).

14 de Febrero de 2023
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 17潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 30961 ,F 202, S 8, H M 371549, I/A 20 ( 7.02.23).

19 de Enero de 2023
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: JAUDENES LOPEZ DE CASTRO RAMON. Vicesecret.: RUIZ-GIMENEZ AGUILAR ANTONIO.Consejero: CARNICER DIEZ CARLOS;POZO GOMEZ JOSE PASCUAL;ALBIAC CRUXENT MANUEL. Nombramientos. Secretario:ALBAREDA CA脩ADELL JORDI. Consejero: GONZALEZ MARTIN SALVADOR. Reelecciones. Consejero: PELLON FERNANDEZ-FONTECHA JESUS;ARTECHE GIL CIPRIANO;SANZ FERNANDEZ LOMANA ENRIQUE;ORTEGA BENITO VICTORIA. Presidente:ORTEGA BENITO VICTORIA. Datos registrales. T 30961 , F 201, S 8, H M 371549, I/A 19 (12.01.23).

29 de Marzo de 2021
Nombramientos. Consejero: MASSIEU CURBELO RAFAEL;DE DIEGO MARTINEZ ANDRES. Datos registrales. T 30961 , F 200, S8, H M 371549, I/A 18 (22.03.21).

12 de Junio de 2018
Ampliaci贸n de capital. Capital: 500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 700.000,00 Euros. Datos registrales. T 30961 , F 200, S 8,H M 371549, I/A 17 ( 4.06.18).

30 de Mayo de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: HUGUET TOUS PERE. Datos registrales. T 30961 , F 199, S 8, H M 371549, I/A 12 (23.05.18).

Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: ORTEGA BENITO VICTORIA. Reelecciones. Consejero: ORTEGA BENITO VICTORIA.Presidente: ORTEGA BENITO VICTORIA. Datos registrales. T 30961 , F 199, S 8, H M 371549, I/A 13 (23.05.18).

Reelecciones. SecreNoConsj: JAUDENES LOPEZ DE CASTRO RAMON. Datos registrales. T 30961 , F 199, S 8, H M 371549, I/A14 (23.05.18).

Reelecciones. Consejero: SANZ FERNANDEZ LOMANA ENRIQUE. Datos registrales. T 30961 , F 199, S 8, H M 371549, I/A 15(23.05.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GUMPERT MELGOSA SONIA. Nombramientos. Consejero: PEREZ ANDUJAR MARIA DELCARMEN;BONMATI LLORENS RAFAEL. Datos registrales. T 30961 , F 200, S 8, H M 371549, I/A 16 (23.05.18).

14 de Octubre de 2016
Ceses/Dimisiones. Secretario: ORTEGA BENITO VICTORIA. Presidente: CARNICER DIEZ CARLOS. Nombramientos. Presidente:ORTEGA BENITO VICTORIA. SecreNoConsj: JAUDENES LOPEZ DE CASTRO RAMON. Datos registrales. T 30961 , F 198, S 8, HM 371549, I/A 11 ( 5.10.16).

03 de Junio de 2015
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: CARNICER DIEZ CARLOS;CARNICER DIEZ CARLOS. Reelecciones. Consejero: CARNICERDIEZ CARLOS;HUGUET TOUS PERE. Presidente: CARNICER DIEZ CARLOS. Consejero: PELLON FERNANDEZ-FONTECHAJESUS. Datos registrales. T 30961 , F 197, S 8, H M 371549, I/A 8 (26.05.15).

Nombramientos. Consejero: POZO GOMEZ JOSE PASCUAL;ARTECHE GIL CIPRIANO;GUMPERT MELGOSA SONIA;ALBIACCRUXENT MANUEL. Datos registrales. T 30961 , F 197, S 8, H M 371549, I/A 9 (26.05.15).

Ampliaci贸n de capital. Capital: 100.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 200.000,00 Euros. Datos registrales. T 30961 , F 198, S 8,H M 371549, I/A 10 (26.05.15).

13 de Agosto de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE PABLO DAVILA VICTORIA;DURAN LALAGUNA MARIANO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: RUIZGIMENEZ AGUILAR ANTONIO. Apoderado: ESTEBANEZ VELASCO ADOLFO;BLANQUE REY LUCAS;RUIZ GIMENEZ DE AGUILAR

02 de Junio de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA ROMANILLOS VALVERDE JOAQUIN;REAL CUENCA FRANCISCO. Secretario: GARCIAROMANILLOS VALVERDE JOAQUIN. Cons.Del.Sol: GARCIA ROMANILLOS VALVERDE JOAQUIN. Revocaciones. Apo.Man.Soli:RUIZ LOPEZ JOSE LUIS;PARADINAS HERNANDEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Secretario: ORTEGA BENITO VICTORIA.Cons.Del.Sol: ORTEGA BENITO VICTORIA;CARNICER DIEZ CARLOS. Apoderado: BLANQUE REY LUCAS;RUIZ GIMENEZ DEAGUILAR ANTONIO;ESTEBANEZ VELASCO ADOLFO. Consejero: ORTEGA BENITO VICTORIA;SANZ FERNANDEZ LOMANAENRIQUE;DURAN LALAGUNA MARIANO. Datos registrales. T 20953 , F 18, S 8, H M 371549, I/A 6 (23.05.11).

19 de Enero de 2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SEGIMON ESCOBEDO JOSE LUIS. Apo.Manc.: GONZALEZ FIERRO CUERVAS MONSMAXIMILIANO. Nombramientos. Apoderado: ESTEBANEZ VELASCO ADOLFO. Datos registrales. T 20953 , F 17, S 8, H M371549, I/A 5 ( 7.01.10).

18 de Enero de 2010
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CARNICER DIEZ CARLOS. Nombramientos. Consejero: CARNICER DIEZ CARLOS;GARCIAROMANILLOS VALVERDE JOAQUIN;HERNANDEZ GIL ALVAREZ CIENFUEGOS ANTONIO;REAL CUENCA FRANCISCO;HUGUETTOUS PERE. Vicesecret.: RUIZ-GIMENEZ AGUILAR ANTONIO. Presidente: CARNICER DIEZ CARLOS. Secretario: GARCIAROMANILLOS VALVERDE JOAQUIN. Cons.Del.Sol: GARCIA ROMANILLOS VALVERDE JOAQUIN;CARNICER DIEZ CARLOS.Consejero: DE PABLO DAVILA VICTORIA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nicoa Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 20953 , F 16, S 8, H M 371549, I/A 3 ( 5.01.10).

Nombramientos. Consejero: PELLON FERNANDEZ-FONTECHA JESUS. Datos registrales. T 20953 , F 17, S 8, H M 371549, I/A 4

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n