Buscador CIF Logo

Actos BORME Infratextura Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Infratextura Sl

Actos BORME Infratextura Sl - B86566791

Tenemos registrados 17 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Infratextura Sl con CIF B86566791

馃敊 Perfil de Infratextura Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Infratextura Sl

29 de Noviembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Representan: PELLON REVUELTA LEOPOLDO. Nombramientos. Representan: SOSA FERNANDEZ MARCOANTONIO. Datos registrales. T 37960 , F 55, S 8, H M 547240, I/A 32 (22.11.23).

09 de Mayo de 2023
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 83.000,00 Euros. Datos registrales. T 37960 , F 55, S 8, H M547240, I/A 31 (28.04.23).

19 de Enero de 2023
Ceses/Dimisiones. Representan: GUIO CALLEJA JAVIER. Nombramientos. Representan: GONZALEZ CAMINO RUIZ DEBUCESTA I脩IGO. Datos registrales. T 37960 , F 54, S 8, H M 547240, I/A 30 (12.01.23).

05 de Diciembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: GUIO CALLEJA JAVIER. Nombramientos. Apoderado: GARCIA GONZALEZ IGNACIO. Datosregistrales. T 37960 , F 54, S 8, H M 547240, I/A 29 (28.11.22).

28 de Octubre de 2022
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 82.000,00 Euros. Datos registrales. T 37960 , F 54, S 8, H M547240, I/A 28 (21.10.22).

26 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apoderado: OTERO FERNANDEZ JOSE CARLOS;OTERO FERNANDEZ JOSE CARLOS. Datos registrales. T37960 , F 53, S 8, H M 547240, I/A 27 (19.10.22).

12 de Abril de 2022
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 81.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de losestatutos: 5. Datos registrales. T 37960 , F 51, S 8, H M 547240, I/A 23 ( 5.04.22).

Ceses/Dimisiones. Representan: MOCHON LOPEZ PABLO. Nombramientos. Representan: GUIO CALLEJA JAVIER. Datosregistrales. T 37960 , F 51, S 8, H M 547240, I/A 24 ( 5.04.22).

Revocaciones. Apoderado: MOCHON LOPEZ PABLO. Datos registrales. T 37960 , F 51, S 8, H M 547240, I/A 25 ( 5.04.22).

Nombramientos. Apoderado: GOMEZ DEL RIO SANZ-HERNANZ RAFAEL;ABRIL-MARTORELL HERNANDEZ PABLO;PELLONREVUELTA LEOPOLDO JOSE;GUIO CALLEJA JAVIER;MU脩OZ MU脩OZ MARIA;JIMENEZ-ALFARO LARRAZABALRODRIGO;RODRIGUEZ-AVIAL VILLALAIN FERNANDO;CAJA CALERO BEATRIZ;RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE HERRUZOJUAN;DIAZ DEL RIO REDONDO PABLO;MIJANGOS GOROZARRI CARLOS;GARCIA URUE脩A LUIS ENRIQUE;OTEROESCUDERO PABLO;OTERO FERNANDEZ JOSE CARLOS;VENTURA GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO. Datos registrales. T37960 , F 51, S 8, H M 547240, I/A 26 ( 5.04.22).

29 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: ABRIL-MARTORELL HERNANDEZ PABLO;PELLON REVUELTA LEOPOLDO;MANRIQUE SABATELFABIO;MOCHON LOPEZ PABLO;JALON GONZALEZ EVA;MU脩OZ MU脩OZ MARIA;JIMENEZ-ALFARO LARRAZABALRODRIGO;RODRIGUEZ-AVIAL VILLALAIN FERNANDO;CAJA CALERO BEATRIZ;RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE HERRUZOJUAN;DIAZ DEL RIO REDONDO PABLO;GARCIA URUE脩A LUIS ENRIQUE;OTERO ESCUDERO PABLO;OTERO FERNANDEZJOSE CARLOS;VENTURA GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO;MIJANGOS GOROZARRI CARLOS. Datos registrales. T 37960 , F49, S 8, H M 547240, I/A 22 (22.11.21).

18 de Noviembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Representan: JIMENEZ ORTEGA DOMINGO. Nombramientos. Representan: PELLON REVUELTALEOPOLDO. Datos registrales. T 37960 , F 48, S 8, H M 547240, I/A 21 (11.11.21).

02 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: CORRAL FERNANDEZ FELIX. Datos registrales. T 37960 , F 48, S 8, H M 547240, I/A 20 (25.10.21).

24 de Mayo de 2021
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 80.000,00 Euros. Datos registrales. T 37960 , F 48, S 8, H M547240, I/A 19 (14.05.21).

19 de Octubre de 2020
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 79.000,00 Euros. Datos registrales. T 37960 , F 47, S 8, H M547240, I/A 18 ( 9.10.20).

24 de Octubre de 2019
Cambio de domicilio social. C/ CONDESA DE VENADITO, NUMERO 7 (MADRID). Datos registrales. T 37960 , F 47, S 8, H M547240, I/A 17 (17.10.19).

17 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MANRIQUE SABATEL FABIO;MOCHON LOPEZ PABLO. Nombramientos. Representan:JIMENEZ ORTEGA DOMINGO;MOCHON LOPEZ PABLO. Adm. Mancom.: SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS II SL;SACYRCONCESIONES PARTICIPADAS III SL. Datos registrales. T 37960 , F 46, S 8, H M 547240, I/A 16 (10.10.19).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n