Actos BORME de Ingenia Soluciones Grupo Electricas Hermanos Campos Sociedad Limitada
13 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: CAMPOS SANTOS JOSE;CAMPOS SANTOS ANTONIO. Revocaciones. Apo.Manc.: GRANADOSCAMPOS ALFONSO;MORENO MOLINILLO JOSE. Apoderado: TALAYA COLLADO JOSE;QUISLANT PEREZ DIEGO JOSE.Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 945, L 709, F 9, S 8, H AB 17693, I/A 17 ( 5.01.17).
23 de Junio de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.302.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.308.200,00 Euros. Modificaciones estatutarias.ARTICULO 9潞. ADMINISTRACION. 1. Estructura del 贸rgano de administraci贸n.- La gesti贸n y representaci贸n de la Sociedad seencomendar谩 por la Junta General, en virtud de acuerdo adoptado con las mayor铆as previstas para la modificaci贸n de los Estatutos,pero sin que suponga alteraci贸n de su texto, el. Datos registrales. T 939, L 703, F 124, S 8, H AB 17693, I/A 16 (13.06.14).
20 de Enero de 2014Ampliacion del objeto social. El desarrollo de soluciones industriales basadas en el control remoto de equipos, la realizacion deestudios, planificacion,ejecucion y mantenimiento de dichas soluciones, asi como su comercializaci贸n o compraventa, tanto en Espa帽acomo en el extranjero. La licitaci贸n y contrataci贸n con el sector. Datos registrales. T 939, L 703, F 124, S 8, H AB 17693, I/A 15(10.01.14).
08 de Enero de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.200,00 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedadesabsorbidas: APLICACIONES TELECONTROLADAS URBANTEC SOCIEDAD LIM. Datos registrales. T 930, L 694, F 35, S 8, H AB17693, I/A 14 (30.12.13).
31 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPOS SANTOS JOSE;CAMPOS SANTOS ANTONIO;GRANADOS CAMPOSALFONSO;MORENO MOLINILLO JOSE. Presidente: CAMPOS SANTOS JOSE. Vicepresid.: CAMPOS SANTOS ANTONIO.Secretario: GRANADOS CAMPOS ALFONSO. Con.Delegado: CAMPOS SANTOS JOSE. Nombramientos. Adm. Solid.: CAMPOSSANTOS JOSE;CAMPOS SANTOS ANTONIO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 930, L 694, F 35, S 8, H AB 17693, I/A 13 (24.10.13).
09 de Abril de 2013Nombramientos. Apoderado: QUISLANT PEREZ DIEGO JOSE. Datos registrales. T 909, L 673, F 97, S 8, H AB 17693, I/A 12 (2.04.13).
07 de Diciembre de 2012Revocaciones. Apoderado: FLORES CORCOLES ANTONIO;PACHECO ALCARRIA JORGE;SAEZ GARCIA ANTONIO. Datosregistrales. T 909, L 673, F 97, S 8, H AB 17693, I/A 11 (28.11.12).
05 de Octubre de 2011Revocaciones. Apo.Manc.: AGUILAR GARRIDO PILAR. Datos registrales. T 909, L 673, F 97, S 8, H AB 17693, I/A 10 (26.09.11).
12 de Agosto de 2011Nombramientos. Apoderado: TALAYA COLLADO JOSE. Datos registrales. T 907, L 671, F 92, S 8, H AB 17693, I/A 9 ( 3.08.11).
10 de Junio de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: FLORES CORCOLES ANTONIO;CAMPOS SANTOS JOSE;CAMPOS SANTOS ANTONIO;LUCASPEREZ MIGUEL;PACHECO ALCARRIA JORGE. Presidente: CAMPOS SANTOS JOSE. Vicepresid.: CAMPOS SANTOS ANTONIO.Secretario: FLORES CORCOLES ANTONIO. Con.Delegado: CAMPOS SANTOS JOSE. Nombramientos. Consejero: CAMPOSSANTOS JOSE;CAMPOS SANTOS ANTONIO;GRANADOS CAMPOS ALFONSO;MORENO MOLINILLO JOSE. Presidente: CAMPOSSANTOS JOSE. Vicepresid.: CAMPOS SANTOS ANTONIO. Secretario: GRANADOS CAMPOS ALFONSO. Con.Delegado: CAMPOSSANTOS JOSE. Datos registrales. T 895, L 659, F 13, S 8, H AB 17693, I/A 7 ( 1.06.11).
Nombramientos. Apo.Manc.: GRANADOS CAMPOS ALFONSO;AGUILAR GARRIDO PILAR;MORENO MOLINILLO JOSE. Datosregistrales. T 895, L 659, F 13, S 8, H AB 17693, I/A 8 ( 1.06.11).
23 de Abril de 2010Nombramientos. Apoderado: SAEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 891, L 655, F 134, S 8, H AB 17693, I/A 5 (14.04.10).
Nombramientos. Apoderado: PACHECO ALCARRIA JORGE. Datos registrales. T 895, L 659, F 13, S 8, H AB 17693, I/A 6(14.04.10).
08 de Febrero de 2010Nombramientos. Apoderado: FLORES CORCOLES ANTONIO. Datos registrales. T 891, L 655, F 134, S 8, H AB 17693, I/A 4(28.01.10).
15 de Enero de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LUCAS PEREZ MIGUEL;PACHECO ALCARRIA JORGE. Nombramientos. Consejero: FLORESCORCOLES ANTONIO;CAMPOS SANTOS JOSE;CAMPOS SANTOS ANTONIO;LUCAS PEREZ MIGUEL;PACHECO ALCARRIAJORGE. Presidente: CAMPOS SANTOS JOSE. Vicepresid.: CAMPOS SANTOS ANTONIO. Secretario: FLORES CORCOLESANTONIO. Con.Delegado: CAMPOS SANTOS JOSE. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Cambio de domicilio social. PQUE INDUSTRIAL CAMPOLLANO - CALLEF, NUMERO 21 (ALBACETE). Datos registrales. T 844, L 608, F 3, S 8, H AB 17693, I/A 3 ( 5.01.10).
07 de Enero de 2009Ampliacion del objeto social. la actividad de suministrar equipos muebles y veh铆culos con o y sin motor. Datos registrales. T 844, L608, F 3, S 8, H AB 17693, I/A 2 (23.12.08).