Buscador CIF Logo

Actos BORME Ingenieria De Sistemas Y Telemando Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ingenieria De Sistemas Y Telemando Sociedad Anonima

Actos BORME Ingenieria De Sistemas Y Telemando Sociedad Anonima - A95439584

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Vizcaya para Ingenieria De Sistemas Y Telemando Sociedad Anonima con CIF A95439584

馃敊 Perfil de Ingenieria De Sistemas Y Telemando Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Vizcaya

Actos BORME de Ingenieria De Sistemas Y Telemando Sociedad Anonima

03 de Agosto de 2023
Revocaciones. Apoderado: DE LA TORRE TOLEDO JULIA. Datos registrales. T 5951 , F 161, S 8, H BI 47516, I/A 30 (27.07.23).

13 de Junio de 2023
Reelecciones. Adm. Unico: CLECH LAURENT JEAN LOUIS. Datos registrales. T 5951 , F 159, S 8, H BI 47516, I/A 28 ( 1.06.23).

17 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: ANDRES JIMENEZ JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 5951 , F 158, S 8, H BI 47516, I/A 27 (8.11.22).

29 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: IRAZABAL CASAMITJANA I脩IGO. Datos registrales. T 5951 , F 157, S 8, H BI 47516, I/A 25(21.09.22).

17 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ MIRALLES LUIS MARIA. Datos registrales. T 5951 , F 156, S 8, H BI 47516, I/A 23 ( 8.02.22).

Nombramientos. Apoderado: GOMEZ MIRALLES LUIS MARIA. Datos registrales. T 5951 , F 156, S 8, H BI 47516, I/A 24 (8.02.22).

27 de Septiembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ MIRALLES LUIS MARIA. Datos registrales. T 5951 , F 154, S 8, H BI 47516, I/A 22(15.09.21).

30 de Julio de 2021
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ MARTIN AGUSTIN. Datos registrales. T 5951 , F 154, S 8, H BI 47516, I/A 21 (21.07.21).

29 de Octubre de 2020
Cambio de domicilio social. PQUE EMPRESARIAL ABRA INDUSTRIAL - S/N (ORTUELLA). Datos registrales. T 5951 , F 154, S8, H BI 47516, I/A 20 (15.10.20).

22 de Octubre de 2020
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ MARTIN AGUSTIN;ARESTI ZALBIDEA IKERNE. Datos registrales. T 5725 , F 174, S 8, H BI47516, I/A 18 (13.10.20).

Revocaciones. Apoderado: MAGUREGUI URIA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5951 , F 154, S 8, H BI 47516, I/A 19(13.10.20).

11 de Junio de 2020
Revocaciones. Apoderado: YAGUE MARTINEZ TAMARA;ANGULO REIGOSA ANA;MAGUREGUI URIA FRANCISCO JAVIER;RUIZCUESTA ZULEMA. Nombramientos. Apoderado: MAGUREGUI URIA FRANCISCO JAVIER;YAGUE MARTINEZ TAMARA;ANGULOREIGOSA ANA;ARESTE ZALBIDEA IKERNE. Datos registrales. T 5725 , F 173, S 8, H BI 47516, I/A 17 ( 3.06.20).

14 de Febrero de 2019
Revocaciones. Apoderado: YAGUE MARTINEZ TAMARA;ANGULO REIGOSA ANA;MAGUREGUI URIA FRANCISCO JAVIER;RUIZCUESTA ZULEMA. Nombramientos. Apoderado: YAGUE MARTINEZ TAMARA;ANGULO REIGOSA ANA;MAGUREGUI URIAFRANCISCO JAVIER;RUIZ CUESTA ZULEMA. Datos registrales. T 5725 , F 171, S 8, H BI 47516, I/A 16 ( 1.02.19).

19 de Septiembre de 2018
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: VINCI ENERGIES ESPA脩A SOCIEDAD ANONIMA. Ceses/Dimisiones. Consejero:CORDON BALMASEDA IVAN. Presidente: CORDON BALMASEDA IVAN. Consejero: DIAZ LOPEZ RICARDO. Secretario:MAGUREGUI URIA FRANCISCO JAVIER. Consejero: MAGUREGUI URIA FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Adm. Unico:CLECH LAURENT JEAN LOUIS. Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n y refundici贸n de los Estatutos sociales.. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 5765 , F169, S 8, H BI 47516, I/A 14 ( 3.09.18).

Revocaciones. Apo.Sol.: MAGUREGUI URIA FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apoderado: YAGUE MARTINEZTAMARA;ANGULO REIGOSA ANA;MAGUREGUI URIA FRANCISCO JAVIER;RUIZ CUESTA ZULEMA. Datos registrales. T 5765 ,F 170, S 8, H BI 47516, I/A 15 ( 3.09.18).

13 de Abril de 2018
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: INSITEL LOGISTICA SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5765 , F 167, S 8,H BI 47516, I/A 13 ( 3.04.18).

23 de Noviembre de 2017
Escisi贸n parcial. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: PROMOCIONES LUCERO 1953 SOCIEDAD LIMITADA. Datosregistrales. T 4756 , F 167, S 8, H BI 47516, I/A 12 (14.11.17).

23 de Noviembre de 2015
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Secretario: MAGUREGUI URIA FRANCISCO JAVIER. Consejero: MAGUREGUI URIAFRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Secretario: MAGUREGUI URIA FRANCISCO JAVIER. Consejero: MAGUREGUI URIAFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 4756 , F 167, S 8, H BI 47516, I/A 11 (14.11.15).

22 de Enero de 2015
Cambio de domicilio social. C/ USAUSUAGA, POLIGONO INDUSTRIAL ARTUNDUAGA, PABE (BASAURI). Datos registrales. T4756 , F 167, S 8, H BI 47516, I/A 10 (14.01.15).

21 de Abril de 2014
Revocaciones. Apo.Sol.: CORDON BALMASEDA IVAN. Reelecciones. Consejero: DIAZ LOPEZ RICARDO. Datos registrales. T4756 , F 167, S 8, H BI 47516, I/A 9 ( 8.04.14).

20 de Marzo de 2013
Reelecciones. Consejero: CORDON BALMASEDA IVAN. Presidente: CORDON BALMASEDA IVAN. Datos registrales. T 4756 , F167, S 8, H BI 47516, I/A 8 ( 1.03.13).

19 de Noviembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ SAN MILLAN JOSE RAMON. Secretario: GOMEZ SAN MILLAN JOSE RAMON.Nombramientos. Consejero: MAGUREGUI URIA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 4756 , F 166, S 8, H BI 47516, I/A 7 (5.11.09).

13 de Enero de 2009
Ceses/Dimisiones. Secretario: ORTEGA RODRIGUEZ GUILLERMO. Nombramientos. Consejero: GOMEZ SAN MILLAN JOSERAMON. Secretario: GOMEZ SAN MILLAN JOSE RAMON. Datos registrales. T 4756 , F 166, S 8, H BI 47516, I/A 6 (29.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n