Actos BORME de Ingenieria Y Construccion Moymar Sa
20 de Mayo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: AYRES JANEIRO JUAN ANTONIO;FERRER PARRA ALFONSO CARMELO. Secretario: FERRERPARRA ALFONSO CARMELO. Consejero: CAMY RUS PEDRO MANUEL. Presidente: CAMY RUS PEDRO MANUEL. Consejero:PREAMANECER SL EN LIQUIDACION. Secretario: FERRER PARRA ALFONSO. Representan: CAMY RUS PEDRO MANUEL.Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 901/2019. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 7/10/2019. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID. Juez: MARTA GARCIAFERNANDEZ. Resoluciones: Se declara el concurso de acreedores a la sociedad INGENIERIA Y CONSTRUCCION MOYMAR, S.A.Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 901/2019. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 7/10/2019. Auto de conclusi贸n delconcurso. Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID. Juez: MARTAGARCIA FERNANDEZ. Resoluciones: Se declara la conclusi贸n del concurso de acreedores de la sociedad y se acuerda.la extinci贸nde la misma. Extinci贸n. Datos registrales. T 24460 , F 204, S 8, H M 56009, I/A 73 (13.05.21).
22 de Junio de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: LAMELA COLMENAR MONICA. Apoderado: AYRES JANEIRO FERNANDO IGNACIO;GUTIERREZALVAREZ FERNANDO;VELAYOS GONZALEZ ROMAN;CAMY SEGOVIA MONICA. Datos registrales. T 24460 , F 204, S 8, H M56009, I/A 71 (14.06.16).
Ceses/Dimisiones. Representan: SEGOVIA VELASCO MARIA DOLORES. Nombramientos. Representan: CAMY RUS PEDROMANUEL. Datos registrales. T 24460 , F 204, S 8, H M 56009, I/A 72 (14.06.16).
24 de Noviembre de 2014Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: PREAMANECER SL. Reelecciones. Consejero: PREAMANECER SL. Datos registrales. T24460 , F 203, S 8, H M 56009, I/A 69 (14.11.14).
Cambio de domicilio social. C/ PERU 2 - LOCAL 7 (COSLADA). Datos registrales. T 24460 , F 204, S 8, H M 56009, I/A 70(14.11.14).
14 de Enero de 2014Reelecciones. Consejero: CAMY RUS PEDRO MANUEL. Presidente: CAMY RUS PEDRO MANUEL. Datos registrales. T 24460 , F203, S 8, H M 56009, I/A 68 ( 7.01.14).
18 de Noviembre de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: VELAYOS GONZALEZ ROMAN. Datos registrales. T 24460 , F 203, S 8, H M 56009, I/A 67 (8.11.13).
31 de Julio de 2013Cambio de domicilio social. C/ JENNER 3 - 1潞 IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 24460 , F 203, S 8, H M 56009, I/A 66(23.07.13).
25 de Enero de 2013Cambio de domicilio social. C/ GARCIA DE PAREDES 78 3潞 3 (MADRID). Datos registrales. T 24460 , F 202, S 8, H M 56009, I/A65 (17.01.13).
24 de Enero de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMY SEGOVIA JAVIER. Reelecciones. Consejero: AYRES JANEIRO JUAN ANTONIO;FERRERPARRA ALFONSO CARMELO. Secretario: FERRER PARRA ALFONSO CARMELO. Datos registrales. T 24460 , F 202, S 8, H M56009, I/A 64 (16.01.13).
22 de Enero de 2013Revocaciones. Apoderado: AYRES JANEIRO JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 24460 , F 202, S 8, H M 56009, I/A 63(14.01.13).
11 de Abril de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ DIAZ AMARO. Apoderado: FERRER PARRA ALFONSO;CONEJO TROCA SONIA;CAMYSEGOVIA MONICA;CAMY SEGOVIA PEDRO MANUEL. Datos registrales. T 24460 , F 202, S 8, H M 56009, I/A 62 (28.03.12).
24 de Junio de 2011Nombramientos. Auditor: DE TERRY CARLOS JOHANSSON. Aud.Supl.: GARCIA ADAN GARCIA DANIEL. Datos registrales. T24460 , F 202, S 8, H M 56009, I/A 61 ( 9.06.11).
20 de Julio de 2010Nombramientos. Apoderado: CAMY SEGOVIA MONICA;CAMY SEGOVIA PEDRO MANUEL. Datos registrales. T 24460 , F 200, S8, H M 56009, I/A 60 ( 8.07.10).
25 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: CAMY SEGOVIA MONICA. Datos registrales. T 24460 , F 199, S 8, H M 56009, I/A 59 (13.02.09).