Buscador CIF Logo

Actos BORME Ingeser Corporacion Catalunya Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ingeser Corporacion Catalunya Sa

Actos BORME Ingeser Corporacion Catalunya Sa - A81182040

Tenemos registrados 9 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Ingeser Corporacion Catalunya Sa con CIF A81182040

馃敊 Perfil de Ingeser Corporacion Catalunya Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Ingeser Corporacion Catalunya Sa

27 de Enero de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANZ DELGADO FRANCISCO JAVIER. Presidente: SANZ DELGADO FRANCISCO JAVIER.Consejero: BAU MARTINEZ JOSE LUIS. Secretario: BAU MARTINEZ JOSE LUIS. Cons.Del.Sol: SANZ DELGADO FRANCISCOJAVIER;BAU MARTINEZ JOSE LUIS. Consejero: MU脩OZ RONCERO MARIA VICTORIA;GUTIERREZ BOURDON JOSEFLORESTAN;GONZALEZ ROIZ JUAN IGNACIO. Nombramientos. Adm. Solid.: DOS REIS EDUARDO MARCELO;DUSMETMINGOT IGNACIO. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 9潞, 17. al 26. AMBOS INCLUSIVE, QUEQUEDAN RENUMERADOS DEL 17. AL 20., Y RENUMERACION DE LOS ARTICULOS 27 A 30, QUE PASAN A SER 21 A 24 ,..Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Cambio dedomicilio social. C/ GOBELAS, 13 (MADRID). Cambio de objeto social. La intermediaci贸n en la coordinaci贸n y contrataci贸n parael estudio y redacci贸n de toda clase de proyectos y dict谩menes t茅cnicos y de ingenier铆a, a todo tipo de empresas y particulares tantoen el territorio nacional como internacional, que contempla desde estudios de viabilidad o ingenier铆as b谩sica. Datos registrales. T9606 , F 176, S 8, H M 154444, I/A 12 (20.01.21).

12 de Agosto de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: MIRANDA CASTAN DANIEL. Datos registrales. T 9606 , F 176, S 8, H M 154444, I/A 11 ( 5.08.20).

07 de Agosto de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: BERMEJO RAMOS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 9606 , F 175, S 8, H M 154444, I/A10 (31.07.20).

05 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apoderado: DOS REIS EDUARDO MARCELO. Datos registrales. T 9606 , F 175, S 8, H M 154444, I/A 9(29.07.20).

22 de Junio de 2020
Revocaciones. Apoderado: GUTIERREZ BOURDON JOSE FLORESTAN;GONZALEZ ROIZ JUAN IGNACIO;SAHUN PERES ENRICRAMON;SANZ DELGADO FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: SAHUN PERES ENRIC RAMON;GONZALEZ ROIZ JUANIGNACIO;SANZ DELGADO FRANCISCO JAVIER;MU脩OZ RONCERO MARIA VICTORIA. Datos registrales. T 9606 , F 174, S 8, HM 154444, I/A 8 (15.06.20).

24 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUTIERREZ BOURDON JOSE FLORESTAN. Presidente: GUTIERREZ BOURDON JOSEFLORESTAN. Consejero: BAU MARTINEZ JOSE LUIS. Secretario: BAU MARTINEZ JOSE LUIS. Consejero: SANZ DELGADOFRANCISCO JAVIER;GONZALEZ ROIZ JUAN IGNACIO;MU脩OZ RONCERO MARIA VICTORIA. Cons.Del.Sol: GUTIERREZBOURDON JOSE FLORESTAN;BAU MARTINEZ JOSE LUIS;SANZ DELGADO FRANCISCO JAVIER;GONZALEZ ROIZ JUANIGNACIO. Nombramientos. Consejero: SANZ DELGADO FRANCISCO JAVIER. Presidente: SANZ DELGADO FRANCISCOJAVIER. Consejero: BAU MARTINEZ JOSE LUIS. Secretario: BAU MARTINEZ JOSE LUIS. Cons.Del.Sol: SANZ DELGADOFRANCISCO JAVIER;BAU MARTINEZ JOSE LUIS. Consejero: MU脩OZ RONCERO MARIA VICTORIA;MIRANDA CASTANDANIEL;BERMEJO RAMOS FRANCISCO JAVIER;GUTIERREZ BOURDON JOSE FLORESTAN;GONZALEZ ROIZ JUAN IGNACIO.Datos registrales. T 9606 , F 174, S 8, H M 154444, I/A 7 (17.08.15).

01 de Abril de 2015
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 45.075,91 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 219.898,79 Euros.Desembolsado: 219.898,79 Euros. Resultante Suscrito: 280.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 280.000,00 Euros. Datosregistrales. T 9606 , F 174, S 8, H M 154444, I/A 6 (25.03.15).

05 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUTIERREZ BOURDON JOSE FLORESTAN. Presidente: GUTIERREZ BOURDON JOSEFLORESTAN. Consejero: BAU MARTINEZ JOSE LUIS. Secretario: BAU MARTINEZ JOSE LUIS. Consejero: SAHUN PERES ENRICRAMON. Cons.Del.Sol: GUTIERREZ BOURDON JOSE FLORESTAN;BAU MARTINEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero:GUTIERREZ BOURDON JOSE FLORESTAN. Presidente: GUTIERREZ BOURDON JOSE FLORESTAN. Consejero: BAU MARTINEZJOSE LUIS. Secretario: BAU MARTINEZ JOSE LUIS. Consejero: SANZ DELGADO FRANCISCO JAVIER;GONZALEZ ROIZ JUANIGNACIO;MU脩OZ RONCERO MARIA VICTORIA. Cons.Del.Sol: GUTIERREZ BOURDON JOSE FLORESTAN;BAU MARTINEZ JOSELUIS;SANZ DELGADO FRANCISCO JAVIER;GONZALEZ ROIZ JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 9606 , F 173, S 8, H M154444, I/A 5 (26.07.10).

30 de Diciembre de 2009
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SERVICIOS DE INGENIERIA Y GESTION SA. Datos registrales. T 9606 , F 173, S8, H M 154444, I/A 4 (18.12.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n