Actos BORME de Iniciativas Radiofonicas Y De Television Sociedad Limitada
10 de Febrero de 2016Revocaciones. Apoderado: MORENO PERAL ISAAC. Datos registrales. T 27933 , F 59, S 8, H M 143143, I/A 54 ( 3.02.16).
06 de Febrero de 2014Revocaciones. Apoderado: CA脩ADAS MACHADO ANDRES LUIS;GARCIA AMOEDO PASCUAL;FERNANDEZ DEL VISO MORANLUCIA;MARTIN DE BLAS JOSE MARIA;GONZALEZ DEL YERRO VALDES JENARO. Datos registrales. T 27933 , F 59, S 8, H M143143, I/A 53 (30.01.14).
22 de Enero de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: ARMENTEROS MENENDEZ JOSE IGNACIO;MARTIN DE BLAS JOSE MARIA;SERETI LOPEZSAHARA. Datos registrales. T 27933 , F 59, S 8, H M 143143, I/A 52 (14.01.14).
20 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Representan: FERNANDEZ DEL VISO MORAN LUCIA. Nombramientos. Representan: MARTINEZ PEREZ DETUDELA BENITO. Datos registrales. T 27933 , F 58, S 8, H M 143143, I/A 51 (12.12.13).
29 de Octubre de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 5.024.354,60 Euros. Resultante Suscrito: 370.488,60 Euros. Otros conceptos: SERENUMERAN LAS PARTICIPACIONES SOCIALES QUE SE MANTIENEN. Datos registrales. T 27933 , F 57, S 8, H M 143143, I/A50 (21.10.13).
27 de Agosto de 2013Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27933 , F 57, S 8, H M 143143, I/A 49 (19.08.13).
26 de Octubre de 2012Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27933 , F 57, S 8, H M 143143, I/A 48 (16.10.12).
04 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Presidente: GIMENEZ BARRIOCANAL FERNANDO. Con.Delegado: GIMENEZ BARRIOCANAL FERNANDO.Consejero: GIMENEZ BARRIOCANAL FERNANDO;PEREZ DEL PUERTO RODRIGUEZ RAFAEL. Con.Delegado: PEREZ DELPUERTO RODRIGUEZ RAFAEL. Consejero: CORONEL DE PALMA Y MARTINEZ AGULLO ALFONSO. Vicepresid.: CORONEL DEPALMA Y MARTINEZ AGULLO ALFONSO. Consejero: JUAREZ GARCIA GASCO TOMAS;GIL TAMAYO JOSE MARIA;GRUPO DEEMPRESAS CAJASUR SA;MORENO PERAL ISAAC;FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO C E U;ORTU脩O MORENTE JUANPEDRO;DIAZ-BERNARDO NAVARRO JUAN;BURILLO AZCARRAGA EMILIO;SPINNAKER INVEST SCR SA. Representan:CA脩ADILLA MOYANO ANGEL-MARIA;ROMERO CARAMELO CARLOS;FERRER OLIVERAS ALBERTO. SecreNoConsj: GONZALEZDEL YERRO VALDES JENARO. Nombramientos. Adm. Unico: RADIO POPULAR SOCIEDAD ANONIMA CADENA DE ONDASPOP. Representan: FERNANDEZ DEL VISO MORAN LUCIA. Datos registrales. T 27933 , F 57, S 8, H M 143143, I/A 47 (21.09.11).
29 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Representan: DAGNINO GUERRA ALFREDO. Nombramientos. Representan: ROMERO CARAMELOCARLOS. Datos registrales. T 27933 , F 56, S 8, H M 143143, I/A 46 (19.09.11).
02 de Junio de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.256.999,20 Euros. Resultante Suscrito: 5.394.843,20 Euros. Datos registrales. T 27933 , F 55, S8, H M 143143, I/A 45 (23.05.11).
03 de Enero de 2011Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 9.362.173,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.137.844,00 Euros. Datos registrales. T 27933, F 54, S 8, H M 143143, I/A 44 (22.12.10).
24 de Diciembre de 2010Nombramientos. Consejero: DIAZ-BERNARDO NAVARRO JUAN. Datos registrales. T 27933 , F 54, S 8, H M 143143, I/A 43(14.12.10).
19 de Noviembre de 2010Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27933 , F 53, S 8, H M 143143, I/A 41 ( 8.11.10).
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DEL YERRO VALDES JENARO. Nombramientos. SecreNoConsj: GONZALEZ DELYERRO VALDES JENARO. Datos registrales. T 27933 , F 54, S 8, H M 143143, I/A 42 ( 8.11.10).
14 de Octubre de 2010Ceses/Dimisiones. Representan: MONTES GARCIA ALFREDO. Consejero: CERIX GLOBAL HISPANIA SL. Nombramientos.Representan: CA脩ADILLA MOYANO ANGEL-MARIA. Consejero: GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA. Datos registrales. T27933 , F 53, S 8, H M 143143, I/A 38 ( 1.10.10).
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: BURILLO AZCARRAGA EMILIO;GONZALEZ DEL YERRO VALDES JENARO. Nombramientos.Con.Delegado: GIMENEZ BARRIOCANAL FERNANDO. Datos registrales. T 27933 , F 53, S 8, H M 143143, I/A 39 ( 1.10.10).
Nombramientos. Con.Delegado: PEREZ DEL PUERTO RODRIGUEZ RAFAEL. Datos registrales. T 27933 , F 53, S 8, H M143143, I/A 40 ( 1.10.10).
28 de Septiembre de 2010Ceses/Dimisiones. Presidente: BURILLO AZCARRAGA EMILIO. Nombramientos. Presidente: GIMENEZ BARRIOCANALFERNANDO. Datos registrales. T 27933 , F 52, S 8, H M 143143, I/A 37 (16.09.10).
16 de Septiembre de 2010Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: CORONEL DE PALMA Y MARTINEZ AGULLO ALFONSO. Presidente: CORONEL DE PALMA YMARTINEZ AGULLO ALFONSO. Nombramientos. Presidente: BURILLO AZCARRAGA EMILIO. Vicepresid.: CORONEL DE PALMAY MARTINEZ AGULLO ALFONSO. Cons.Del.Man: BURILLO AZCARRAGA EMILIO;GONZALEZ DEL YERRO VALDES JENARO.Datos registrales. T 27933 , F 52, S 8, H M 143143, I/A 36 (31.08.10).
31 de Agosto de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: CRUZ-CONDE SUAREZ DE TANGIL FERNANDO. Nombramientos. Consejero: GIMENEZBARRIOCANAL FERNANDO;BURILLO AZCARRAGA EMILIO. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.500.000,00 Euros.Resultante Suscrito: 11.500.000,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.000.017,00 Euros. Resultante Suscrito: 12.500.017,00Euros. Datos registrales. T 17359 , F 167, S 8, H M 143143, I/A 35 (19.08.10).
29 de Marzo de 2010Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 17359 , F 167, S 8, H M 143143, I/A 34 (16.03.10).
31 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: GIMENEZ BARRIOCANAL FERNANDO. Datos registrales. T 17359 , F 167, S 8, H M 143143, I/A33 (18.12.09).
11 de Diciembre de 2009Revocaciones. Apoderado: SAMANES PRAT ALEJANDRO. Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ DEL YERRO VALDESJENARO. Datos registrales. T 17359 , F 167, S 8, H M 143143, I/A 32 (27.11.09).
09 de Octubre de 2009Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 17359 , F166, S 8, H M 143143, I/A 31 (30.09.09).