Actos BORME de Inima Water Services Sl
24 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: ANDREU GARCIA RAUL. Datos registrales. T 1163 , F 108, S 8, H S 29010, I/A 37 (13.11.23).
26 de Octubre de 2023Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1163 , F 108, S 8, H S 29010, I/A 36 (19.10.23).
15 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: VERDE BLAZQUEZ MARTA ELENA. Datos registrales. T 1163 , F 106, S 8, H S 29010, I/A 34 (7.09.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: REBECA GOMEZ ORTIZ;CAYON GARCIA LIDIA. Datos registrales. T 1163 , F 108, S 8, H S 29010, I/A35 ( 7.09.23).
29 de Agosto de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: BECERRA DE MARCOS MANUEL-EDUARDO. Datos registrales. T 1163 , F 105, S 8, H S 29010, I/A32 ( 3.08.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CALLEJA MATEO GONZALO ANTONIO. Datos registrales. T 1163 , F 105, S 8, H S 29010, I/A 33( 3.08.23).
01 de Junio de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: BECERRA DE MARCOS MANUEL-EDUARDO. Nombramientos. Adm. Mancom.: CALLEJAMATEO GONZALO ANTONIO. Datos registrales. T 1163 , F 105, S 8, H S 29010, I/A 31 (23.05.23).
26 de Enero de 2023Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1163 , F 105, S 8, H S 29010, I/A 30 ( 5.01.23).
12 de Diciembre de 2022Cambio de domicilio social. CALLE VILLANOSA Nº 67, BAJO NORTE-PLAZA MARQUES D (MIENGO). Datos registrales. T 1163, F 105, S 8, H S 29010, I/A 29 (29.11.22).
05 de Agosto de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: SIGUERO AZATEGUI MARTA;NACENTA MORA CARLOS. Datos registrales. T 1163 , F 104, S 8, H S29010, I/A 27 (26.07.22).
Revocaciones. Apo.Sol.: AVILAS FERNANDEZ MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 1163 , F 105, S 8, H S 29010, I/A 28(26.07.22).
29 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1163 , F 104, S 8, H S 29010, I/A 26 (20.12.21).
24 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: SAN EMETERIO BEDIA ADRIANA. Datos registrales. T 1163 , F 103, S 8, H S 29010, I/A 24(17.06.21).
Nombramientos. Apoderado: DE DOLAREA FERNANDEZ MARIA DOLORES. Datos registrales. T 1163 , F 104, S 8, H S 29010,I/A 25 (17.06.21).
12 de Septiembre de 2019Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1163 , F 103, S 8, H S 29010, I/A 23 ( 3.09.19).
26 de Julio de 2018Revocaciones. Apoderado: LAFRAYA PUENTE DAVID. Datos registrales. T 1163 , F 103, S 8, H S 29010, I/A 21 (19.07.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: AVILAS FERNANDEZ MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 1163 , F 103, S 8, H S 29010, I/A 22(19.07.18).
31 de Mayo de 2018Modificaciones estatutarias. Modificado el artículo 7 de los estatutos sociales en cuanto al ejercicio de los derechos políticos yeconómicos en caso de prenda de las participaciones sociales. . Datos registrales. T 1163 , F 103, S 8, H S 29010, I/A 20 (25.05.18).
15 de Marzo de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN TORRES ALBERTO. Datos registrales. T 1163 , F 102, S 8, H S 29010, I/A 18 ( 6.03.18).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: APARICIO GUIRADO JOSE-MARIA. Datos registrales. T 1163 , F 103, S 8, H S 29010, I/A 19 (6.03.18).
24 de Noviembre de 2017Cambio de domicilio social. C/ CASTILLA Nº 38, BAJO (SANTANDER). Datos registrales. T 1163 , F 102, S 8, H S 29010, I/A 17(15.11.17).