Buscador CIF Logo

Actos BORME Inmobiliaria Juban Sociedad Anonima De Construcciones

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Inmobiliaria Juban Sociedad Anonima De Construcciones

Actos BORME Inmobiliaria Juban Sociedad Anonima De Construcciones - A28046811

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Inmobiliaria Juban Sociedad Anonima De Construcciones con CIF A28046811

🔙 Perfil de Inmobiliaria Juban Sociedad Anonima De Construcciones
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Inmobiliaria Juban Sociedad Anonima De Construcciones

30 de Octubre de 2020
Reelecciones. Adm. Mancom.: BANUS GUTIERREZ MANUEL;BANUS GUTIERREZ RAFAEL ANGEL. Datos registrales. T 32904 ,F 23, S 8, H M 45634, I/A 58 (23.10.20).

17 de Septiembre de 2019
Cambio de domicilio social. C/ NURIA Nº 59, 2º (MADRID). Datos registrales. T 32904 , F 23, S 8, H M 45634, I/A 57 (10.09.19).

11 de Octubre de 2017
Revocaciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: MORISON AC SLP. Datosregistrales. T 32904 , F 22, S 8, H M 45634, I/A 56 ( 4.10.17).

12 de Enero de 2017
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32904 , F 22, S 8, H M 45634,I/A 55 ( 3.01.17).

24 de Diciembre de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: BANUS GUTIERREZ RAFAEL;CAMPOS CASTAÑO EDUARDO. Nombramientos. Apoderado: BANUSGUTIERREZ RAFAEL;FRESNILLO DE LEON OSCAR. Cambio de domicilio social. TRVA DE COSTA BRAVA, NUMERO 6, 7ºC(MADRID). Datos registrales. T 32904 , F 21, S 8, H M 45634, I/A 54 (16.12.15).

09 de Diciembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: BANUS GUTIERREZ JUAN;BANUS ALEIXANDRE ALVARO. Nombramientos. Adm. Mancom.:BANUS GUTIERREZ MANUEL;BANUS GUTIERREZ RAFAEL ANGEL. Datos registrales. T 2626 , F 109, S 8, H M 45634, I/A 52(27.11.14).

Revocaciones. Apo.Manc.: BANUS FERRE ANTONIO;BANUS ALEIXANDRE ALVARO;BANUS GUTIERREZ JUAN;BANUSGUTIERREZ GONZALO ANTONIO;BANUS GUTIERREZ MANUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: BANUS GUTIERREZRAFAEL;CAMPOS CASTAÑO EDUARDO. Datos registrales. T 2626 , F 109, S 8, H M 45634, I/A 53 ( 1.12.14).

29 de Enero de 2014
Revocaciones. Apoderado: MALDONADO LOZANO MIGUEL ENRIQUE. Nombramientos. Apoderado: BANUS GUTIERREZMANUEL. Datos registrales. T 2626 , F 108, S 8, H M 45634, I/A 51 (22.01.14).

29 de Julio de 2013
Declaración de unipersonalidad. Socio único: COMERCIAL MIRASIERRA SA. Datos registrales. T 2626 , F 108, S 8, H M 45634,I/A 50 (22.07.13).

25 de Febrero de 2013
Ceses/Dimisiones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2626 , F 107, S 8, H M 45634,I/A 49 (18.02.13).

08 de Noviembre de 2012
Ampliacion del objeto social. ADQUISICION, ENAJENACION Y ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES RUSTICOS YURBANOS. PROMOCION INMOBILIARIA. Datos registrales. T 2626 , F 107, S 8, H M 45634, I/A 48 (26.10.12).

18 de Junio de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO GIL JOSE;LOPEZ ALONSO EMILIANO. Datos registrales. T 2626 , F 107, S 8, H M 45634, I/A47 ( 6.06.12).

27 de Enero de 2011
Otros conceptos: RECTIFICACION DEL PODER MANCOMUNADO CONFERIDO A DON ANTONIOBANUS FERRE, DON ALVAROBANUS ALEIXANDRE, DON JUAN BANUS GUTIERREZ, DON GONZALO ANTONIO BANUS GUTIERREZ Y DON MANUEL BANUSGUTIERREZ MEDIANTE ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 43&, EN CUANTO A LA FORMA DE ACTUACION DEDICHOS APODERADOS. Datos registrales. T 2626 , F 107, S 8, H M 45634, I/A 46 (13.01.11).

24 de Diciembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Presidente: GUTIERREZ FERNANDEZ CELIA. Secretario: BANUS GUTIERREZ GONZALO. Consejero: BANUSFERRE ANTONIO;BANUS GUTIERREZ GONZALO;GUTIERREZ FERNANDEZ CELIA. Con.Delegado: GUTIERREZ FERNANDEZCELIA. Nombramientos. Adm. Mancom.: BANUS GUTIERREZ JUAN;BANUS ALEIXANDRE ALVARO. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Consejo deadministración a Administradores mancomunados.MODIFICADOS LOS ARTICULOS 19, 24 Y 23 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES .Datos registrales. T 2626 , F 102, S 8, H M 45634, I/A 42 (14.12.10).

Nombramientos. Apo.Manc.: BANUS FERRE ANTONIO;BANUS ALEIXANDRE ALVARO;BANUS GUTIERREZ JUAN;BANUSGUTIERREZ GONZALO ANTONIO;BANUS GUTIERREZ MANUEL. Datos registrales. T 2626 , F 103, S 8, H M 45634, I/A 43(14.12.10).

Nombramientos. Apoderado: MALDONADO LOZANO MIGUEL ENRIQUE. Datos registrales. T 2626 , F 105, S 8, H M 45634, I/A44 (14.12.10).

Revocaciones. Apoderado: BANUS GUTIERREZ JUAN;BANUS GUTIERREZ GONZALO;BANUS GUTIERREZ MANUEL;BANUSALEIXANDRE ALVARO. Otros conceptos: REVOCADO EL PODER CONFERIDO A FAVOR DE DON ANTONIO BANUSFERRE YQUE CAUSO LA INSCRIPCION 20 . REVOCADOS LOS PODERES CONFERIDOS A FAVOR DE DON ANTONIO BANUS FERRE YDON JOSE MARIA GOMEZ MARTIN Y QUE CAUSO LA INSCRIPCION 22 . Datos registrales. T 2626 , F 107, S 8, H M 45634, I/A45 (14.12.10).

18 de Octubre de 2010
Reelecciones. Presidente: GUTIERREZ FERNANDEZ CELIA. Secretario: BANUS GUTIERREZ GONZALO. Consejero: BANUSFERRE ANTONIO;BANUS GUTIERREZ GONZALO;GUTIERREZ FERNANDEZ CELIA. Con.Delegado: GUTIERREZ FERNANDEZCELIA. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 21 DE LOS ESTATUTOS.. Datos registrales. T 2626 , F 102, S8, H M 45634, I/A 41 ( 5.10.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información