Actos BORME de Inmobiliaria Puerto De Vega Sa
07 de Octubre de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 19.893,47 Euros. Resultante Suscrito: 40.207,65 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:40.207,65 Euros. Desembolsado: 40.207,65 Euros. Resultante Suscrito: 80.415,30 Euros. Resultante Desembolsado: 80.415,30 Euros.Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 7. Capital social.-. Datos registrales. T 1405 , F 181, S 8, H AS 6440, I/A 25(29.09.22).
08 de Agosto de 2022Nombramientos. Auditor: ASTURAUDIMEBA SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1405 , F 181, S 8, H AS 6440, I/A 24(29.07.22).
10 de Diciembre de 2021Nombramientos. Cons.Del.Sol: VIDAL GARCIA MARIA VICTORIA. Apo.Sol.: VIDAL MUGA SERGIO ANDRES. Datos registrales. T1405 , F 38, S 8, H AS 6440, I/A 23 (30.11.21).
28 de Octubre de 2021Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: VIDAL GARCIA MARIA VICTORIA;VIDAL GARCIA MARIA DELMAR;VIDAL MUGA SERGIO ANDRES;VIDAL MUGA ALBERTO. Presidente: VIDAL GARCIA MARIA VICTORIA. Cons.Del.Sol: VIDALGARCIA MARIA VICTORIA;VIDAL MUGA SERGIO ANDRES. Secretario: VIDAL MUGA ALBERTO. Nombramientos. Consejero:VIDAL GARCIA MARIA VICTORIA;VIDAL MUGA ALBERTO;VIDAL MUGA SERGIO ANDRES;VIDAL GARCIA MARIA DEL MAR.Cons.Del.Sol: VIDAL MUGA SERGIO ANDRES. Presidente: VIDAL GARCIA MARIA VICTORIA. Secretario: VIDAL MUGA ALBERTO.Datos registrales. T 1405 , F 38, S 8, H AS 6440, I/A 22 (21.10.21).
27 de Agosto de 2019Revocaciones. Apoderado: PEREZ RIU PEDRO;SUAREZ GUTIERREZ VICTOR JOSE. Nombramientos. Cons.Del.Sol: VIDALGARCIA MARIA VICTORIA. Datos registrales. T 1405 , F 38, S 8, H AS 6440, I/A 21 (16.08.19).
16 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: VIDAL FERNANDEZ MANUEL. Datos registrales. T 1405 , F 37, S 8, H AS 6440, I/A 20 ( 9.07.19).
22 de Agosto de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: VIDAL FERNANDEZ MANUEL;VIDAL FERNANDEZ SERGIO;VIDAL GARCIA MARIAVICTORIA;VIDAL MUGA SERGIO ANDRES. Cons.Del.Sol: VIDAL FERNANDEZ MANUEL. Presidente: VIDAL FERNANDEZMANUEL. Cons.Del.Sol: VIDAL FERNANDEZ SERGIO. Secretario: VIDAL FERNANDEZ SERGIO. Nombramientos. Consejero:VIDAL GARCIA MARIA VICTORIA;VIDAL MUGA ALBERTO;VIDAL MUGA SERGIO ANDRES;VIDAL GARCIA MARIA DEL MAR.Presidente: VIDAL GARCIA MARIA VICTORIA. Secretario: VIDAL MUGA ALBERTO. Cons.Del.Sol: VIDAL MUGA SERGIO ANDRES.Datos registrales. T 1405 , F 37, S 8, H AS 6440, I/A 19 (11.08.16).
19 de Febrero de 2013Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 6. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ CABRALES 32 -ENTRESUELO IZQUIERDA (GIJON). Datos registrales. T 1405 , F 37, S 8, H AS 6440, I/A 18 (11.02.13).
24 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: VIDAL GARCIA MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 1405 , F 36, S 8, H AS 6440, I/A 17(14.02.12).
10 de Enero de 2011Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: VIDAL FERNANDEZ SERGIO;VIDAL FERNANDEZ MANUEL. Nombramientos. Cons.Del.Sol:VIDAL FERNANDEZ SERGIO;VIDAL FERNANDEZ MANUEL. Reelecciones. Consejero: VIDAL FERNANDEZ SERGIO;VIDALFERNANDEZ MANUEL;VIDAL GARCIA MARIA VICTORIA;VIDAL MUGA SERGIO ANDRES. Presidente: VIDAL FERNANDEZMANUEL. Secretario: VIDAL FERNANDEZ SERGIO. Datos registrales. T 1405 , F 35, S 8, H AS 6440, I/A 16 (28.12.10).
03 de Febrero de 2010Nombramientos. Apoderado: VIDAL MUGA ALBERTO. Datos registrales. T 1405 , F 35, S 8, H AS 6440, I/A 15 (25.01.10).