Actos BORME de Inmobiliaria Rio Trujillo Sa
27 de Julio de 2023Reelecciones. Consejero: LOPEZ CANTALAPIEDRA ANA. Datos registrales. T 5059 , F 224, S 8, H M 32352, I/A 50 (20.07.23).
16 de Agosto de 2021Reelecciones. Consejero: ANGUIANO JIMENEZ PABLO. Datos registrales. T 5059 , F 224, S 8, H M 32352, I/A 49 ( 9.08.21).
04 de Diciembre de 2020Reelecciones. Consejero: MONTES TOYOS JOSE LUIS;GOIZUETA GRASSET FRANCISCO JAVIER;CANSECO VIEJO ANTONIO.Datos registrales. T 5059 , F 224, S 8, H M 32352, I/A 48 (27.11.20).
22 de Octubre de 2019Reelecciones. Consejero: ZAFRA ARROYO PEDRO GIL. Presidente: ZAFRA ARROYO PEDRO GIL. Datos registrales. T 5059 , F223, S 8, H M 32352, I/A 47 (15.10.19).
20 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGO ARAMBURU FERNANDO. Secretario: RODRIGO ARAMBURU FERNANDO.Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: POINTON JAMES ALEXANDER. Revocaciones. Apo.Man.Soli:RODRIGO ARAMBURU FERNANDO. Nombramientos. SecreNoConsj: RAMIREZ CORROTO JOSE ANTONIO. Apo.Man.Soli:RAMIREZ CORROTO JOSE ANTONIO. Consejero: LOPEZ CANTALAPIEDRA ANA. Apo.Manc.: ZAFRA ARROYO PEDRO. Datosregistrales. T 5059 , F 222, S 8, H M 32352, I/A 46 (12.12.18).
11 de Octubre de 2016Reelecciones. Consejero: ANGUIANO JIMENEZ PABLO. Datos registrales. T 5059 , F 222, S 8, H M 32352, I/A 45 ( 3.10.16).
21 de Enero de 2016Otros conceptos: MODIFICACION Y NUEVA REDACCION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA SU ADAPTACION A LA LEYDE SOCIEDADES DE CAPITAL . Datos registrales. T 5059 , F 218, S 8, H M 32352, I/A 44 (13.01.16).
18 de Noviembre de 2015Reelecciones. Consejero: MONTES TOYOS JOSE LUIS;GOIZUETA GRASSET FRANCISCO JAVIER;CANSECO VIEJOANTONIO;RODRIGO ARAMBURU FERNANDO. Secretario: RODRIGO ARAMBURU FERNANDO. Datos registrales. T 5059 , F 218,S 8, H M 32352, I/A 43 (10.11.15).
19 de Septiembre de 2014Reelecciones. Consejero: ZAFRA ARROYO PEDRO. Presidente: ZAFRA ARROYO PEDRO. Datos registrales. T 5059 , F 218, S 8,H M 32352, I/A 42 (11.09.14).
10 de Julio de 2014Nombramientos. Consejero: POINTON JAMES ALEXANDER. Datos registrales. T 5059 , F 218, S 8, H M 32352, I/A 41 ( 3.07.14).
17 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: ZAFRA ARROYO PEDRO. Presidente: RODRIGO ARAMBURU FERNANDO. SecreNoConsj:GARCIA MORENO LOPEZ POZUELO ANTONIO. Revocaciones. Apoderado: RODRIGO ARAMBURU FERNANDO;GARCIAMORENO LOPEZ POZUELO ANTONIO;GOIZUETA GRASSET FRANCISCO JAVIER;DIAZ CANEJA BURGALETAFERNANDO;GARCIA MORENO LOPEZ POZUELO ANTONIO;GARCIA MORENO LOPEZ POZUELO ANTONIO;MILLAN PISONEROMANUEL. Nombramientos. Presidente: ZAFRA ARROYO PEDRO. Secretario: RODRIGO ARAMBURU FERNANDO. Apo.Man.Soli:ZAFRA ARROYO PEDRO;RODRIGO ARAMBURU FERNANDO;GOIZUETA GRASSET JAVIER. Datos registrales. T 5059 , F 216, S8, H M 32352, I/A 40 ( 4.05.12).
27 de Octubre de 2011Reelecciones. Presidente: RODRIGO ARAMBURU FERNANDO. Datos registrales. T 5059 , F 215, S 8, H M 32352, I/A 38(18.10.11).
Reelecciones. Consejero: ANGUIANO JIMENEZ PABLO. Datos registrales. T 5059 , F 216, S 8, H M 32352, I/A 39 (18.10.11).
13 de Mayo de 2011Reelecciones. Consejero: MONTES TOYOS JOSE LUIS;GOIZUETA GRASSET FRANCISCO JAVIER;CANSECO VIEJOANTONIO;RODRIGO ARAMBURU FERNANDO. Datos registrales. T 5059 , F 215, S 8, H M 32352, I/A 37 ( 3.05.11).
11 de Junio de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ CANEJA BURGALETA FERNANDO. Reelecciones. Vicepresid.: ZAFRA ARROYO PEDRO.Consejero: ZAFRA ARROYO PEDRO. Datos registrales. T 5059 , F 215, S 8, H M 32352, I/A 36 (31.05.10).