Actos BORME de Inmuebles Regina Sociedad Anonima
31 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Co.De.Ma.So: FERNANDEZ MESEGUER ANA;FERNANDEZ MESEGUER JOSE. Nombramientos.Cons.Del.Sol: FERNANDEZ MESEGUER JOSE. Cons.Del.Man: FERNANDEZ MESEGUER JOSE. Cons.Del.Sol: FERNANDEZMESEGUER ANA. Cons.Del.Man: FERNANDEZ MESEGUER ANA. Reelecciones. Consejero: FERNANDEZ MESEGUERANA;FERNANDEZ MESEGUER ELOY;FERNANDEZ MESEGUER JOSE;FERNANDEZ MESEGUER LUIS. Presidente: FERNANDEZMESEGUER LUIS. Secretario: FERNANDEZ MESEGUER ELOY. Vicepresid.: FERNANDEZ MESEGUER ANA. Datos registrales. T26342 , F 74, S 8, H M 74118, I/A 45 (24.01.22).
29 de Octubre de 2020Cambio de domicilio social. C/ EMBAJADORES 203, BAJO (MADRID). Datos registrales. T 26342 , F 74, S 8, H M 74118, I/A 44(22.10.20).
08 de Abril de 2019Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 200 (MADRID). Datos registrales. T 26342 , F 74, S 8, H M 74118, I/A43 ( 1.04.19).
06 de Julio de 2018Otros conceptos: Subsanaci贸n de los acuerdos Segundo y Tercero de los adoptados por el Consejo de Administraci贸n de fecha 8 deenero de 2018, en cuanto a la omisi贸n en el acuerdo Segundo, de la referencia a las facultades recogidas en el n煤mero 10; y, elacuerdo Tercero, la omisi贸n del n煤mero 4 de las facultades. Datos registrales. T 26342 , F 72, S 8, H M 74118, I/A 42 (28.06.18).
27 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: FERNANDEZ MESEGUER JOSE. Nombramientos. Co.De.Ma.So: FERNANDEZ MESEGUERANA;FERNANDEZ MESEGUER JOSE. Apo.Manc.: FERNANDEZ MESEGUER LUIS;FERNANDEZ MESEGUER ELOY. Datosregistrales. T 26342 , F 71, S 8, H M 74118, I/A 41 (19.03.18).
18 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ ALVAREZ-CASTELLANOS LUIS. Presidente: FERNANDEZ ALVAREZ-CASTELLANOSLUIS. Consejero: MESEGUER BERNAL ANA MARIA. Vicepresid.: MESEGUER BERNAL ANA MARIA. Consejero: FERNANDEZMESEGUER ELOY. Con.Delegado: FERNANDEZ MESEGUER ELOY. Secretario: FERNANDEZ MESEGUER ELOY. Consejero:FERNANDEZ MESEGUER LUIS. Vicesecret.: FERNANDEZ MESEGUER LUIS. Consejero: FERNANDEZ MESEGUERANA;FERNANDEZ MESEGUER JOSE. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ MESEGUER ANA;FERNANDEZ MESEGUERELOY;FERNANDEZ MESEGUER JOSE;FERNANDEZ MESEGUER LUIS. Presidente: FERNANDEZ MESEGUER LUIS. Secretario:FERNANDEZ MESEGUER ELOY. Vicepresid.: FERNANDEZ MESEGUER ANA. Con.Delegado: FERNANDEZ MESEGUER JOSE.Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 12 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES . Datos registrales. T 26342 , F70, S 8, H M 74118, I/A 40 ( 8.11.16).
06 de Octubre de 2014Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MESEGUER JOSE. Datos registrales. T 26342 , F 69, S 8, H M 74118, I/A 39(26.09.14).
05 de Julio de 2013Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ MESEGUER JOSE. Datos registrales. T 26342 , F 69, S 8, H M 74118, I/A 38 (27.06.13).
24 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: MESEGUER BERNAL ANA MARIA. Presidente: MESEGUER BERNAL ANA MARIA. Consejero:FERNANDEZ ALVAREZ-CASTELLANOS LUIS. Vicepresid.: FERNANDEZ ALVAREZ-CASTELLANOS LUIS. Consejero: FERNANDEZMESEGUER ELOY. Secretario: FERNANDEZ MESEGUER ELOY. Consejero: FERNANDEZ MESEGUER LUIS. Vicesecret.:FERNANDEZ MESEGUER LUIS. Consejero: FERNANDEZ MESEGUER JOSE;FERNANDEZ MESEGUER ANA. Con.Delegado:FERNANDEZ ALVAREZ-CASTELLANOS LUIS. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ ALVAREZ-CASTELLANOS LUIS.Presidente: FERNANDEZ ALVAREZ-CASTELLANOS LUIS. Consejero: MESEGUER BERNAL ANA MARIA. Vicepresid.: MESEGUERBERNAL ANA MARIA. Consejero: FERNANDEZ MESEGUER ELOY. Con.Delegado: FERNANDEZ MESEGUER ELOY. Secretario:FERNANDEZ MESEGUER ELOY. Consejero: FERNANDEZ MESEGUER LUIS. Vicesecret.: FERNANDEZ MESEGUER LUIS.Consejero: FERNANDEZ MESEGUER ANA;FERNANDEZ MESEGUER JOSE. Datos registrales. T 26342 , F 69, S 8, H M 74118, I/A37 (16.04.13).
06 de Febrero de 2012Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.465.422,20 Euros. Desembolsado: 2.465.422,20 Euros. Resultante Suscrito: 3.079.614,15 Euros.Resultante Desembolsado: 3.079.614,15 Euros. Datos registrales. T 26342 , F 68, S 8, H M 74118, I/A 36 (25.01.12).
17 de Noviembre de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 472.956,95 Euros. Desembolsado: 472.956,95 Euros. Resultante Suscrito: 614.191,95 Euros.Resultante Desembolsado: 614.191,95 Euros. Datos registrales. T 26342 , F 67, S 8, H M 74118, I/A 35 ( 5.11.10).
08 de Junio de 2010Nombramientos. Auditor: PE脩ARANDA GOMEZ JULIAN. Aud.Supl.: MIRO OROZCO VICENTE. Datos registrales. T 26342 , F 67,S 8, H M 74118, I/A 34 (26.05.10).
20 de Mayo de 2009Nombramientos. Apoderado: MESEGUER BERNAL ANA MARIA. Datos registrales. T 26342 , F 66, S 8, H M 74118, I/A 33 (8.05.09).