Actos BORME de Innoquant Strategic Analytics Sl
27 de Abril de 2021Revocaciones. CONSEJERO: GONZALEZ GUTIERREZ MARIA FERNANDA. PRESIDENTE: GONZALEZ GUTIERREZ MARIAFERNANDA. CONSEJERO: OLEG MORAJKO. VICEPRESIDEN: OLEG MORAJKO. CONSEJERO: VILAJOSANA GUILLEN IGNASI.APODERAD.SOL: GONZALEZ GUTIERREZ MARIA FERNANDA. SECR.NO CONS: JIMENEZ BORRAS CARLOS. V-SEC NO CON:POMPOSO SANTOS ANA MARIA. CONSEJERO: POAL MARCET JOSE. Nombramientos. CONSEJERO: POAL MARCET JOSE.ADM.UNICO: OLEG IGOR MORAJKO. Datos registrales. T 42975 , F 48, S 8, H B 393442, I/A 20 (15.04.21).
26 de Marzo de 2021Nombramientos. V-SEC NO CON: POMPOSO SANTOS ANA MARIA. Datos registrales. T 42975 , F 48, S 8, H B 393442, I/A 19(17.03.21).
29 de Mayo de 2020Cambio de domicilio social. CL TARRAGONA NUM.161 P.12,MODULO A (BARCELONA). Datos registrales. T 42975 , F 48, S 8,H B 393442, I/A 18 (20.05.20).
30 de Agosto de 2019Revocaciones. SECR.NO CONS: BERTOLIN GUTIERREZ ALVAR. Nombramientos. SECR.NO CONS: JIMENEZ BORRASCARLOS. Datos registrales. T 42975 , F 48, S 8, H B 393442, I/A 17 (22.08.19).
04 de Marzo de 2019Revocaciones. DTOR.GENERAL: OLEG MORAJKO;GONZALEZ GUTIERREZ MARIA FERNANDA. Nombramientos.APODERAD.SOL: GONZALEZ GUTIERREZ MARIA FERNANDA;OLEG MORAJKO. Datos registrales. T 42975 , F 46, S 8, H B393442, I/A 16 (21.02.19).
24 de Enero de 2019Revocaciones. CONSEJERO: PHILLIPE VIMARD. Ampliaci贸n de capital. Capital: 494,53 Euros. Resultante Suscrito: 4.958,53Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 7. MODIFICACION DEL NUMERO Y VALOR NOMINAL DE LASPARTICIPACIONES. ARTICULO 13. CONVOCATORIA. CREACION DE LA PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD. P谩gina web de lasociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.mocaplatform.com. Datos registrales. T 42974 , F 190, S 8, H B 393442, I/A15 (16.01.19).
14 de Noviembre de 2017Nombramientos. CONSEJERO: VILAJOSANA GUILLEN IGNASI. Ampliaci贸n de capital. Capital: 248,00 Euros. ResultanteSuscrito: 4.464,00 Euros. Datos registrales. T 42974 , F 189, S 8, H B 393442, I/A 14 ( 3.11.17).
06 de Noviembre de 2017Revocaciones. CONSEJERO: INVEREADY ASSET MANAGEMENT SGECR SA. REPR.143 RRM: FONTS CAVESTANY IGNACIO.Datos registrales. T 42974 , F 189, S 8, H B 393442, I/A 13 (24.10.17).
21 de Agosto de 2017Revocaciones. CONSEJERO: PEREZ OLMO EDUARD. SECR.NO CONS: LEXCREA SLP. REPR.143 RRM: MARTINEZ LOSASSILVIA. Nombramientos. SECR.NO CONS: BERTOLIN GUTIERREZ ALVAR. Datos registrales. T 42974 , F 189, S 8, H B 393442,I/A 12 (10.08.17).
22 de Enero de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 30,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.367,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 849,00Euros. Resultante Suscrito: 4.216,00 Euros. Datos registrales. T 41688 , F 191, S 8, H B 393442, I/A 11 (15.01.16).
04 de Diciembre de 2015Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: GONZALEZ GUTIERREZ MARIA FERNANDA;OLEG MORAJKO. Nombramientos. CONSEJERO:INVEREADY ASSET MANAGEMENT SGECR SA. REPR.143 RRM: FONTS CAVESTANY IGNACIO. CONSEJERO: PHILLIPEVIMARD;PEREZ OLMO EDUARD;GONZALEZ GUTIERREZ MARIA FERNANDA. PRESIDENTE: GONZALEZ GUTIERREZ MARIAFERNANDA. CONSEJERO: OLEG MORAJKO. VICEPRESIDEN: OLEG MORAJKO. SECR.NO CONS: LEXCREA SLP. REPR.143RRM: MARTINEZ LOSAS SILVIA. DTOR.GENERAL: OLEG MORAJKO;GONZALEZ GUTIERREZ MARIA FERNANDA. Datosregistrales. T 41688 , F 189, S 8, H B 393442, I/A 10 (26.11.15).
19 de Agosto de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 17,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.397,00 Euros. Datos registrales. T 41688 , F 188, S 8, H B393442, I/A 9 (12.08.15).
29 de Julio de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 78,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.296,00 Euros. Datos registrales. T 41688 , F 187, S 8, H B393442, I/A 7 (21.07.15).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 84,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.380,00 Euros. Datos registrales. T 41688 , F 188, S 8, H B393442, I/A 8 (21.07.15).
18 de Noviembre de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 18,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.218,00 Euros. Datos registrales. T 41688 , F 187, S 8, H B393442, I/A 6 (11.11.14).
24 de Marzo de 2014Cambio de domicilio social. AV TORREBLANCA,57, OFICINA A106 (SANT CUGAT DEL VALLES). Datos registrales. T 41688 , F187, S 8, H B 393442, I/A 5 (17.03.14).
13 de Noviembre de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 116,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.128,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 72,00 Euros.Resultante Suscrito: 3.200,00 Euros. Datos registrales. T 41688 , F 186, S 8, H B 393442, I/A 4 ( 5.11.13).
18 de Enero de 2013Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: GONZALEZ GUTIERREZ MARIA FERNANDA;OLEG MORAJKO. Modificaciones estatutarias.ART.9:TRANSMISION DE PARTICIPACIONES SOCIALES. Otros conceptos: PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDADUNIPERSONAL. Datos registrales. T 41688 , F 185, S 8, H B 393442, I/A 3 (10.01.13).
04 de Noviembre de 2010Cambio de domicilio social. CL LLACUNA 162-164 (BARCELONA). Datos registrales. T 41688 , F 185, S 8, H B 393442, I/A 2(21.10.10).
22 de Febrero de 2010Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 25.01.10. Objeto social: LAS SOLUCIONES ALGORITMICAS AVANZADAS Y LACOMPUTACION DE ALTO NIVEL TENIENDO COMO BASE LAS MATEMATICAS,LA FISICA Y LAINFORMATICA.ESPECIALIZACION ENMONITORIZACION,ANALISIS DE LA INFORMACION GENERADA EN REDES FISICAS,ETC.Domicilio: AV RIERA DE SAN LORENZO Num.189 P.1 (GAVA). Capital: 3.012,00 Euros. Nombramientos. ADM.UNICO: GONZALEZGUTIERREZ MARIA FERNANDA. Otros conceptos: DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICODO脩A MARIA FERNANDA GONZALEZ GUTIERREZ. Datos registrales. T 41688 , F 182, S 8, H B 393442, I/A 1 ( 9.02.10).