Buscador CIF Logo

Actos BORME Innovations Zamora Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Innovations Zamora Sl

Actos BORME Innovations Zamora Sl - B30885511

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Murcia para Innovations Zamora Sl con CIF B30885511

馃敊 Perfil de Innovations Zamora Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Murcia

Actos BORME de Innovations Zamora Sl

29 de Diciembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Liquidador: JOSE MARIA DE SANTIAGO RESTOY. Adm. Unico: DIEGO ZAMORA SA. Revocaciones.Apoderado: JUAN JOSE GALINDO BROCAL. Apo.Man.Soli: MARIA DEL CARMEN VALLEJO SANCHEZ. Apoderado: JUAN JOSEGALINDO BROCAL. Apo.Sol.: ANDRES JOSE AYALA SANCHEZ;JUAN JOSE FANLO GOMEZ. Apo.Man.Soli: JAVIER PIJOANMARIN;MONTSERRAT DIEZ RIVAS;RAUL BORREGUERO MARTIN;SARA GUILLEN ZAMORA;ENRIQUE DE COIG O`DONNELLLOPEZ;QUERUBINA HERNANDEZ VIVANCOS;JAVIER PIJOAN MARIN;MONTSERRAT DIEZ RIVAS;RAUL BORREGUEROMARTIN;SARA GUILLEN ZAMORA. Apo.Sol.: QUERUBINA HERNANDEZ VIVANCOS. Nombramientos. Liquidador: JOSE MARIADE SANTIAGO RESTOY. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 3573 , F 140, S 8, H MU 85663, I/A 20(21.12.23).

18 de Enero de 2023
Nombramientos. Apo.Man.Soli: JAVIER PIJOAN MARIN;MONTSERRAT DIEZ RIVAS;RAUL BORREGUERO MARTIN;SARAGUILLEN ZAMORA. Apo.Sol.: QUERUBINA HERNANDEZ VIVANCOS. Datos registrales. T 3573 , F 138, S 8, H MU 85663, I/A 19(11.01.23).

17 de Mayo de 2022
Revocaciones. Apoderado: SARA GUILLEN ZAMORA;QUERUBINA HERNANDEZ VIVANCOS. Apo.Man.Soli: ENRIQUE DE COIGO'DONNELL LOPEZ. Apoderado: ENRIQUE DE COIG O`DONNELL LOPEZ;QUERUBINA HERNANDEZ VIVANCOS;QUERUBINAHERNANDEZ VIVANCOS;RAUL BORREGUERO MARTIN. Datos registrales. T 3573 , F 138, S 8, H MU 85663, I/A 18 ( 9.05.22).

06 de Mayo de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: JAVIER PIJOAN MARIN;MONTSERRAT DIEZ RIVAS;RAUL BORREGUERO MARTIN;SARAGUILLEN ZAMORA;ENRIQUE DE COIG O`DONNELL LOPEZ;QUERUBINA HERNANDEZ VIVANCOS. Datos registrales. T 3196 , F75, S 8, H MU 85663, I/A 17 (28.04.22).

05 de Mayo de 2021
Revocaciones. Apoderado: LORENZO IGNACIO GUERRA FAGALDE;LORENZO IGNACIO GUERRA FAGALDE. Datosregistrales. T 3196 , F 75, S 8, H MU 85663, I/A 15 (27.04.21).

15 de Marzo de 2018
Nombramientos. Apoderado: LORENZO IGNACIO GUERRA FAGALDE. Datos registrales. T 3196 , F 73, S 8, H MU 85663, I/A 13( 8.03.18).

Nombramientos. Apoderado: RAUL BORREGUERO MARTIN. Datos registrales. T 3196 , F 74, S 8, H MU 85663, I/A 14 ( 8.03.18).

15 de Septiembre de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: ANDRES JOSE AYALA SANCHEZ;JUAN JOSE FANLO GOMEZ. Datos registrales. T 3196 , F 73, S 8,H MU 85663, I/A 12 ( 8.09.17).

22 de Julio de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 14.490,00 Euros. Resultante Suscrito: 314.490,00 Euros. Datos registrales. T 3049 , F 7, S 8, H MU85663, I/A 6 (15.07.15).

21 de Julio de 2014
Nombramientos. Apoderado: SARA GUILLEN ZAMORA. Datos registrales. T 3049 , F 3, S 8, H MU 85663, I/A 2 (14.07.14).

Nombramientos. Apoderado: QUERUBINA HERNANDEZ VIVANCOS. Datos registrales. T 3049 , F 5, S 8, H MU 85663, I/A 3(14.07.14).

Nombramientos. Apoderado: JUAN JOSE GALINDO BROCAL. Datos registrales. T 3049 , F 5, S 8, H MU 85663, I/A 4 (14.07.14).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ENRIQUE DE COIG O'DONNELL LOPEZ;MARIA DEL CARMEN VALLEJO SANCHEZ. Datosregistrales. T 3049 , F 6, S 8, H MU 85663, I/A 5 (14.07.14).

18 de Julio de 2014
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 23.06.14. Objeto social: 1.- El desarrollo, homologaci贸n y lanzamiento de bebidasalcoh贸licas y no alcoh贸licas. 2.- La investigaci贸n y desarrollo de nuevos productos e ingredientes. 3.- La implantaci贸n de sistemas de

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n