Actos BORME de Instalaciones Inabensa Sa
01 de Junio de 2023Revocaciones. Apoderado: FRANCO IZQUIERDO ANTONIO. Apo.Manc.: RAMON JERONIMO MILAGROS;PEREZ ARIZA MARIARESURRECCION;MOREIRA GARCIA PAULA;DELGADO BALLESTA JESUS;FRANCO IZQUIERDO ANTONIO;INFANTE COSSIOPABLO DAVID. Apo.Sol.: FRANCO IZQUIERDO ANTONIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: LECAROZ MUÑOZ RAFAEL.Apo.Manc.: INFANTE COSSIO PABLO DAVID. Otros conceptos: REVOCADOS la totalidad de los poderes otorgados a favor de donAntonio Franco Izquierdo, tanto inscritos como posibles otorgados y no inscritos en este Registro, en la hoja registral de la sociedad.Datos registrales. T 6622 , F 146, S 8, H SE 20724, I/A 451 (24.05.23).
29 de Mayo de 2023Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2021 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 6620 , F 105, S 8, H SE 20724, I/A 450 (19.05.23).
20 de Febrero de 2023Otros conceptos: "ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP.", con NIF B28266526, designa como representante persona física a donGuillermo Ramos González, con D.N.I. 25.065.852-S. Situación concursal. Procedimiento concursal 820/2022. FIRME: Si, Fecha deresolución 10/11/2022. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DESEVILLA. Juez: JESUS GINES GABALDON CODESIDO. Resoluciones: Practicada INSCRIPCION DE LA DECLARACION DECONCURSO VOLUNTARIO. Situación concursal. Procedimiento concursal 820/2022. FIRME: Si, Fecha de resolución 10/11/2022.Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. Juzgado:num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE SEVILLA. Juez: JESUS GINES GABALDON CODESIDO. Resoluciones:INTERVENCION. Situación concursal. Procedimiento concursal 820/2022. Fecha de resolución 10/11/2022. Nombramiento deadministradores. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE SEVILLA. Juez: JESUS GINES GABALDONCODESIDO. Administrador Concursal. Fecha 10/11/2022, NIF/CIF B28266526. ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP. Datosregistrales. T 6620 , F 105, S 8, H SE 20724, I/A 449 (10.02.23).
27 de Octubre de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL;MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL. Apo.Man.Soli:
13 de Julio de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: CABEZAS CARBONELL SANTIAGO;MARTIN ATUCHA MARIA;VERGARA LOPEZ ALBERTO.Apo.Sol.: BALBOA LINARES SALVADOR. Datos registrales. T 6620 , F 104, S 8, H SE 20724, I/A 447 ( 6.07.22).
24 de Marzo de 2022Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2020 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 6620 , F 104, S 8, H SE 20724, I/A 446 (15.03.22).
18 de Octubre de 2021Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: MODIFICACION DEL ARTICULO 3º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.Cambio de domicilio social. C/ ENERGIA SOLAR 1 - CAMPUS PALMAS ALTAS (SEVILLA). Datos registrales. T 6620 , F 103, S8, H SE 20724, I/A 444 ( 7.10.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: GOMEZ GARCIA GONZALO. Apo.Man.Soli: GOMEZ GARCIA GONZALO;GOMEZ GARCIA GONZALO.Apo.Sol.: GOMEZ GARCIA GONZALO. Apo.Manc.: GOMEZ GARCIA GONZALO;GOMEZ GARCIA GONZALO;GOMEZ GARCIAGONZALO;GOMEZ GARCIA GONZALO. Apo.Sol.: GOMEZ GARCIA GONZALO. Apo.Manc.: GOMEZ GARCIA GONZALO. Apo.Sol.:SANTOS ESCOLANO JUAN;SANTOS ESCOLANO JUAN;SANTOS ESCOLANO JUAN. Otros conceptos: Revocar la totalidad delos poderes otorgados, inscritos y no inscritos, en nombre y presentación de la Sociedad, así como de cualquiera de sus UnionesTemporales de Empresas, Establecimientos Permanentes y/o Sucursales, a favor de D. Gonzalo Gómez García. Revocados lospoderes otorgados, en nombre y presentación de la Sociedad, así como de cualquiera de sus Uniones Temporales de Empresas, afavor de D. Francisco Moreno Pantoja -no constando inscrito ninguno en este Registro a favor de dicho señor. Datos registrales. T6620 , F 103, S 8, H SE 20724, I/A 4445 ( 7.10.21).
01 de Septiembre de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ SANCHEZ JOSE MANUEL. Otros conceptos: REVOCA y deja sin efecto la totalidad de lospoderes y cargos otorgados en nombre y representación de la sociedad, así como de cualquiera de sus Uniones Temporales deEmpresas, Establecimientos Permanentes y/o Sucursales, a favor de DON JOSE MANUEL LOPEZ SANCHEZ, D.N.I. 29.439.386-F.REVOCA los poderes no inscritos otorgados a JOSE MANUEL LOPEZ SANCHEZ, D.N.I. 29.439.386-F, conferidos en escrituras: -23/03/2017, notario de Madrid, José Miguel García Lombardía, 1.196 protocolo; 9/03/2015 y 7/09/2015, notario de Sevilla, José RuizGranados, 796 y 2.627 protocolos, respectivamenteREVOCA y deja sin efecto la totalidad de los poderes otorgados, en nombre yrepresentación de la sociedad así como de cualquiera de sus Uniones Temporales de Empresas, Establecimientos Permanentes y/oSucursales, a favor de DON DANIEL ALAMINOS ECHARRI, D.N.I. 07.492.396-P. REVOCA y deja sin efecto la totalidad de lospoderes otorgados, en nombre y representación de la sociedad así como de cualquiera de sus Uniones Temporales de Empresas,Establecimientos Permanentes y/o Sucursales, a favor de DON MIGUEL ANGEL JIMENEZ VELASCO MAZARIO, D.N.I. 28.874.696-JREVOCA el poder no inscrito conferido a favor de DON DANIEL ALAMINOS ECHARRI, D.N.I. 07.492.396-P y DON MIGUEL ANGELJIMENEZ VELASCO MAZARIO, D.N.I. 28.874.696-J, en escritura de fecha 7/09/2015, notario de Sevilla, José Ruiz Granados, 2.627de su protocolo. Datos registrales. T 6620 , F 102, S 8, H SE 20724, I/A 443 (24.08.21).
19 de Julio de 2021Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2019 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 6620 , F 102, S 8, H SE 20724, I/A 441 ( 6.07.21).
Otros conceptos: CAMBIADO el representante persona física de la entidad "ABENGOA ABENEWCO 1, S.A.", administradora únicade "INSTALACIONES INABENSA SA", renuncia don Joaquín Fernández de Piérola Marín, y se nombra a DON JUAN PABLO LOPEZ-BRAVO VELASCO, con D.N.I. número 50.694.706-S.- Datos registrales. T 6620 , F 102, S 8, H SE 20724, I/A 442 ( 8.07.21).
18 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO RUIZ JOSE;SANTOS ESCOLANO JUAN;COLLADO YOLDI FELIPE JOSE;CEINOS MORENOJORGE. Datos registrales. T 6626 , F 95, S 8, H SE 20724, I/A 440 (11.05.21).
13 de Abril de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ VAZQUEZ ALFONSO. Apoderado: MARTIN DE BRIONES IGNACIO. Nombramientos.Apoderado: FRANCO IZQUIERDO ANTONIO. Apo.Manc.: FRANCO IZQUIERDO ANTONIO;INFANTE COSSIO PABLODAVID;PEREZ ARIZA MARIA RESURRECCION;MOREIRA GARCIA PAULA;DELGADO BALLESTA JESUS;CABEZAS CARBONELLSANTIAGO;RAMON JERONIMO MILAGROS;GOMEZ GARCIA GONZALO. Apo.Sol.: FRANCO IZQUIERDO ANTONIO. Otrosconceptos: La Sociedad REVOCA el PODER NO INSCRITO, conferido a favor de DON JOSE GONGORA GUZMAN, con N.I.F.número 28.774.964-D, en escritura de fecha 27 de enero de 2021, ante el notario de Madrid, don José Miguel García Lombardía, con elnúmero 379 de su protocolo, La Sociedad revoca y deja sin efecto la totalidad de los poderes conferidos, en nombre y representaciónde la Sociedad así como de cualquiera de sus Uniones Temporales de Empresas, Establecimientos Permanentes y/o Sucursales, afavor de DON IGNACIO MARTIN DE BRIONES. Datos registrales. T 6620 , F 98, S 8, H SE 20724, I/A 438 ( 5.04.21).
Otros conceptos: La Sociedad REVOCA el PODER NO INSCRITO, conferido a favor de DON IGNACIO MARTIN DE BRIONES. LaSociedad REVOCA los PODERES NO INSCRITOS, conferidos a favor de DON PABLO INFANTE COSSIO, DON IGNACIO MARTINDE BRIONES, DON JULIO ARTILLO GRAU; DON MANUEL JIMENEZ AGUI LAR, DON ALBERTO VERGARA LOPEZ, DONSALVADOR BALBOA LINARES, DON SANTIAGO CORREA PORTILLO, DON ALFONSO GONZALEZ DOMINGUEZ, DON MLaSociedad REVOCA los PODERES NO INSCRITOS, conferidos a favor de DON CESAR HERNANDEZ CHICO, DON JOSE LUISGALINDO CORVILLO, DON SANTIAGO CABEZAS CARBONELL, DON JESUS DE MIGUEL FERNANDEZ, DON MANUEL GARCIALAFFITE, y DON IGNACIO MARTIN DE BRIONES. La Sociedad REVOCA los PODERES NO INSCRITOS, conferidos a favor de DONJULIO ARTILLO GRAU, DON ALBERTO VERGARA LOPEZ, DON JOSE LEAL DEL OJO CHAMORRO, DON MIGUEL ANGELMASERAS GUTIERREZ, DON OSWALDO FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ, DON JOSE LUIS GALINDO CORVILLO, y DONIGNACIO MARTIN DE BRIONES. La Sociedad REVOCA los PODERES NO INSCRITOS, conferidos a favor de DON RAUL PEREZSANTIAGO, DON ALBERTO VERGARA LOPEZ; DON JOSE GONGORA GUZMAN, DON JOSE MARIA MURO ALVAREZ; y DON ALIMUSA SOUTO. Datos registrales. T 6620 , F 101, S 8, H SE 20724, I/A 439 ( 5.04.21).
25 de Enero de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: CERON RAIGON FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: CERON RAIGON FRANCISCO JAVIER. Datosregistrales. T 6620 , F 98, S 8, H SE 20724, I/A 437 (15.01.21).
19 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ VAZQUEZ ALFONSO. Datos registrales. T 6620 , F 96, S 8, H SE 20724, I/A 434(11.11.20).
Revocaciones. Apo.Sol.: CANELO GOMEZ JORGE. Apo.Manc.: CANELO GOMEZ JORGE;CANELO GOMEZ JORGE;CANELOGOMEZ JORGE;CANELO GOMEZ JORGE. Apo.Sol.: CANELO GOMEZ JORGE. Otros conceptos: REVOCADOS todos losposibles poderes otorgados a favor de don Jorge Canelo Gómez y no inscritos en este Registro.- REVOCADO el poder conferido afavor de don Jorge Canelo Gómez en virtud de escritura 5.132 de 7 de noviembre de 2018, otorgada ante el notario de Madrid, D. JoséMiguel García Lombardía, NO INSCRITO en este Registro.- Revocado el poder conferido a favor de don Jorge Canelo Gómez en virtudde la escritura 1.336 de 4 de junio de 2019, otorgada ante notario de Sevilla, D. José Ignacio Guajardo-Fajardo Colunga, NOINSCRITO en este Registro.- REVOCADO el poder conferido a favor de don Jorge Canelo Gómez en virtud de la escritura 3007 de 11de diciembre de 2019, otorgada ante el notario de Sevilla, D. José Ignacio Guajardo-Fajardo Colunga, NO INSCRITO en esteRegistro.- REVOCADO el poder conferido a favor de don Jorge Canelo Gómez en virtud de la escritura 1506 de 1 de septiembre de2020, otorgada ante el notario de Sevilla, D. José Ignacio Guajardo-Fajardo Colunga, NO INSCRITO en este Registro.- Datosregistrales. T 6620 , F 98, S 8, H SE 20724, I/A 435 (11.11.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: DELGADO BALLESTA JESUS. Datos registrales. T 6620 , F 98, S 8, H SE 20724, I/A 436 (11.11.20).
01 de Octubre de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: DE LA ROSA DORADO JUAN MANUEL. Apoderado: ROUQUART FRANCOIS EUGENEAUGUSTE;ANZOLA ROBLES & ASOCIADOS. Apo.Sol.: BECERRA SANCHEZ JAVIER. Apo.Manc.: ARTILLO GRAU JULIO;GOMEZGARCIA GONZALO. Datos registrales. T 6620 , F 95, S 8, H SE 20724, I/A 433 (17.09.20).
30 de Julio de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: GOMEZ GARCIA GONZALO;CANELO GOMEZ JORGE;INFANTE COSSIO PABLO DAVID. Apo.Manc.:
11 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: GALINDO CORVILLO JOSE LUIS. Apo.Manc.: GALINDO CORVILLO JOSE LUIS. Apo.Sol.: GALINDOCORVILLO JOSE LUIS. Apo.Manc.: GALINDO CORVILLO JOSE LUIS. Apo.Sol.: GALINDO CORVILLO JOSE LUIS. Apo.Manc.:GALINDO CORVILLO JOSE LUIS. Otros conceptos: La Sociedad REVOCA el poder NO INSCRITO conferido a favor de Don JoséLuis Galindo Corvillo en escritura 1196 de 23 de marzo de 2017, firmada ante Notario de Madrid, D. José Miguel Garcia Lombardia. LaSociedad REVOCA el poder NO INSCRITO conferido a favor de Don José Luis Galindo Corvillo en escritura 5132 de 7 de noviembrede 2018, firmada ante Notario de Madrid, D. José Miguel Garcia Lombardia. La Sociedad REVOCA el poder NO INSCRITO conferido afavor de Don José Luis Galindo Corvillo en escritura 1466 de 11 de octubre de 2016, firmada ante Notario de Madrid, D. FernandoMolina Stranz. La Sociedad REVOCA el poder NO INSCRITO conferido a favor de Don José Luis Galindo Corvillo en escritura 796 de7 de septiembre de 2015, firmada ante Notario de Sevilla, D. José Ruiz Granados. La Sociedad REVOCA el poder NO INSCRITOconferido a favor de Don José Luis Galindo Corvillo en escritura 797 de 9 de marzo de 2015, firmada ante Notario de Sevilla, D. JoséRuiz Granados. La Sociedad REVOCA el poder NO INSCRITO conferido a favor de Don José Luis Galindo Corvillo en escritura 5415de 25 de noviembre de 2016, firmada ante Notario de Madrid, D. José Miguel Garcia Lombardia. La Sociedad REVOCA el poder NOINSCRITO conferido a favor de Don José Luis Galindo Corvillo en escritura 2882 de 8 de abril de 2016, firmada ante Notario de Sevilla,D. José Ruiz Granados. La Sociedad REVOCA el poder NO INSCRITO conferido a favor de Don José Luis Galindo Corvillo enescritura 681 de 4 de marzo de 2013, firmada ante Notario de Sevilla, Don José Ruiz Granados, y la escritura 2839 de 28 deseptiembre de 2015, firmada ante Notario de Sevilla, Don José Ruiz Granados La Sociedad REVOCA el poder NO INSCRITOconferido a favor de Don Julio Artillo Grau en escritura 1196 de 23 de marzo de 2017, firmada ante Notario de Madrid, Don José MiguelGarcía Lombardia; La Sociedad REVOCA el poder NO INSCRITO conferido a favor de Don Julio Artillo Grau en escritura 5415 de 25de noviembre de 2016, firmada ante Notario de Madrid, Don José Miguel García Lombardia; La Sociedad REVOCA el poder NOINSCRITO conferido a favor de Don Julio Artillo Grau en escritura 2627 de 7 de septiembre de 2015, firmada ante Notario de Sevilla,Don José Ruiz Granados La Sociedad REVOCA el poder NO INSCRITO conferido a favor de Don Julio Artillo Grau en escritura 558 de16 de febrero de 2015, firmada ante Notario de Sevilla, Don José Ruiz Granados; La Sociedad REVOCA el poder NO INSCRITOconferido a favor de Don Julio Artillo Grau en escritura 1916 de 16 de junio de 2015, firmada ante Notario de Sevilla, Don José RuizGranados La Sociedad REVOCA el poder NO INSCRITO conferido a favor de Don Julio Artillo Grau en escritura 3655 de 3 denoviembre de 2014, firmada ante Notario de Sevilla, Don José Ruiz Granados. Datos registrales. T 6620 , F 94, S 8, H SE 20724, I/A430 (27.11.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: INFANTE COSSIO PABLO DAVID. Datos registrales. T 6620 , F 94, S 8, H SE 20724, I/A 431(28.11.19).
11 de Septiembre de 2019Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 6620 , F 94,S 8, H SE 20724, I/A 429 ( 3.09.19).
12 de Junio de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: MONTORO MANTILLA ISIDRO. Datos registrales. T 6620 , F 93, S 8, H SE 20724, I/A 428 (4.06.19).
07 de Mayo de 2019Modificaciones estatutarias. 25.bis. Organo de administración.- . Datos registrales. T 6620 , F 93, S 8, H SE 20724, I/A 427(26.04.19).
23 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ABENGOA SA. Nombramientos. Adm. Unico: ABENGOA ABENEWCO 1 SA. Otros conceptos:La entidad administradora única de la sociedad de referencia, designa a DON JOAQUIN FERNANDEZ DE PIEROLA MARIN comorepresentante persona fisica para el ejercicio de tal cargo. Datos registrales. T 6620 , F 92, S 8, H SE 20724, I/A 426 (10.04.19).
18 de Marzo de 2019Revocaciones. Apoderado: DELGADO RODRIGUEZ MANUEL. Datos registrales. T 6620 , F 92, S 8, H SE 20724, I/A 425(11.03.19).
13 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: INFANTE COSSIO PABLO DAVID. Datos registrales. T 6620 , F 91, S 8, H SE 20724, I/A 424 (4.12.18).
07 de Diciembre de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: PRAENA RODRIGUEZ JOSE ANGEL. Apo.Sol.: GARCIA HERNANDEZ DIAZ CLAUDIO. Apo.Manc.:INFANTE COSSIO PABLO DAVID;CERON RAIGON FRANCISCO JAVIER;GALINDO CORVILLO JOSE LUIS;MASERAS GUTIERREZMIGUEL ANGEL;TORRES TORRES JUAN CARLOS;PRAENA RODRIGUEZ JOSE ANGEL;COLLADO YOLDI FELIPEJOSE;MONTORO MANTILLA ISIDRO. Datos registrales. T 6620 , F 91, S 8, H SE 20724, I/A 423 (28.11.18).
16 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: CANELO GOMEZ JORGE;GALINDO CORVILLO JOSE LUIS. Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZGARCIA GONZALO;CANELO GOMEZ JORGE;INFANTE COSSIO PABLO DAVID;GALINDO CORVILLO JOSE LUIS. Apo.Manc.:GOMEZ GARCIA GONZALO;CANELO GOMEZ JORGE;INFANTE COSSIO PABLO DAVID;GALINDO CORVILLO JOSE LUIS. Datosregistrales. T 6360 , F 120, S 8, H SE 20724, I/A 422 ( 7.11.18).
31 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ABEINSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL SA. Nombramientos. Adm. Unico:ABENGOA SA. Datos registrales. T 6360 , F 120, S 8, H SE 20724, I/A 421 (22.08.18).
06 de Julio de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: CANELO GOMEZ JORGE. Apo.Manc.: ARTILLO GRAU JULIO. Apo.Man.Soli: ARTILLO GRAUJULIO;ARTILLO GRAU JULIO. Apoderado: ARTILLO GRAU JULIO. Apo.Manc.: ARTILLO GRAU JULIO. Apoderado: GOMEZ GARCIAGONZALO. Apo.Sol.: GOMEZ GARCIA GONZALO. Apoderado: ARTILLO GRAU JULIO. Apo.Sol.: GOMEZ GARCIAGONZALO;ARTILLO GRAU JULIO;GOMEZ GARCIA GONZALO. Apo.Manc.: GOMEZ GARCIA GONZALO;PEREZ ARIZA MARIARESURRECCION;GALINDO CORVILLO JOSE LUIS;MONTERO DE ESPINOSA GOMEZ MARIA;MONTORO MANTILLAISIDRO;DELGADO BALLESTA JESUS;ARTILLO GRAU JULIO;VERGARA LOPEZ ALBERTO;DE LA ROSA DORADO JUANMANUEL. Apo.Man.Soli: GOMEZ GARCIA GONZALO;ARTILLO GRAU JULIO;PEREZ ARIZA MARIA RESURRECCION;GALINDOCORVILLO JOSE LUIS;MONTERO DE ESPINOSA GOMEZ MARIA;MONTORO MANTILLA ISIDRO;DELGADO BALLESTA JESUS.Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ GARCIA GONZALO;CANELO GOMEZ JORGE;MOREIRA GARCIA PAULA;PEREZ ARIZAMARIA RESURRECCION. Apo.Manc.: INFANTE COSSIO PABLO DAVID;GOMEZ GARCIA GONZALO;CANELO GOMEZ JORGE.Apo.Sol.: INFANTE COSSIO PABLO DAVID;PEREZ ARIZA MARIA RESURRECCION;MOREIRA GARCIA PAULA;GALINDOCORVILLO JOSE LUIS;DELGADO BALLESTA JESUS;CABEZAS CARBONELL SANTIAGO;RAMON JERONIMO MILAGROS.Apo.Manc.: GOMEZ GARCIA GONZALO;INFANTE COSSIO PABLO DAVID;PEREZ ARIZA MARIA RESURRECCION;MOREIRA
27 de Febrero de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: SALAMERO SANCHEZ EUGENIO JOSE. Datos registrales. T 6360 , F 115, S 8, H SE 20724, I/A 418 (5.02.18).
26 de Febrero de 2018Fe de erratas: Rectificada la inscripción 412ª en el sentido siguiente: 1) en el apartado VI), relativo a la revocación de la totalidad delos poderes conferidos por la sociedad a don Miguel Angel Garrido Mantilla, se hizo constar que se revocaba especialmente... ...elpoder no inscrito referido en dicha inscripción 412ª, habiéndose indicado, por error, que no constaba inscrito ningún apoderamientovigente conferido por la sociedad a favor de dicho señor, a la fecha de dicho asiento, cuando en realidad dicho señor tenía unapoderamiento vigente... ...a dicha fecha, el otorgado en Sevilla, a dieciséis de febrero de dos mil quince, ante su Notario don Jos RuizGranados, número 556 de su protocolo, que motivó la anterior inscripción 392ª de la Hoja social, el cual queda REVOCADO.- 2) que enel apartado IX), relativo a la revocación de la totalidad de los poderes otorgados a favor de don José López Domínguez, se hizo constarque se revocaba especialmente el que motivó la anterior inscripción 311ª, habiéndose indicado, por error, que no constaba inscritoningún otro... ...apoderamiento vigente conferido por la sociedad a favor de dicho señor, a la fecha de dicho asiento, cuando enrealidad dicho señor tenía un apoderamiento vigente a dicha fecha, el otorgado en Sevilla, a cinco de mayo de dos mil catorce, ante suNotario don José Ruiz Granados, número 1.665 de... ...su protocolo, que motivó la anterior inscripción 357ª de la Hoja social, el cualqueda REVOCADO.- 3) que en el apartado X), relativo a la revocación de los poderes otorgados a favor de don Miguel Angel MaserasGutiérrez que motivaron la anterior inscripción 262ª, se indicó, por error, que no constaba inscrito ningún otro apoderamiento vigenteconferido por la sociedad a favor de dicho señor,... ...a la fecha de dicho asiento, lo cual se tendrá por NO PUESTO.- Datosregistrales. T 6360 , F 116, S 8, H SE 20724, I/A 419 (19.02.18).
Revocaciones. Apo.Manc.: LOPEZ DOMINGUEZ JOSE;GARRIDO MANTILLA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 6360 , F 113,S 8, H SE 20724, I/A 412 ( 9.10.17).
14 de Febrero de 2018Revocaciones. Apoderado: LUENGO MERINO LUIS. Apo.Sol.: ASTIGARRAGA AGUIRRE IÑIGO. Apo.Man.Soli: SANCHEZFERNANDEZ JOAQUIN;NUÑEZ GARCIA ANTONIO;PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL;JURADO CHACON JESUS. Apoderado:GONZALEZ RUIZ ANDRES;RANERO HERRERO IGNACIO. Apo.Man.Soli: MUÑOZ MARTIN MIGUEL ANGEL;GONZALEZ REINAJOAQUIN;ESCRIVA DE ROMANI CARICOL ALBERTO;NUÑEZ GARCIA ANTONIO;SANCHEZ FERNANDEZ JOAQUIN;RANEROHERRERO IGNACIO. Apo.Sol.: AMIGUETI TOSSO JOSE ANTONIO. Apo.Man.Soli: TATHER GYAN CHAND;MUÑOZ MARTINMIGUEL ANGEL;JIMENEZ CASTAÑO MANUEL. Apo.Manc.: FLORES PALACIOS JOSE TOMAS;TATHER GYAN CHAND.Apo.Man.Soli: TORRES SENES JUAN LUIS;AMORES MARTIN JESUS FERNANDO;ESCRIVA DE ROMANI CARICOLALBERTO;AMORES ZURITA ENRIQUE;DEAN GARCIA ADAMEZ JUAN CARLOS;GALINDO CORVILLO JOSE LUIS;ESPILAJIMENEZ JUAN JOSE;GALINDO CORVILLO JOSE LUIS;DEAN GARCIA ADAMEZ JUAN CARLOS;ESPILA JIMENEZ JUAN JOSE.Rep.SUC.: JIMENEZ CASTAÑO MANUEL. Apo.Man.Soli: TATHER GYAN CHAND;TATHER GYAN CHAND;GALINDO CORVILLOJOSE LUIS;ESPILA JIMENEZ JUAN JOSE;DEAN GARCIA ADAMEZ JUAN CARLOS;TATHER GYAN CHAND. Apo.Manc.: TATHERGYAN CHAND. Apo.Man.Soli: JIMENEZ GUERRERO BORJA;LOPEZ ROMERO LUIS EDUARDO. Apoderado: KUMAR BRIJESH.Apo.Manc.: CASTAÑEDA VAZQUEZ FEDERICO;JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL;GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUSANGEL. Apo.Man.Soli: GOMEZ- LANDERO TORRES JUAN CARLOS. Apo.Manc.: JIMENEZ VELASCO MAZARIO MIGUELANGEL;GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL. Apo.Man.Soli: BENAVENT ALBA JOSE MARIA. Apo.Manc.: JIMENEZ-VELASCOMAZARIO MIGUEL ANGEL;GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL. Datos registrales. T 6360 , F 115, S 8, H SE 20724, I/A 418 (5.02.18).
01 de Febrero de 2018Declaración de unipersonalidad. Socio único: ABENGOA ABENEWCO 1 SA. Datos registrales. T 6360 , F 114, S 8, H SE 20724,I/A 417 (23.01.18).
16 de Enero de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: CUESTA SANCHEZ JESUS. Datos registrales. T 6360 , F 114, S 8, H SE 20724, I/A 416 ( 8.01.18).
15 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 6360 , F 114, S 8, H SE 20724, I/A 415 ( 5.01.18).
22 de Diciembre de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ JUNQUERA ANA. Datos registrales. T 6360 , F 113, S 8, H SE 20724, I/A 414 (15.12.17).
27 de Octubre de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Apo.Sol.: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Apo.Manc.:GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Apo.Man.Soli: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZALFONSO. Apo.Sol.: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;GONZALEZDOMINGUEZ ALFONSO;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO Datos registrales. T 6360 , F 113, S 8, H SE 20724, I/A 413(20.10.17).
19 de Octubre de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: SERRANO GONZALEZ JUAN. Apo.Man.Soli: MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL;KUMAR JAINDEEPAK. Apo.Sol.: LOPEZ DOMINGUEZ JOSE. Apo.Manc.: LOPEZ DOMINGUEZ JOSE;LOPEZ DOMINGUEZ JOSE. Apo.Man.Soli:LOPEZ DOMINGUEZ JOSE. Apo.Sol.: CORREA PORTILLO SANTIAGO;HIDALGO AVILA MANUEL;RAMIREZ ALARCONJAVIER;CORREA PORTILLO SANTIAGO;CORREA PORTILLO SANTIAGO;SOMLO MORENO DANIEL ALEJANDRO. Otrosconceptos: REVOCADO el siguiente poder NO INSCRITO en este Registro: el conferido a favor de D. José Leal del Ojo Chamorro,otorgado el 11 de octubre de 2016, ante Notario de Madrid, D. Fernando Molina Stranz bajo el número 1.466 de su protocolo.-REVOCADO el siguiente poder NO INSCRITO en este Registro: el otorgado el 25 de noviembre de 2016, ante Notario de Madrid, D.José Miguel García Lombardía bajo el número 5.415 de su protocolo.- REVOCADO el siguiente poder NO INSCRITO en este Registro:el conferido a favor de D. Eduard Pavel, otorgado el 27 de diciembre de 2010, ante el Notario don José Ruiz Granados, en Sevilla elnúmero 6.202 de protocolo.- REVOCADO el siguiente poder NO INSCRITO en este Registro: el conferido a favor de D. Miguel AngelGarrido Mantilla, otorgado el 22 de diciembre de 2014, ante el Notario don José Ruiz Granados, en Sevilla bajo el número 4.264 deprotocolo.- REVOCADO el siguiente poder NO INSCRITO en este Registro: el conferido a favor de D. Miguel Angel Garrido Mantilla,otorgado el 30 de octubre 2015, bajo el número 3.116 de protocolo.- REVOCADO el siguiente poder NO INSCRITO en este Registro: elconferido a favor de D. Jesús de Miguel Fernández, otorgado el 28 de septiembre de 2015, en Sevilla, ante el Notario don José RuizGranados, bajo el número 2.839 de protocolo.- Datos registrales. T 6360 , F 112, S 8, H SE 20724, I/A 412 ( 9.10.17).
20 de Septiembre de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: VALLADOLID MORO JUAN MANUEL. Apo.Manc.: VALLADOLID MORO JUAN MANUEL. Otrosconceptos: REVOCA LA TOTALIDAD DE LOS PODERES, INSCRITOS Y NO INSCRITOS, OTORGADOS EN NOMBRE DE LAMISMA A FAVOR DON HOUDA BOUDRAA, EN ESPECIAL EL NO INSCRITO, OTORGADO EL DIECISEIS DE FEBRERO DE DOSMIL QUINCE, ANTE EL NOTARIO DE SEVILLA, DON JOSE RUIZ GRANADOS, NUMERO 557 DE PROTOCOLO.- REVOCA LATOTALIDAD DE LOS PODERES, INSCRITOS Y NO INSCRITOS, OTORGADOS EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA MISMA,A FAVOR DE DON JUAN MANUEL VALLADOLID MORO.- Datos registrales. T 6360 , F 112, S 8, H SE 20724, I/A 411 (13.09.17).
18 de Agosto de 2017Modificaciones estatutarias. 9. Derechos de los accionistas.-. Datos registrales. T 6360 , F 111, S 8, H SE 20724, I/A 409 (7.08.17).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: TEBA GUIRAO GUILLERMO. Apo.Manc.: TEBA GUIRAO GUILLERMO. Apo.Man.Soli: TEBA GUIRAOGUILLERMO. Apo.Sol.: GARCIA LOS SANTOS JUAN PEDRO. Apo.Manc.: TEBA GUIRAO MAXIMO GUILLERMO;GARCIA LOSSANTOS JUAN PEDRO;GARCIA LOS SANTOS JUAN PEDRO. Apo.Sol.: GARCIA LAFFITTE MANUEL. Apo.Man.Soli: CHADDHADHIRAJ. Apo.Manc.: GARCIA LAFFITTE MANUEL. Otros conceptos: Se REVOCAN los poderes no inscritos a favor de DONMANUEL GARCIA LAFFITTE, en las siguientes escrituras con protocolos: 889/15, 1988/16, 1987/16, 2184/16, 2180/16, 1177/16,2839/15, 3842/14, 3115/16 y 3576/14. Todas otorgadas en Sevilla, ante el Notario don José Ruiz Granados.- Datos registrales. T6360 , F 111, S 8, H SE 20724, I/A 410 ( 8.08.17).
19 de Junio de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: CABEZAS CARBONELL SANTIAGO. Nombramientos. Apo.Sol.: CABEZAS CARBONELL SANTIAGO.Datos registrales. T 6360 , F 110, S 8, H SE 20724, I/A 408 ( 9.06.17).
29 de Mayo de 2017Otros conceptos: se hace constar que con fecha 2 de marzo de 2017, esta sociedad ha aprobado emitir tres títulos números 1, 2 y 3,representativos, cada uno de ellos, de 199.998 acciones nominativas, de una -1- acción nominativa y de una -1- acción nominativa dela Sociedad, respectivamente. Datos registrales. T 3107 , F 34, S 8, H SE 20724, I/A 58 B (16.05.17).
10 de Mayo de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ REINE RAFAEL. Apo.Sol.: BURGOS GOMEZ MANUEL;GONZALEZ REINE RAFAEL.Apo.Man.Soli: BURGOS GOMEZ MANUEL. Apoderado: MARCHANTE ANGUITA JUAN CARLOS. Apo.Man.Soli: CASTEJONRODRIGUEZ FRANCISCO DE PAULA. Apo.Manc.: GONZALEZ REINE RAFAEL. Apo.Man.Soli: CASTEJON RODRIGUEZFRANCISCO DE PAULA. Apo.Manc.: GONZALEZ REINE RAFAEL. Apoderado: GONZALEZ REINE RAFAEL. Apo.Man.Soli: BURGOSGOMEZ MANUEL;GONZALEZ REINE RAFAEL;DEL CASTILLO ESTEBAN LUIS;GONZALEZ REINE RAFAEL;GONZALEZ REINERAFAEL. Apo.Manc.: GONZALEZ REINE RAFAEL;GONZALEZ REINE RAFAEL;ARIAS GUILLEN IRENE. Apo.Man.Soli: GONZALEZREINE RAFAEL;ARIAS GUILLEN IRENE;GONZALEZ REINE RAFAEL. Apo.Sol.: CASTEJON RODRIGUEZ FRANCISCO DE PAULA.Apo.Manc.: GONZALEZ REINE RAFAEL. Apo.Sol.: GONZALEZ REINE RAFAEL. Apo.Manc.: CASTEJON RODRIGUEZ FRANCISCODE PAULA;DEL CASTILLO ESTEBAN LUIS;GONZALEZ REINE RAFAEL. Apoderado: GONZALEZ REINE RAFAEL. Apo.Man.Soli:VAZQUEZ GONZALEZ- MARIÑO FERNANDO. Apo.Sol.: GONZALEZ REINE RAFAEL. Apo.Man.Soli: GONZALEZ REINE RAFAEL.Apo.Manc.: GONZALEZ REINE RAFAEL;GARCIA LAFFITTE MANUEL;CASTEJON RODRIGUEZ FRANCISCO DEPAULA;CASTEJON RODRIGUEZ FRANCISCO DE PAULA;GONZALEZ REINE RAFAEL;GONZALEZ REINE RAFAEL;GARCIALAFFITTE MANUEL. Apo.Sol.: DEL CASTILLO ESTEBAN LUIS. Datos registrales. T 5901 , F 63, S 8, H SE 20724, I/A 407(26.04.17).
27 de Marzo de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: DE BENITO SALIDO JOSE PEDRO;DE BENITO SALIDO JOSE PEDRO;DE BENITO SALIDO JOSEPEDRO;DE BENITO SALIDO JOSE PEDRO;DE BENITO SALIDO JOSE PEDRO;DE BENITO SALIDO JOSE PEDRO;DE BENITOSALIDO JOSE PEDRO;DE BENITO SALIDO JOSE PEDRO;DE BENITO SALIDO JOSE PEDRO;BENITO SALIDO JOSE PEDRO;DEBENITO SALIDO JOSE PEDRO;DE BENITO SALIDO JOSE PEDRO;DE BENITO SALIDO JOSE PEDRO;DE BENITO SALIDO JOSEPEDRO;DE BENITO SALIDO JOSE PEDRO. Nombramientos. Apo.Sol.: CANELO GOMEZ JORGE;DEL CASTILLO ESTEBANLUIS;GALINDO CORVILLO JOSE LUIS. Datos registrales. T 5901 , F 63, S 8, H SE 20724, I/A 406 (17.03.17).
15 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. RepresSuplen: AMIGUETI TOSSO JOSE ANTONIO. Revocaciones. Apo.Sol.: ESPILA JIMENEZ JUAN JOSE.Apo.Man.Soli: SANCHEZ LAGUNA FRANCISCO JAVIER;SALAMERO SANCHEZ EUGENIO JOSE. Apo.Sol.: TORRES VELAZQUEZJAVIER. Apo.Man.Soli: CASTAÑEDA VAZQUEZ FEDERICO. Apo.Sol.: VALERA LLANOS CARLOS. Apoderado: GESSA SORROCHEFRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.: GALAN PEÑA JAVIER. Apo.Manc.: CASTAÑEDA VAZQUEZ FEDERICO. Apo.Man.Soli:CASTAÑEDA VAZQUEZ FEDERICO;SANCHEZ LAGUNA FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: GARCIA GALLEGO MARIA;SANCHEZLAGUNA FRANCISCO JAVIER;MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL;MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL. Datosregistrales. T 5901 , F 62, S 8, H SE 20724, I/A 405 ( 7.03.17).
Revocaciones. Apoderado: CANAS MONTES MANUEL;GARCIA GONZALEZ FRANCISCO;ROUQUART FRANCOIS EUGENEAUGUSTE. Apo.Sol.: GALVAN GOMEZ FRANCISCO;SANTAMARIA MIFSUT JORGE. Apo.Man.Soli: PIZA GRANADOS ALBERTO.Apo.Sol.: PIZA GRANADOS ALBERTO. Apo.Man.Soli: PIZA GRANADOS ALBERTO. Apoderado: MAYORGA ROA OFILIO.Apo.Man.Soli: BERNARDO VEGA FRANCISCO;VEGA CHANG PAOLA JUFRANCE;BERNARDO VEGA FRANCISCO;VEGA CHANGPAOLA JUFRANCE;BERNARDO VEGA FRANCISCO;VEGA CHANG PAOLA JUFRANCE. Apoderado: MORENO PANTOJASFRANCISCO JOSE;RAMIREZ MORGADO FRANCISCO JOSE;MORENO GONZALEZ ENRIQUE. Apo.Man.Soli: CHEBAA HAMZA.Apoderado: BERMEJO COLLADO JULIAN;ANZOLA ROBLES AND ASOCIADOS. Apo.Sol.: BATRES PEREZ FAVIO JOSUE;CASTROROMERO MANUEL ALBERTO. Apo.Man.Soli: ATILIO HEREDIA NESTOR;MAYORAL ESPAÑA JOSE MANUEL;ATILIO HEREDIANESTOR;GALVAN GOMEZ FRANCISCO;AMORES MARTIN JESUS FERNANDO;JURADO CHACON JESUS;AMORES ZURITAENRIQUE;GALVAN GOMEZ FRANCISCO. Apoderado: ORTEGA SANTOS LUIS. Apo.Man.Soli: BUENO CRESPO ANTONIO JOSEDAMASO;GALVAN GOMEZ FRANCISCO. Apo.Manc.: ORTEGA SANTOS LUIS. Apoderado: GONZALEZ REINE RAFAEL.Apo.Man.Soli: LEAL DEL OJO CHAMORRO JOSE;CLARES DEL MORAL PEDRO JULIAN. Apo.Sol.: CAO GARCIAFERNANDO;CLARES DEL MORAL PEDRO JULIAN;RAI SATISH. Apo.Man.Soli: BARROSO DE TENA JULIO. Apo.Sol.: BALAYSAMUEL;JIMENEZ AGUILAR MANUEL. Apo.Manc.: JIMENEZ AGUILAR MANUEL. Apo.Man.Soli: JIMENEZ AGUILARMANUEL;SANTAMARIA MIFSUT JORGE. Apo.Sol.: GARCIA HERNANDEZ DIAZ CLAUDIO;SANTOS ESCOLANO JUAN. Apo.Manc.:JIMENEZ AGUILAR MANUEL. Apo.Sol.: ALVAREZ DODERO JOSE ANTONIO. Apo.Manc.: GONZALEZ REINE RAFAEL. Apo.Sol.:MORENO GONZALEZ ENRIQUE;MUÑOZ FERNANDEZ MARTIN. Apo.Manc.: ATILIO HEREDIA NESTOR;ATILIO HEREDIANESTOR;ATILIO HEREDIA NESTOR;BORRELL PEDROSA FRANCISCO MANUEL;CLARES DEL MORAL PEDRO JULIAN.Apo.Man.Soli: MARTINEZ CONESA ANTONIO. Apo.Sol.: JIMENEZ GUERRERO FRANCISCO DE BORJA. Apo.Manc.: PEREZALONSO AIDA;MONTOYA CAZORLA MARIA JOSE. Apo.Sol.: ALEGRE MARRADES MIGUEL. Apo.Man.Soli: JIMENEZ AGUILARMANUEL. Apo.Manc.: PEREZ ALONSO AIDA;MONTOYA CAZORLA MARIA JOSE;JIMENEZ AGUILAR MANUEL;HEREDIA NESTORATILIO;HEREDIA NESTOR ATILIO. Apo.Man.Soli: JIMENEZ AGUILAR MANUEL. Apo.Manc.: PEREZ ALONSO AIDA;MONTOYACAZORLA MARIA JOSE. Apo.Man.Soli: MORENO MORA FELIPE. Apoderado: MARTINEZ HERNANDEZ PEDRO MIGUEL.
07 de Marzo de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: TORRES CASTILLO JAVIER. Datos registrales. T 5901 , F 60, S 8, H SE 20724, I/A 403 (23.02.17).
27 de Febrero de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5901 , F 60, S 8, H SE 20724, I/A 402 (17.02.17).
19 de Septiembre de 2016Modificaciones estatutarias. Artículo 25º.- Facultades del Organo de Administración.-. Datos registrales. T 5901 , F 58, S 8, H SE20724, I/A 401 (12.09.16).
12 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: CANELO GOMEZ JORGE. Datos registrales. T 5901 , F 58, S 8, H SE 20724, I/A 400 (24.08.16).
24 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;GOMEZ GARCIA GONZALO;VALVERDE DELGADO
24 de Diciembre de 2015Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5901 , F 55, S 8, H SE 20724, I/A 398 (10.12.15).
14 de Agosto de 2015Nombramientos. Apoderado: MARTIN DE BRIONES IGNACIO. Datos registrales. T 5901 , F 54, S 8, H SE 20724, I/A 397(29.07.15).
12 de Junio de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: TATHER GYAN CHAND. Datos registrales. T 5901 , F 54, S 8, H SE 20724, I/A 396 ( 3.06.15).
06 de Abril de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: VALERIO PALACIO JOSE JAVIER;VALERIO PALACIO JAVIER. Apo.Manc.: VALERIO PALACIO JOSEJAVIER;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER. Apoderado: VALERIO PALACIO JOSE JAVIER.Apo.Manc.: VALERIO PALACIO JOSE JAVIER;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER;VALERIOPALACIO JOSE JAVIER;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER. Apo.Man.Soli: VALERIO PALACIO JOSE JAVIER;VALERIO PALACIOSJAVIER. Apo.Sol.: REDONDO GOMEZ LUCIANO;REDONDO GOMEZ LUCIANO. Apo.Man.Soli: REDONDO GOMEZ LUCIANO.Apo.Manc.: VALERIO PALACIO JOSE JAVIER;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER;VALERIOPALACIO JOSE JAVIER;REDONDO GOMEZ LUCIANO;REDONDO GOMEZ LUCIANO;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER;VALERIOPALACIO JOSE JAVIER;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER. Datos registrales. T 5901 , F 53, S8, H SE 20724, I/A 395 (16.03.15).
13 de Marzo de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: FRANCOIS MICHEL AVARO CEDRIC. Datos registrales. T 5901 , F 51, S 8, H SE 20724, I/A 391 (4.03.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: BUSTELO MUIÑOS DAVID;BUSTELO MUIÑOS DAVID. Apo.Manc.: BUSTELO MUIÑOSDAVID;GARRIDO MANTILLA MIGUEL ANGEL;MORENO MORA FELIPE;ARRIBAS ANDRES RAUL. Datos registrales. T 5901 , F51, S 8, H SE 20724, I/A 392 ( 4.03.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ JUNQUERA ANA. Datos registrales. T 5901 , F 52, S 8, H SE 20724, I/A 393 ( 4.03.15).
10 de Marzo de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: SOMLO MORENO DANIEL ALEJANDRO. Datos registrales. T 5901 , F 50, S 8, H SE 20724, I/A 390 (3.03.15).
24 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABALLERO MONDAZA JOSE ALBERTO. Apo.Manc.: MASERAS GUTIERREZ MIGUELANGEL;GONZALEZ REINE RAFAEL;GARCIA LAFFITTE MANUEL. Datos registrales. T 5901 , F 49, S 8, H SE 20724, I/A 389(17.12.14).
19 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: BECERRA SANCHEZ JAVIER. Datos registrales. T 5901 , F 48, S 8, H SE 20724, I/A 387 (10.12.14).
Revocaciones. Apo.Sol.: NORBERTO ZARPELLON GABRIEL;HORACIO SARALEGUI ERNESTO;PAULINO JUNQUEIRA LUCIANO.Apo.Man.Soli: DIEZ MARTINEZ JORGE. Datos registrales. T 5901 , F 49, S 8, H SE 20724, I/A 388 (10.12.14).
28 de Noviembre de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: GALVAN GOMEZ FRANCISCO. Apo.Man.Soli: GARCIA LAFFITE MANUEL;GONZALEZ REINERAFAEL;PRAENA RODRIGUEZ JOSE ANGEL;GARCIA LAFFITTE MANUEL;SANTIAGO PEREZ RAUL;BORRELL PEDROSAFRANCISCO MANUEL;LAZARICH RAMIREZ MARIA;GOMEZ GARCIA GONZALO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIALAFFITTE MANUEL;INFANTE COSSIO PABLO DAVID;GOMEZ GARCIA GONZALO;BORRELL PEDROSA FRANCISCOMANUEL;ARTILLO GRAU JULIO;VERGARA LOPEZ ALBERTO;JIMENEZ AGUILAR MANUEL. Apo.Sol.: BALBOA LINARES
Nombramientos. Apo.Sol.: GUK HAKAN. Datos registrales. T 5901 , F 47, S 8, H SE 20724, I/A 386 (18.11.14).
24 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORENO MORA FELIPE. Datos registrales. T 5901 , F 44, S 8, H SE 20724, I/A 383 (14.11.14).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ HERNANDEZ PEDRO MIGUEL. Datos registrales. T 5901 , F 45, S 8, H SE 20724, I/A384 (14.11.14).
20 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: VILLAMOR VARGAS ALBERTO. Apo.Manc.: VILLAMOR VARGAS ALBERTO;MASERAS GUTIERREZMIGUEL ANGEL;GONZALEZ REINE RAFAEL;GARCIA LAFFITTE MANUEL. Datos registrales. T 5901 , F 43, S 8, H SE 20724, I/A382 ( 6.11.14).
13 de Noviembre de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: MYRO BORRERO JOSE ENRIQUE. Apoderado: TRUJILLO VALERA FERNANDO. Datosregistrales. T 5901 , F 42, S 8, H SE 20724, I/A 380 ( 4.11.14).
Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ GARCIA JOSE CARMELO. Otros conceptos: REVOCADO el poder especial NOINSCRITO, conferido a favor de D. JOSE CARMELO FERNANDEZ GARCIA, en escritura de 7-4-14, número 1408, otorgada ante elNotario de Sevilla, D. Jose Ruiz Granados.- REVOCADO el poder especial NO INSCRITO, conferido a favor de D. JOSE CARMELOFERNANDEZ GARCIA, en escritura de 7-4-14, número 1407, otorgada ante el Notario de Sevilla, D. Jose Ruiz Granados.- Datosregistrales. T 5901 , F 43, S 8, H SE 20724, I/A 381 ( 4.11.14).
17 de Octubre de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ SANCHEZ JOSE MANUEL. Apo.Sol.: GALINDO CORVILLO JOSE LUIS;TORRES TORRESJUAN CARLOS. Datos registrales. T 5901 , F 40, S 8, H SE 20724, I/A 378 (29.09.14).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ REINE RAFAEL;DONADO RUBIO JOSE MANUEL. Nombramientos. Representan:AVARO CEDRIC. Apo.Man.Soli: RAMON JERONIMO MILAGROS;ARTILLO GRAU JULIO;VERGARA LOPEZ ALBERTO;JIMENEZAGUILAR MANUEL. Apo.Sol.: BALBOA LINARES SALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: GONZALEZDOMINGUEZ ALFONSO;JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL;GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL;PEREZALONSO AIDA;MONTOYA CAZORLA MARIA JOSE. Datos registrales. T 5901 , F 40, S 8, H SE 20724, I/A 379 (29.09.14).
19 de Septiembre de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: AGUIRRE MORO JUAN IGNACIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE DIOS GOMEZ VICTORJOSE. Apo.Manc.: GALINDO CORVILLO JOSE LUIS;TORRES TORRES JUAN CARLOS. Datos registrales. T 5901 , F 39, S 8, HSE 20724, I/A 377 (10.09.14).
17 de Septiembre de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: CUESTA SANCHEZ JESUS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CUESTA SANCHEZ JESUS.Apo.Manc.: HEREDIA NESTOR ATILIO;CASTEJON RODRIGUEZ FRANCISCO DE PAULA;GALINDO CORVILLO JOSELUIS;TORRES TORRES JUAN CARLOS. Otros conceptos: LAS FACULTADES MANCOMUNADAS TENDRAN UN LIMITEMAXIMO DE UN MILLON QUINIENTOS MIL EUROS, O EL EQUIVALENTE EN LA MONEDA LOCAL QUE CORRESPONDA Y, PARAEL EJERCICIO DE LAS MISMAS SERA OBLIGATORIA LA CONCURRENCIA DE DOS DE LOS APODERADOS.- Datos registrales.T 5901 , F 38, S 8, H SE 20724, I/A 376 ( 9.09.14).
15 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: VAZQUEZ GONZALEZ- MARIÑO FERNANDO;CHADDHA DHIRAJ. Apo.Manc.: MASERASGUTIERREZ MIGUEL ANGEL;GONZALEZ REINE RAFAEL;GARCIA LAFFITTE MANUEL. Datos registrales. T 5901 , F 35, S 8, HSE 20724, I/A 374 ( 4.09.14).
Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ REINE RAFAEL;CASTEJON RODRIGUEZ FRANCISCO DE PAULA;MASERASGUTIERREZ MIGUEL ANGEL;BENAVENT ALBA JOSE MARIA;HEREDIA NESTOR ATILIO. Apo.Sol.: BENAVENT ALBA JOSEMARIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BENAVENT ALBA JOSE MARIA. Apo.Manc.: GALINDO CORVILLO JOSE LUIS;TORRESTORRES JUAN CARLOS;HEREDIA NESTOR ATILIO;CASTEJON RODRIGUEZ FRANCISCO DE PAULA. Otros conceptos: PARAEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES MANCOMUNADAS, SERA OBLIGATORIA LA CONCURRENCIA DE DOS DE LOSAPODERADOS, HASTA UN IMPORTE MAXIMO DE UN MILLON QUINIENTOS MIL EUROS -1.500.000E-, O EL EQUIVALENTE ENLA MONEDA LOCAL QUE CORRESPONDA.- Datos registrales. T 5901 , F 36, S 8, H SE 20724, I/A 375 ( 9.09.14).
03 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ- LANDERO TORRES JUAN CARLOS. Apo.Manc.: RAMON JERONIMOMILAGROS;AVARO CEDRIC. Datos registrales. T 5901 , F 34, S 8, H SE 20724, I/A 371 (26.08.14).
02 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: ARTILLO GRAU JULIO;JIMENEZ AGUILAR MANUEL;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;GOMEZGARCIA GONZALO. Datos registrales. T 5901 , F 31, S 8, H SE 20724, I/A 370 (26.08.14).
29 de Agosto de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ REINE RAFAEL;MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL. Apo.Man.Soli: GONZALEZREINE RAFAEL;MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL. Otros conceptos: REVOCADO el mandato de don Alberto PizáGranados como representante legal de la sucursal de la sociedad en Libia, mandato éste que resulta del artículo 5º de los Estatutos dedicha sucursal, cuya apertura motivó la anterior inscripción 109& de la hoja social.- NOMBRADO como representante legal de lasociedad para la sucursal que la misma tiene en Libia, a DON RAFAEL GONZALEZ REINE.- Las facultades se confieren en la forma ycon las limitaciones establecidas en la escritura otorgada en Sevilla, a veintiuno de julio de dos mil catorce, ante su Notario don JoséRuiz Granados, número 2.585 de su protocolo.- Datos registrales. T 5786 , F 189, S 8, H SE 20724, I/A 369 (19.08.14).
28 de Agosto de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABEZAS CARBONELL SANTIAGO;MARTIN ATUCHA MARIA;GOMEZ GARCIAGONZALO;ARTILLO GRAU JULIO;VERGARA LOPEZ ALBERTO;JIMENEZ AGUILAR MANUEL. Apo.Sol.: BALBOA LINARESSALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;JIMENEZ VELASCO MAZARIOMIGUEL ANGEL;GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL;PEREZ ALONSO AIDA;MONTOYA CAZORLA MARIA JOSE. Datosregistrales. T 5786 , F 186, S 8, H SE 20724, I/A 368 (14.08.14).
22 de Agosto de 2014Revocaciones. Apoderado: LEIZA RECONDO IMANOL. Apo.Man.Soli: ALEGRE MARRADES MIGUEL. Apo.Sol.: DEL CASTILLOESTEBAN LUIS;LAZARICH RAMIREZ MARIA;GOMEZ GARCIA GONZALO. Apo.Man.Soli: DE LA ROSA DORADO JUAN MANUEL.Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Apo.Sol.: ARTILLO GRAU JULIO. Apo.Manc.: VERGARA LOPEZALBERTO;ARTILLO GRAU JULIO;GOMEZ GARCIA GONZALO. Datos registrales. T 5786 , F 185, S 8, H SE 20724, I/A 366(11.08.14).
29 de Julio de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: CABEZAS CARBONELL SANTIAGO;GARCIA LAFFITTE MANUEL;RAMON JERONIMOMILAGROS;RAMIREZ ALARCON JAVIER;ALEGRE MARRADES MIGUEL. Datos registrales. T 5786 , F 185, S 8, H SE 20724, I/A365 (21.07.14).
16 de Julio de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL;GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL;CERROREDONDO JOSE FERNANDO;JIMENEZ AGUILAR MANUEL;MONTOYA CAZORLA MARIA JOSE. Nombramientos. Apo.Manc.:JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL;GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL;PEREZ ALONSO AIDA;MONTOYACAZORLA MARIA JOSE. Datos registrales. T 5786 , F 183, S 8, H SE 20724, I/A 362 ( 4.07.14).
Revocaciones. Apoderado: ALEGRE MARRADES MIGUEL. Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ REINE RAFAEL. Datosregistrales. T 5786 , F 184, S 8, H SE 20724, I/A 364 ( 4.07.14).
02 de Julio de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANCHEZ LOPEZ ANTONIO. Nombramientos. Apo.Sol.: BENAVENT ALBA JOSE MARIA.Apo.Manc.: MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL;GONZALEZ REINE RAFAEL;CASTEJON RODRIGUEZ FRANCISCO DEPAULA;BENAVENT ALBA JOSE MARIA;HEREDIA NESTOR ATILIO. Datos registrales. T 5786 , F 182, S 8, H SE 20724, I/A 361(24.06.14).
23 de Junio de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: ROMERO MARTIN SALVADOR. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ CONESA ANTONIO.Datos registrales. T 5786 , F 180, S 8, H SE 20724, I/A 359 (11.06.14).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: JIMENEZ GUERRERO BORJA. Nombramientos. Apo.Sol.: JIMENEZ GUERRERO FRANCISCO DEBORJA. Datos registrales. T 5786 , F 182, S 8, H SE 20724, I/A 360 (11.06.14).
12 de Junio de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA LOS SANTOS JUAN PEDRO. Apo.Manc.: GARCIA LOS SANTOS JUAN PEDRO;DE BENITOSALIDO JOSE PEDRO. Datos registrales. T 5786 , F 179, S 8, H SE 20724, I/A 358 ( 3.06.14).
09 de Junio de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: HIDALGO AVILA MANUEL. Datos registrales. T 5786 , F 177, S 8, H SE 20724, I/A 356 (26.05.14).
Nombramientos. Apo.Manc.: INFANTE COSSIO PABLO DAVID;DE BENITO SALIDO JOSE PEDRO;CASTAÑEDA VAZQUEZFEDERICO;DEL CASTILLO ESTEBAN LUIS;CERON RAIGON FRANCISCO JAVIER;SANCHEZ LAGUNA FRANCISCOJAVIER;CLARES DEL MORAL PEDRO JULIAN;SALAMERO SANCHEZ EUGENIO JOSE;GALINDO CORVILLO JOSE LUIS;LOPEZDOMINGUEZ JOSE;MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL;TORRES TORRES JUAN CARLOS;PRAENA RODRIGUEZ JOSEANGEL;TEBA GUIRAO MAXIMO GUILLERMO;COLLADO YOLDI FELIPE JOSE;VALLADOLID MORO JUAN MANUEL;MONTOROMANTILLA ISIDRO;GARCIA LOS SANTOS JUAN PEDRO;GONZALEZ REINE RAFAEL. Datos registrales. T 5786 , F 177, S 8, HSE 20724, I/A 357 (26.05.14).
02 de Junio de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;GOMEZ GARCIA GONZALO. Datos registrales. T 5786 , F 176, S8, H SE 20724, I/A 354 (22.05.14).
Nombramientos. Apo.Manc.: GRACIA LAFFITTE MANUEL;BORRELL PEDROSA FRANCISCO MANUEL. Datos registrales. T5786 , F 177, S 8, H SE 20724, I/A 355 (22.05.14).
26 de Mayo de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: CASTEJON RODRIGUEZ FRANCISCO DE PAULA. Apo.Man.Soli: GOMEZ FERRO LUIS ALBERTO.Nombramientos. Apo.Sol.: CASTEJON RODRIGUEZ FRANCISCO DE PAULA. Apo.Manc.: MASERAS GUTIERREZ MIGUELANGEL. Apo.Sol.: GONZALEZ REINE RAFAEL. Apo.Manc.: ATILIO HEREDIA NESTOR;CASTEJON RODRIGUEZ FRANCISCO DEPAULA. Apo.Man.Soli: GOMEZ FERRO LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 5786 , F 175, S 8, H SE 20724, I/A 353 (15.05.14).
22 de Mayo de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: MUÑOZ FERNANDEZ MARTIN. Datos registrales. T 5786 , F 173, S 8, H SE 20724, I/A 350 (13.05.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CASTEJON RODRIGUEZ FRANCISCO DE PAULA. Apo.Manc.: GALINDO CORVILLO JOSELUIS;TORRES TORRES JUAN CARLOS;ATILIO HEREDIA NESTOR. Apo.Man.Soli: GOMEZ FERRO LUIS ALBERTO. Apo.Manc.:MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL;GONZALEZ REINE RAFAEL;ATILIO HEREDIA NESTOR;CASTEJON RODRIGUEZFRANCISCO DE PAULA. Otros conceptos: Se REVOCA EL PODER NO INSCRITO a favor de DON JESUS CUESTA SANCHEZ en
Revocaciones. Apoderado: MORENO GONZALEZ ENRIQUE. Nombramientos. Apo.Sol.: MORENO GONZALEZ ENRIQUE.Datos registrales. T 5786 , F 175, S 8, H SE 20724, I/A 352 (13.05.14).
19 de Mayo de 2014Revocaciones. Apoderado: NAGPAL D.S.K. Apo.Man.Soli: GOMEZ GARCIA GONZALO;GONZALEZ DOMINGUEZALFONSO;ARTILLO GRAU JULIO. Apo.Sol.: VERGARA LOPEZ ALBERTO. Apo.Man.Soli: LAZARICH RAMIREZ MARIA. Apo.Sol.:BALBOA LINARES SALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;LAZARICHRAMIREZ MARIA. Apo.Sol.: MARSET RAMS JOSE. Datos registrales. T 5786 , F 173, S 8, H SE 20724, I/A 349 ( 5.05.14).
12 de Mayo de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABEZAS CARBONEL SANTIAGO;SANCHEZ LAGUNA FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: MARTINATUCHA MARIA;GONZALEZ REINE RAFAEL;ARTILLO GRAU JULIO;VERGARA LOPEZ ALBERTO;GARCIA GALLEGO MARIA.Datos registrales. T 5786 , F 171, S 8, H SE 20724, I/A 348 (25.04.14).
25 de Abril de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: SUAREZ SUAREZ RAFAEL. Apo.Sol.: SUAREZ SUAREZ JOSE RAFAEL. Apo.Manc.: SUAREZSUAREZ JOSE RAFAEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL;GONZALEZ REINE RAFAEL.Datos registrales. T 5786 , F 170, S 8, H SE 20724, I/A 347 (14.04.14).
03 de Abril de 2014Nombramientos. Apoderado: KUMAR BRIJESH. Datos registrales. T 5786 , F 168, S 8, H SE 20724, I/A 344 (25.03.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ DODERO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 5786 , F 169, S 8, H SE 20724, I/A 345
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ LOPEZ ANTONIO;CUESTA SANCHEZ JESUS. Otros conceptos: Se REVOCA ELPODER NO INSCRITO otorgado a favor de DON FRANCISCO GALVAN GOMEZ y DON RAUL SANTIAGO PEREZ, en escritura confecha 31 de mayo de 2011, ante el Notario de Sevilla, don José Ruiz Granados, número 2.577 de su protocolo.- Datos registrales. T5786 , F 169, S 8, H SE 20724, I/A 346 (25.03.14).
26 de Marzo de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: BALBOA LINARES SALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZALFONSO;JIMENEZ AGUILAR MANUEL. Datos registrales. T 5786 , F 168, S 8, H SE 20724, I/A 343 (13.03.14).
21 de Marzo de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: VALERIO PALACIOS JAVIER. Apo.Manc.: GARCIA HERNANDEZ DIAZ CLAUDIO;SANTOSESCOLANO JUAN. Datos registrales. T 5786 , F 166, S 8, H SE 20724, I/A 342 (11.03.14).
10 de Marzo de 2014Nombramientos. Apoderado: CEINOS MORENO JORGE. Datos registrales. T 5786 , F 165, S 8, H SE 20724, I/A 340 (26.02.14).
Fe de erratas: Rectifica la inscripción 328&, en el sentido de hacer que en la certificación inserta en la escritura que motivo talinscripción, se padeció un error involuntario al reflejar el nombre del apoderado, Don Javier Galán Peña, al que se nombro como"Juan".- Datos registrales. T 5786 , F 166, S 8, H SE 20724, I/A 341 (27.02.14).
27 de Febrero de 2014Revocaciones. Apoderado: GOUVEIA DOS SANTOS RAMOS CRISPIM MANUEL. Apo.Sol.: MEDIAVILLA LOPEZAMADEO;ESTEBAN AGUEDA LUIS MARIA;DE AHUMADA PASTOR MANUEL;DE ANDRES RAMIREZ JESUS MARIA;MERINOCIUDAD ANTONIO. Apoderado: GOMEZ MARTINEZ JORGE. Apo.Sol.: CARREÑO SUAREZ AGUSTIN. Apo.Man.Soli: CAMACHODONEZAR JAVIER. Apo.Manc.: JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL;GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL;JORRODE INZA VICENTE;CERRO REDONDO JOSE FERNANDO;GALVAN GOMEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 5786 , F 165, S 8,
14 de Febrero de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: ASTIGARRAGA AGUIRRE IÑIGO. Apo.Manc.: DE BENITO SALIDO JOSE PEDRO;VALERIOPALACIO JOSE JAVIER. Datos registrales. T 5786 , F 164, S 8, H SE 20724, I/A 337 ( 4.02.14).
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Presidente: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Consejero:HOOGSTRAATE MAARTEN. Secretario: HOOGSTRAATE MAARTEN. Consejero: VALVERDE DELGADO MANUEL;GOMEZ GARCIAGONZALO;POLO GUERRERO ALVARO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;VALVERDEDELGADO MANUEL;GOMEZ GARCIA GONZALO;POLO GUERRERO ALVARO;SALINAS IÑIGO PURIFICACION. Presidente:GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Secretario: SALINAS IÑIGO PURIFICACION. Datos registrales. T 5786 , F 164, S 8, H SE20724, I/A 338 ( 5.02.14).
07 de Febrero de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ GARCIA JOSE CARMELO. Datos registrales. T 5786 , F 163, S 8, H SE 20724, I/A 336(30.01.14).
05 de Febrero de 2014Nombramientos. Apoderado: GOMEZ GARCIA GONZALO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Apo.Sol.: GOMEZGARCIA GONZALO. Apoderado: ARTILLO GRAU JULIO. Apo.Sol.: JIMENEZ AGUILAR MANUEL;GOMEZ GARCIAGONZALO;ARTILLO GRAU JULIO;GOMEZ GARCIA GONZALO;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Apo.Manc.: GONZALEZDOMINGUEZ ALFONSO;GOMEZ GARCIA GONZALO;GONZALEZ REINE RAFAEL;PEREZ ARIZA MARIARESURRECCION;GALINDO CORVILLO JOSE LUIS;MONTERO DE ESPINOSA GOMEZ MARIA;TEBA GUIRAOGUILLERMO;CASTAÑEDA VAZQUEZ FEDERICO;ARIAS GUILLEN IRENE;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER;MONTOROMANTILLA ISIDRO;DELGADO BALLESTA JESUS;LOPEZ DOMINGUEZ JOSE;ARTILLO GRAU JULIO;JIMENEZ AGUILARMANUEL;VERGARA LOPEZ ALBERTO;DE LA ROSA DORADO JUAN MANUEL. Apo.Man.Soli: GONZALEZ DOMINGUEZALFONSO;GOMEZ GARCIA GONZALO;ARTILLO GRAU JULIO;JIMENEZ AGUILAR MANUEL;GONZALEZ REINE RAFAEL;PEREZARIZA MARIA RESURRECCION;GALINDO CORVILLO JOSE LUIS;MONTERO DE ESPINOSA GOMEZ MARIA;TEBA GUIRAOGUILLERMO;CASTAÑEDA VAZQUEZ FEDERICO;SANTAMARIA MIFSUT JORGE;ARIAS GUILLEN IRENE;VALERIO PALACIOJOSE JAVIER;MONTORO MANTILLA ISIDRO;DELGADO BALLESTA JESUS;LOPEZ DOMINGUEZ JOSE. Datos registrales. T5594 , F 28, S 8, H SE 20724, I/A 335 (27.01.14).
02 de Enero de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: LAZARICH RAMIREZ MARIA;GOMEZ GARCIA GONZALO;ARTILLO GRAU JULIO. Datos registrales. T5594 , F 28, S 8, H SE 20724, I/A 334 (20.12.13).
09 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ ROMERO LUIS EDUARDO. Apo.Manc.: MASERAS GUTIERREZ MIGUELANGEL;GONZALEZ REINE RAFAEL. Datos registrales. T 5594 , F 26, S 8, H SE 20724, I/A 332 (28.11.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: BECERRA SANCHEZ JAVIER. Datos registrales. T 5594 , F 27, S 8, H SE 20724, I/A 333 (29.11.13).
28 de Noviembre de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: YESHWANT PIMPALKAR NILESH;YESHWANT PIMPALKAR NILESH. Apo.Man.Soli: YESHWANTPIMPALKAR NILESH. Datos registrales. T 5594 , F 25, S 8, H SE 20724, I/A 330 (19.11.13).
Nombramientos. Apo.Manc.: JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL;GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL;CERROREDONDO JOSE FERNANDO;JIMENEZ AGUILAR MANUEL;MONTOYA CAZORLA MARIA JOSE. Datos registrales. T 5594 , F 25,S 8, H SE 20724, I/A 331 (20.11.13).
30 de Agosto de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: GALAN PEÑA JUAN;BALAY SAMUEL. Datos registrales. T 5594 , F 23, S 8, H SE 20724, I/A 328(21.08.13).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: AGUIRRE MORO JUAN IGNACIO. Apo.Manc.: GALINDO CORVILLO JOSE LUIS;TORRESTORRES JUAN CARLOS. Datos registrales. T 5594 , F 24, S 8, H SE 20724, I/A 329 (21.08.13).
20 de Agosto de 2013Nombramientos. Apoderado: GESSA SORROCHE FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5594 , F 23, S 8, H SE 20724, I/A326 ( 7.08.13).
Nombramientos. Apoderado: MORENO GONZALEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 5594 , F 23, S 8, H SE 20724, I/A 327 (7.08.13).
01 de Agosto de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: GALVAN GOMEZ FRANCISCO. Apo.Sol.: GARCIA BRAVO ALEJANDRO DANIEL. Datos registrales.T 5594 , F 22, S 8, H SE 20724, I/A 325 (22.07.13).
25 de Julio de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ REINE RAFAEL;BARROSO DE TENA JULIO. Apo.Manc.: MASERAS GUTIERREZMIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 5594 , F 20, S 8, H SE 20724, I/A 323 (17.07.13).
Revocaciones. Apo.Sol.: COLLADO YOLDI FELIPE JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: COLLADO YOLDI FELIPE JOSE.Apo.Manc.: BENITO SALIDO JOSE PEDRO;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER. Datos registrales. T 5594 , F 21, S 8, H SE 20724,I/A 324 (18.07.13).
21 de Junio de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ REINE RAFAEL;DEL CASTILLO ESTEBAN LUIS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DELCASTILLO ESTEBAN LUIS;GONZALEZ REINE RAFAEL. Apo.Manc.: DE BENITO SALIDO JOSE PEDRO;VALERIO PALACIO JOSEJAVIER. Datos registrales. T 5594 , F 18, S 8, H SE 20724, I/A 322 (11.06.13).
13 de Mayo de 2013Revocaciones. Apoderado: TATHER GYAN CHAND. Nombramientos. Apo.Sol.: TATHER GYAN CHAND;JHA RAJESH KUMAR.Datos registrales. T 5594 , F 16, S 8, H SE 20724, I/A 320 ( 3.05.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: VALERA LLANOS CARLOS. Datos registrales. T 5594 , F 17, S 8, H SE 20724, I/A 321 ( 3.05.13).
03 de Mayo de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: DONADO RUBIO JOSE MANUEL. Otros conceptos: PODER, en relación al EstablecimientoPermanente que "Instalaciones Inabensa, S.A." tiene en Marruecos, solidario a favor de don José Manuel Donado Rubio, ymancomunado con don Rafael González Reiné,o con don Miguel Angel Maseras Gutiérrez. Datos registrales. T 5594 , F 15, S 8, HSE 20724, I/A 319 (24.04.13).
15 de Abril de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA LAFFITTE MANUEL;SANTIAGO PEREZ RAUL;BORRELL PEDROSA FRANCISCOMANUEL;LAZARICH RAMIREZ MARIA;GOMEZ GARCIA GONZALO. Otros conceptos: Revocados los poderes conferidos a DONLUIS ORTEGA SANTOS, por las inscripciones 248&, 249&, 288& y 290&, y canceladas parcialmente las mismas. Datos registrales.T 5594 , F 13, S 8, H SE 20724, I/A 318 ( 3.04.13).
01 de Abril de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: YESHWANT PIMPALKAR NILESH;REDONDO GOMEZ LUCIANO. Apo.Manc.: VALERIO PALACIOJOSE JAVIER;ARTILLO GRAU JULIO. Datos registrales. T 5594 , F 9, S 8, H SE 20724, I/A 314 (20.03.13).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GALINDO CORVILLO JOSE LUIS;BURGOS GOMEZ MANUEL;DIEZ MARTINEZ JORGE.Apo.Manc.: TORRES TORRES JUAN CARLOS;YESHWANT PIMPALKAR NILESH. Datos registrales. T 5594 , F 10, S 8, H SE20724, I/A 315 (20.03.13).
Revocaciones. Apo.Sol.: VARGAS GALLARDO ENRIQUE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LA ROSA DORADO JUANMANUEL. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;GOMEZ GARCIA GONZALO;ARTILLO GRAU JULIO;VERGARA LOPEZALBERTO. Datos registrales. T 5594 , F 11, S 8, H SE 20724, I/A 316 (21.03.13).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ REINE RAFAEL;MYRO BORRERO JOSE ENRIQUE. Apo.Manc.: MASERASGUTIERREZ MIGUEL ANGEL;YESHWANT PIMPALKAR NILESH. Datos registrales. T 5594 , F 12, S 8, H SE 20724, I/A 317(21.03.13).
27 de Febrero de 2013Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ BLANCO VICTOR. Apo.Man.Soli: GONZALEZ CASAS ANTONIO;MACIAS CAMACHOJOSE;GALINDO CORVILLO JOSE LUIS;DUQUE GARCIA EDUARDO;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;ARTILLO GRAUJULIO;VERGARA LOPEZ ALBERTO;VARGAS GALLARDO ENRIQUE;LAZARICH RAMIREZ MARIA. Apo.Sol.: GALINDO CORVILLOJOSE LUIS. Datos registrales. T 5594 , F 9, S 8, H SE 20724, I/A 313 (19.02.13).
28 de Diciembre de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: GALINDO CORVILLO JOSE LUIS. Apo.Manc.: GALINDO CORVILLO JOSE LUIS;DE BENITO SALIDOJOSE PEDRO;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER. Datos registrales. T 5594 , F 7, S 8, H SE 20724, I/A 312 (18.12.12).
11 de Diciembre de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA HERNANDEZ DIAZ CLAUDIO. Datos registrales. T 5594 , F 4, S 8, H SE 20724, I/A 309 (3.12.12).
Nombramientos. Apo.Sol.: CERON RAIGON FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: CERON RAIGON FRANCISCO JAVIER;DE BENITOSALIDO JOSE PEDRO;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER. Datos registrales. T 5594 , F 4, S 8, H SE 20724, I/A 310 ( 3.12.12).
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ DOMINGUEZ JOSE. Apo.Manc.: LOPEZ DOMINGUEZ JOSE;DE BENITO SALIDO JOSEPEDRO;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER. Datos registrales. T 5594 , F 6, S 8, H SE 20724, I/A 311 ( 3.12.12).
12 de Noviembre de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: MARSET RAMS JOSE;MARSET RAMS JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: MARSET RAMS JOSE. Datosregistrales. T 5594 , F 3, S 8, H SE 20724, I/A 308 (29.10.12).
30 de Octubre de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: JIMENEZ GUERRERO BORJA. Apo.Manc.: REDONDO GOMEZ LUCIANO;VALERIO PALACIOJOSE JAVIER. Datos registrales. T 5594 , F 2, S 8, H SE 20724, I/A 307 (18.10.12).
29 de Octubre de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: SUAREZ SUAREZ JOSE RAFAEL. Apo.Manc.: SUAREZ SUAREZ JOSE RAFAEL;MASERASGUTIERREZ MIGUEL ANGEL;GONZALEZ REINE RAFAEL. Datos registrales. T 5485 , F 225, S 8, H SE 20724, I/A 306 (16.10.12).
11 de Septiembre de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: RAI SATISH. Datos registrales. T 5485 , F 225, S 8, H SE 20724, I/A 305 (28.08.12).
21 de Agosto de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: PRAENA RODRIGUEZ JOSE ANGEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PRAENA RODRIGUEZ JOSEANGEL. Datos registrales. T 5485 , F 223, S 8, H SE 20724, I/A 304 ( 6.08.12).
02 de Agosto de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: KUMAR JAIN DEEPAK. Apo.Manc.: GYAN CHAND TATHER. Datos registrales. T 5485 , F 221, S8, H SE 20724, I/A 300 (18.07.12).
Nombramientos. Apoderado: NAGPAL D.S.K. Datos registrales. T 5485 , F 222, S 8, H SE 20724, I/A 301 (18.07.12).
Revocaciones. Apo.Sol.: SAENZ CARRETERO FRANCISCO. Datos registrales. T 5485 , F 223, S 8, H SE 20724, I/A 302(18.07.12).
Nombramientos. Apoderado: ALEGRE MARRADES MIGUEL. Datos registrales. T 5485 , F 223, S 8, H SE 20724, I/A 303(18.07.12).
26 de Julio de 2012Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5485 , F 221, S 8, H SE 20724, I/A 299 (13.07.12).
08 de Junio de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: MONTELLS GARCIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 5485 , F 220, S 8, H SE 20724, I/A 298(24.05.12).
11 de Mayo de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: KUMAR HASIJA SUNIL. Datos registrales. T 5485 , F 220, S 8, H SE 20724, I/A 297 (26.04.12).
23 de Abril de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL;GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL;JORRODE INZA VICENTE;CERRO REDONDO JOSE FERNANDO. Otros conceptos: LOS APODERADOS MANCOMUNADOS A QUEREFIERE ESTE NUMERO DE ENTRADA, ACTUARAN DOS CUALESQUIERA DE ELLOS, DE FORMA MANCOMUNADA. Datosregistrales. T 5485 , F 220, S 8, H SE 20724, I/A 296 ( 9.04.12).
13 de Abril de 2012Fe de erratas: Se ha rectificado la inscripción 285& al objeto de hacer constar que el segundo apellido del apoderado es"RODRIGUEZ" y, no "LOPEZ", como fue enviadoal Registro Mercantil Central en el envio 22 del año 2012.- Datos registrales. T 5485, F 219, S 8, H SE 20724, I/A 295 (28.03.12).
04 de Abril de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA BRAVO ALEJANDRO DANIEL. Datos registrales. T 5485 , F 219, S 8, H SE 20724, I/A 294(19.03.12).
30 de Marzo de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: MARSET RAMS JOSE. Datos registrales. T 5485 , F 219, S 8, H SE 20724, I/A 293 (16.03.12).
26 de Marzo de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: JIMENEZ GUERRERO BORJA. Datos registrales. T 5485 , F 218, S 8, H SE 20724, I/A 292(13.03.12).
23 de Marzo de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: CAO GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 5408 , F 211, S 8, H SE 20724, I/A 286 ( 9.03.12).
Nombramientos. Apo.Sol.: DEL CASTILLO ESTEBAN LUIS;CLARES DEL MORAL PEDRO JULIAN;GALINDO CORVILLO JOSELUIS. Datos registrales. T 5408 , F 211, S 8, H SE 20724, I/A 287 ( 9.03.12).
Revocaciones. Apoderado: MONTELLS GARCIA JOSE LUIS. Apo.Man.Soli: SANTOS ESCOLANO JUAN. Nombramientos.Apo.Man.Soli: GONZALEZ REINE RAFAEL;PRAENA RODRIGUEZ JOSE ANGEL. Apo.Manc.: ORTEGA SANTOS LUIS. Datosregistrales. T 5485 , F 214, S 8, H SE 20724, I/A 288 ( 9.03.12).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GOMEZ GARCIA GONZALO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CASTAÑEDA VAZQUEZ FEDERICO.Apo.Manc.: DE BENITO SALIDO JOSE PEDRO;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER. Datos registrales. T 5485 , F 215, S 8, H SE20724, I/A 289 ( 9.03.12).
Nombramientos. Apo.Sol.: SANTOS ESCOLANO JUAN. Datos registrales. T 5485 , F 217, S 8, H SE 20724, I/A 290 ( 9.03.12).
Revocaciones. Apoderado: HOMDEDEU PEREZ LLUIS. Apo.Man.Soli: ESTERUELAS AGUIRRE MARIA JOSE;NAVA RODRIGUEZMIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: DUQUE GONZALEZ PEDRO LUIS. Apo.Sol.: GONZALEZ ROLDAN MANUEL. Datos registrales. T5485 , F 218, S 8, H SE 20724, I/A 291 ( 9.03.12).
12 de Marzo de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: PRAENA LOPEZ JOSE ANGEL. Datos registrales. T 5408 , F 209, S 8, H SE 20724, I/A 285(27.02.12).
08 de Febrero de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: KUMAR HASIJA SUNIL. Datos registrales. T 5408 , F 206, S 8, H SE 20724, I/A 282 (24.01.12).
07 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;VALVERDE DELGADO MANUEL;DUQUE GARCIAEDUARDO;POLO GUERRERO ALVARO;HOOGSTRAATE MAARTEN. Secretario: HOOGSTRAATE MAARTEN. Presidente:GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Presidente: GONZALEZDOMINGUEZ ALFONSO. Consejero: HOOGSTRAATE MAARTEN. Secretario: HOOGSTRAATE MAARTEN. Consejero: VALVERDEDELGADO MANUEL;GOMEZ GARCIA GONZALO;POLO GUERRERO ALVARO. Datos registrales. T 5408 , F 206, S 8, H SE20724, I/A 283 (25.01.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ GARCIA GONZALO;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;ARTILLO GRAU JULIO.Apo.Sol.: VERGARA LOPEZ ALBERTO;VARGAS GALLARDO ENRIQUE. Apo.Man.Soli: LAZARICH RAMIREZ MARIA. Datosregistrales. T 5408 , F 206, S 8, H SE 20724, I/A 284 (26.01.12).
27 de Diciembre de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: CAMACHO DONEZAR JAVIER. Apo.Manc.: DE BENITO SALIDO JOSE PEDRO;VALERIO PALACIOJOSE JAVIER. Datos registrales. T 5408 , F 204, S 8, H SE 20724, I/A 281 (14.12.11).
20 de Diciembre de 2011Revocaciones. Apo.Man.Soli: CELIS BAUTISTA FERNANDO. Datos registrales. T 5408 , F 203, S 8, H SE 20724, I/A 278 (2.12.11).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GOMEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 5408 , F 203, S 8, H SE 20724, I/A 279 (5.12.11).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ROMERO MARTIN SALVADOR. Apo.Manc.: DE BENITO SALIDO JOSE PEDRO;VALERIOPALACIO JOSE JAVIER. Datos registrales. T 5408 , F 203, S 8, H SE 20724, I/A 280 ( 2.12.11).
10 de Noviembre de 2011Reelecciones. Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 5408 , F 202, S 8, H SE 20724, I/A277 (21.10.11).
31 de Octubre de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: TORRES VELAZQUEZ JAVIER. Datos registrales. T 5408 , F 201, S 8, H SE 20724, I/A 276 (19.10.11).
23 de Septiembre de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: DUQUE GARCIA EDUARDO;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;ARTILLO GRAUJULIO;VERGARA LOPEZ ALBERTO;VARGAS GALLARDO ENRIQUE;LAZARICH RAMIREZ MARIA. Datos registrales. T 5298 , F178, S 8, H SE 20724, I/A 272 (12.09.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: BALBOA LINARES SALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZALFONSO;LAZARICH RAMIREZ MARIA. Datos registrales. T 5298 , F 181, S 8, H SE 20724, I/A 273 (12.09.11).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: DUQUE GARCIA EDUARDO;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;ARTILLO GRAUJULIO;FERNANDEZ VILLAR ANGEL;VARGAS GALLARDO ENRIQUE;TEBA GUIRAO GUILLERMO. Datos registrales. T 5298 , F181, S 8, H SE 20724, I/A 274 (13.09.11).
Revocaciones. Apo.Sol.: BALBOA LINARES SALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZALFONSO;TEBA GUIRAO GUILLERMO. Datos registrales. T 5408 , F 201, S 8, H SE 20724, I/A 275 (13.09.11).
06 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: HOOGSTRAATE MAARTEN. Consejero: AYA ABAURRE ANA MARIA;GONZALEZ DOMINGUEZALFONSO;TERRY MERELLO RAFAEL;VALVERDE DELGADO MANUEL;BENJUMEA LLORENTE MARIA DEL CARMEN. Presidente:GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;VALVERDE DELGADOMANUEL;DUQUE GARCIA EDUARDO;POLO GUERRERO ALVARO;HOOGSTRAATE MAARTEN. Secretario: HOOGSTRAATEMAARTEN. Presidente: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Datos registrales. T 5298 , F 177, S 8, H SE 20724, I/A 271(23.08.11).
16 de Agosto de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: CARREÑO SUAREZ AGUSTIN. Datos registrales. T 5298 , F 176, S 8, H SE 20724, I/A 270 (30.07.11).
22 de Julio de 2011Nombramientos. Apoderado: GOMEZ MARTINEZ JORGE. Datos registrales. T 5298 , F 176, S 8, H SE 20724, I/A 269 (11.07.11).
29 de Junio de 2011Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ ENERGIA SOLAR 1 -CAMPUS PALMAS ALTAS (SEVILLA). Datos registrales. T 5298 , F 176, S 8, H SE 20724, I/A 268 (15.06.11).
28 de Junio de 2011Revocaciones. Apo.Manc.: VALLADOLID MORO JUAN MANUEL. Apo.Sol.: VALLADOLID MORO JUAN MANUEL.Nombramientos. Apo.Man.Soli: VALLADOLID MORO JUAN MANUEL. Datos registrales. T 5298 , F 171, S 8, H SE 20724, I/A 265(13.06.11).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: TEBA GUIRAO GUILLERMO. Datos registrales. T 5298 , F 173, S 8, H SE 20724, I/A 266(13.06.11).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MONTORO MANTILLA ISIDRO. Datos registrales. T 5298 , F 174, S 8, H SE 20724, I/A 267(13.06.11).
14 de Junio de 2011Nombramientos. Apoderado: VALERIO PALACIO JOSE JAVIER. RepresSuplen: AMIGUETI TOSSO JOSE ANTONIO.R.C.P.SolMan: CAMARGO FERNANDEZ FELIPE. Datos registrales. T 5298 , F 170, S 8, H SE 20724, I/A 264 ( 1.06.11).
09 de Junio de 2011Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ REINE RAFAEL. Apo.Sol.: MUÑOZ MARTIN MIGUEL ANGEL;PIZA GRANADOSALBERTO;KUMAR JHA RAJES. Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ REINE RAFAEL. Apo.Man.Soli: MASERAS GUTIERREZMIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 5298 , F 168, S 8, H SE 20724, I/A 262 (26.05.11).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ REINE RAFAEL;MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL;JIMENEZ CASTAÑOMANUEL. Apoderado: JIMENEZ CASTAÑO MANUEL. Apo.Sol.: JIMENEZ CASTAÑO MANUEL. Datos registrales. T 5298 , F 170, S8, H SE 20724, I/A 263 (31.05.11).
26 de Mayo de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL;GYAN CHAND TATHER. Datos registrales. T 5298 , F167, S 8, H SE 20724, I/A 261 (16.05.11).
24 de Mayo de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ REINE RAFAEL;GALVAN GOMEZ FRANCISCO;GOMEZ GARCIA GONZALO;MONTELLSGARCIA JOSE LUIS. Apo.Manc.: DE BENITO SALIDO PEDRO;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER. Apo.Sol.: ESTERUELASAGUIRRE MARIA JOSE. Apo.Manc.: DE BENITO SALIDO PEDRO;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER. Apo.Sol.: GONZALEZ CASASANTONIO. Apo.Manc.: VALERIO PALACIO JOSE JAVIER;DE BENITO SALIDO PEDRO;GONZALEZ CASAS ANTONIO. Datosregistrales. T 5298 , F 165, S 8, H SE 20724, I/A 257 (10.05.11).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: DUQUE GARCIA EDUARDO;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;DEAN GARCIA ADAMEZ JUANCARLOS;FERNANDEZ VILLAR ANGEL;VARGAS GALLARDO ENRIQUE;TEBA GUIRADO GUILLERMO. Datos registrales. T 5298 ,F 166, S 8, H SE 20724, I/A 260 (10.05.11).
Revocaciones. Apo.Sol.: BALBOA LINARES SALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Datos registrales. T 5298 , F 165, S 8,H SE 20724, I/A 258 (10.05.11).
Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ LAGUNA FRANCISCO JAVIER;ASTIGARRAGA AGUIRRE IGNACIO;MACIAS CAMACHOJOSE;CLARES DEL MORAL PEDRO;CELIS BAUTISTA FERNANDO;SALAMERO SANCHEZ EUGENIO JOSE;MUÑOZ DONATJOSE IGNACIO;DEL CASTILLO ESTEBAN LUIS;GALINDO CORVILLO JOSE LUIS. Apo.Manc.: DE BENITO SALIDOPEDRO;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER. Apo.Sol.: PIZA GRANADOS ALBERTO;MARTINEZ GOMEZ FRANCISCO;TORRESTORRES JUAN CARLOS. Apo.Manc.: DE BENITO SALIDO PEDRO;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER. Apoderado: MASERASGUTIERREZ MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: JOSE PEDRO SALIDO DE BENITO;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER. Datosregistrales. T 5298 , F 166, S 8, H SE 20724, I/A 259 (10.05.11).
17 de Mayo de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: DEAN GARCIA ADAMEZ JUAN CARLOS. Nombramientos. Apoderado: ARTILLO GRAU JULIO. Datosregistrales. T 5298 , F 165, S 8, H SE 20724, I/A 256 (28.04.11).
29 de Marzo de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: GALVAN GOMEZ FRANCISCO;GOMEZ GARCIA GONZALO;MONTELLS GARCIA JOSE LUIS.Apo.Manc.: DE BENITO SALIDO JOSE PEDRO;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER. Apo.Man.Soli: ESTERUELAS AGUIRRE MARIAJOSE;GONZALEZ REINE RAFAEL;GONZALEZ CASAS ANTONIO. Apo.Manc.: DE BENITO SALIDO JOSE PEDRO;VALERIOPALACIO JOSE JAVIER. Datos registrales. T 5298 , F 159, S 8, H SE 20724, I/A 254 (15.03.11).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ LAGUNA FRANCISCO JAVIER;ALEGRE MARRADES MIGUEL;ASTIGARRAGAAGUIRRE IÑIGO;MACIAS CAMACHO JOSE;CLARES DEL MORAL PEDRO JULIAN;CELIS BAUTISTA FERNANDO;SALAMEROSANCHEZ EUGENIO JOSE;MUÑOZ DONAT JOSE IGNACIO;DEL CASTILLO ESTEBAN LUIS;GALINDO CORVILLO JOSE LUIS.Apo.Manc.: DE BENITO SALIDO JOSE PEDRO;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GOMEZFRANCISCO;TORRES TORRES JUAN CARLOS;MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: DE BENITO SALIDO JOSEPEDRO;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER. Datos registrales. T 5298 , F 162, S 8, H SE 20724, I/A 255 (15.03.11).
02 de Marzo de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: DUQUE GARCIA EDUARDO;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;ARTILLO GRAUJULIO;FERNANDEZ VILLAR ANGEL;VARGAS GALLARDO ENRIQUE;TEBA GUIRAO GUILLERMO. Datos registrales. T 5298 , F157, S 8, H SE 20724, I/A 253 (16.02.11).
22 de Febrero de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: BALBOA LINARES SALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZALFONSO;TEBA GUIRAO GUILLERMO. Datos registrales. T 5298 , F 156, S 8, H SE 20724, I/A 251 ( 9.02.11).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ORTEGA SANTOS LUIS. Otros conceptos: Revocado el poder conferido a favor de DON JOSEJAVIER VALERIO PALACIO y LUCIANO REDONDO GOMEZ mediante la escritura otorgada con fecha 31 de Agosto de 2.009 ante elNotario de Sevilla, Don José Ruiz Granados, bajo el número 3.128 de su protocolo.- Datos registrales. T 5298 , F 156, S 8, H SE20724, I/A 252 (10.02.11).
15 de Febrero de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: HERNANDEZ CAMAÑO EVA. Datos registrales. T 5298 , F 155, S 8, H SE 20724, I/A 250 ( 3.02.11).
18 de Enero de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: SANTIAGO PEREZ JOSE RAUL;RAMIREZ BERRA GORKA;BURGOS GOMEZ MANUEL;TORRESTORRES JUAN CARLOS. Apo.Manc.: SANTIAGO PEREZ JOSE RAUL;RAMIREZ BERRA GORKA;BURGOS GOMEZMANUEL;TORRES TORRES JUAN CARLOS. Nombramientos. Apo.Sol.: GALVAN GOMEZ FRANCISCO. Apo.Man.Soli: GARCIALAFFITE MANUEL. Datos registrales. T 5298 , F 154, S 8, H SE 20724, I/A 249 (30.12.10).
05 de Enero de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: MONTERO DE ESPINOSA GOMEZ MARIA. Datos registrales. T 4980 , F 129, S 8, H SE 20724, I/A 245(23.12.10).
Revocaciones. Apoderado: RIOS VILLEGAS IGNACIO. Apo.Sol.: RIOS VILLEGAS IGNACIO. Datos registrales. T 4980 , F 130, S8, H SE 20724, I/A 246 (23.12.10).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANTOS ESCOLANO JUAN;MONTELLS GARCIA JOSE LUIS;REDONDO GOMEZ LUCIANO.Nombramientos. Apoderado: MONTELLS GARCIA JOSE LUIS. Apo.Man.Soli: SANTOS ESCOLANO JUAN. Datos registrales. T4980 , F 130, S 8, H SE 20724, I/A 247 (24.12.10).
Revocaciones. Apo.Sol.: LEAL DEL OJO CHAMORRO JOSE. Apo.Manc.: LEAL DEL OJO CHAMORRO JOSE;GONZALEZ REINERAFAEL;MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL.Apo.Sol.: LEAL DEL OJO CHAMORRO JOSE. Nombramientos. Apoderado:GONZALEZ REINE RAFAEL. Apo.Man.Soli: LEAL DEL OJO CHAMORRO JOSE. Datos registrales. T 5298 , F 152, S 8, H SE20724, I/A 248 (24.12.10).
23 de Diciembre de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ CASAS ANTONIO. Apo.Manc.: VALERIO PALACIO JOSE JAVIER;DE BENITO SALIDOPEDRO;GONZALEZ CASAS ANTONIO. Datos registrales. T 4980 , F 128, S 8, H SE 20724, I/A 244 ( 3.12.10).
13 de Diciembre de 2010Revocaciones. Apo.Man.Soli: HORACIO SARALEGUI ERNESTO;RIBEIRO ABREU DOS SANTOS ROGEIRO. Datos registrales. T4980 , F 127, S 8, H SE 20724, I/A 243 (26.11.10).
01 de Octubre de 2010Revocaciones. Apoderado: MARSET RAMS JOSE. Datos registrales. T 4980 , F 127, S 8, H SE 20724, I/A 241 (20.09.10).
Revocaciones. Apoderado: BENAVENT BLANQUET JOSE MARIA;AGUIRRE RODRIGUEZ MANUEL. Datos registrales. T 4980 , F127, S 8, H SE 20724, I/A 242 (20.09.10).
13 de Septiembre de 2010Reelecciones. Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4980 , F 126, S 8, H SE 20724, I/A240 (25.08.10).
04 de Agosto de 2010Nombramientos. Apoderado: ANZOLA ROBLES & ASOCIADOS. Datos registrales. T 4980 , F 124, S 8, H SE 20724, I/A 239(22.07.10).
25 de Junio de 2010Revocaciones. Apoderado: ROGERIO RIBEIRO ABREU. Apo.Sol.: ROGERIO RIBEIRO ABREU DOS SANTOS;FRIAS PECELLINANTONIO JOSE. Apoderado: URBIZTONDO PERDICES MIGUEL. Datos registrales. T 4980 , F 124, S 8, H SE 20724, I/A 238(16.06.10).
15 de Junio de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: BUENO CRESPO ANTONIO JOSE DAMASO;VARONA GOYENECHEA JEUS;OREJON GARCIAJOSE MANUEL;GARCIA-ALMUZARA MARTIN GONZALO;GALINDO CORVILLO JOSE LUIS;ESPILA JIMENEZ JUAN JOSE;GALVANGOMEZ FRANCISCO;DEAN GARCIA ADAMEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4980 , F 118, S 8, H SE 20724, I/A 235 (2.06.10).
Nombramientos. Apo.Sol.: VALLADOLID MORO JUAN MANUEL. Apo.Manc.: VALLADOLID MORO JUAN MANUEL;DE BENITOSALIDO JOSE PEDRO;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER. Datos registrales. T 4980 , F 121, S 8, H SE 20724, I/A 236 ( 2.06.10).
Nombramientos. Apoderado: ORTEGA SANTOS LUIS. Apo.Manc.: ORTEGA SANTOS LUIS;REDONDO GOMEZLUCIANO;VALERIO PALACIO JOSE JAVIER. Datos registrales. T 4980 , F 122, S 8, H SE 20724, I/A 237 ( 2.06.10).
22 de Abril de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: LEAL DEL OJO CHAMORRO JOSE. Apo.Manc.: LEAL DEL OJO CHAMORRO JOSE;GONZALEZ REINERAFAEL;MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL.Apo.Sol.: LEAL DEL OJO CHAMORRO JOSE. Otros conceptos: Las facultadesse confieren en la forma y con los límites que resultan de la escritura otorgada en Sevilla, el día ochode Marzo de dos mil diez, ante suNotario Don José Ruiz Granados, número 1.065 de protocolo.- Datos registrales. T 4980 , F 117, S 8, H SE 20724, I/A 234 ( 8.04.10).
13 de Abril de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: SUAREZ SUAREZ RAFAEL. Datos registrales. T 4980 , F 116, S 8, H SE 20724, I/A 232(18.03.10).
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: DE LAS CUEVAS TERAN FERNANDO. Nombramientos. SecreNoConsj: HOOGSTRAATEMAARTEN. Datos registrales. T 4980 , F 117, S 8, H SE 20724, I/A 233 (18.03.10).
22 de Febrero de 2010Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 4. Objeto.-. Ampliacion del objeto social. La Sociedad tendrá por objeto laorganización desarrollo y explotación de actividades y negocios destinados a la realización de estudios, inspecciones, informes,proyectos, dirección de obras, consultoría y servicios, promoción, diseño, suministro, construcción, montaje, distribución,mantenimiento,. Datos registrales. T 4980 , F 115, S 8, H SE 20724, I/A 231 ( 9.02.10).
11 de Enero de 2010Revocaciones. Apoderado: HORACIO SARALEGUI ERNESTO;MERINO CIUDAD ANTONIO;PAULINO JUNQUEIRA LUCIANO.Nombramientos. Apo.Sol.: NORBERTO ZARPELLON GABRIEL;MERINO CIUDAD ANTONIO;HORACIO SARALEGUIERNESTO;PAULINO JUNQUEIRA LUCIANO. Datos registrales. T 4980 , F 114, S 8, H SE 20724, I/A 230 (21.12.09).
31 de Diciembre de 2009Nombramientos. Apoderado: MERINO CIUDAD ANTONIO;PAULINO JUNQUEIRA LUCIANO. Datos registrales. T 4980 , F 84, S 8,H SE 20724, I/A 203 (22.12.08).
21 de Diciembre de 2009Revocaciones. Apoderado: MORA FIGUEROA MORA FIGUEROA NICOLAS. Datos registrales. T 4980 , F 114, S 8, H SE 20724,I/A 229 ( 9.12.09).
24 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: SANTOS ESCOLANO JUAN. Datos registrales. T 4980 , F 114, S 8, H SE 20724, I/A 228 (12.11.09).
03 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ LAVADO MANUEL. Apo.Manc.: RODRIGUEZ LAVADO MANUEL. Datos registrales. T4980 , F 112, S 8, H SE 20724, I/A 226 (22.10.09).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORTEGA SANTOS LUIS. Otros conceptos: Las facultades se confieren en la forma y con loslímites que resultan de la escritura otorgada en Sevilla, a treinta yuno de Agosto de dos mil nueve, ante su Notario Don José RuizGranados, número 3.128 de su protocolo.- Datos registrales. T 4980 , F 113, S 8, H SE 20724, I/A 227 (22.10.09).
09 de Septiembre de 2009Reelecciones. Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4980 , F 112, S 8, H SE 20724, I/A225 (28.08.09).
29 de Julio de 2009Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ZULUAGA ZILBERMANN ARMANDO. Nombramientos. SecreNoConsj: DE LAS CUEVASTERAN FERNANDO. Datos registrales. T 4980 , F 112, S 8, H SE 20724, I/A 224 (14.07.09).
20 de Mayo de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: JIMENEZ CASTAÑO MANUEL. Datos registrales. T 4980 , F 108, S 8, H SE 20724, I/A 220 ( 7.05.09).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL;GYAN CHAND TATHER. Datos registrales. T 4980 , F108, S 8, H SE 20724, I/A 221 ( 7.05.09).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL;GYAN CHAND TATHER. Datos registrales. T 4980 , F110, S 8, H SE 20724, I/A 222 ( 7.05.09).
04 de Mayo de 2009Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ CASTAÑO MANUEL. Datos registrales. T 4980 , F 108, S 8, H SE 20724, I/A 219(21.04.09).
15 de Abril de 2009Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ CASTAÑO MANUEL. Otros conceptos: Establecimiento de una Sucursal de InstalacionesInabensa, S.A. en Belgrado -Serbia- que será registrada como Instalaciones Inabensa, S.A., Belgrado Branch, con domicilio en AlekseNenadovica 15/15, 11000 Belgrade, para la ejecución del contrato, Construction of the Overhead Transmission Power Line. Datosregistrales. T 4980 , F 107, S 8, H SE 20724, I/A 218 (31.03.09).
07 de Abril de 2009Nombramientos. Apo.Man.Soli: AMORES MARTIN JESUS FERNANDO;JURADO CHACON JESUS;AMORES ZURITAENRIQUE;GALINDO CORVILLO JOSE LUIS;DEAN GARCIA ADAMEZ JUAN CARLOS;ESPILA JIMENEZ JUAN JOSE;GALVANGOMEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 4980 , F 104, S 8, H SE 20724, I/A 217 (26.03.09).
26 de Marzo de 2009Nombramientos. Apo.Man.Soli: MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: GYAN CHAND TATHER. Datos registrales.T 4980 , F 95, S 8, H SE 20724, I/A 211 ( 2.03.09).
Nombramientos. Apoderado: MARCHANTE ANGUITA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4980 , F 95, S 8, H SE 20724, I/A 212 (6.03.09).
Nombramientos. Apo.Manc.: FLORES PALACIOS JOSE TOMAS;SERRANO GONZALEZ JUAN. Otros conceptos: Las facultadesconferidas lo son por el límite que se indica en la escritura otorgada en Sevilla, el 16 de febrero de 2009, ante el Notario Don José RuizGranados, número 462 de protocolo.- Datos registrales. T 4980 , F 96, S 8, H SE 20724, I/A 213 ( 6.03.09).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: NAVA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: DUQUE GONZALEZ PEDRO LUIS. Otrosconceptos: Algunas de las facultades son con límites que se establecenen la escritura otorgada en Sevilla, el 16 de febrero de 2009,ante el Notario Don José Ruiz Granados, número 463 de protocolo.- Datos registrales. T 4980 , F 97, S 8, H SE 20724, I/A 214 (6.03.09).
Revocaciones. Apoderado: CUENCA BELDA JOSE JEREMIAS;DE AHUMADA PASTOR MANUEL;GUARDIOLA CENTENEROANDRES. Apo.Sol.: MORA FIGUEROA MORA FIGUEROA NICOLAS;ESPILA JIMENEZ JUAN JOSE. Apoderado: MARSET RAMSJOSE. Apo.Sol.: DE ANDRES RAMIREZ JESUS MARIA;NUÑEZ GARCIA ANTONIO. Nombramientos. Apo.Sol.: COLLADO YOLDIFELIPE JOSE;TORRES CASTILLO JAVIER;MARSET RAMS JOSE;FERNANDEZ LUCAS FRANCISCO ANTONIO;GONZALEZROLDAN MANUEL;DE AHUMADA PASTOR MANUEL;DE ANDRES RAMIREZ JESUS MARIA;ESPILA JIMENEZ JUAN JOSE.Apoderado: MORA FIGUEROA MORA FIGUEROA NICOLAS. Datos registrales. T 4980 , F 98, S 8, H SE 20724, I/A 215 ( 6.03.09).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PINILLOS MONTERO GREGORIO;AMORES MARTIN JESUS FERNANDO;ESCRIVA DE ROMANICARICOL ALBERTO;AMORES ZURITA ENRIQUE;DEAN GARCIA ADAMEZ JUAN CARLOS;NUÑEZ GARCIA ANTONIO;GALVANGOMEZ FRANCISCO;SANCHEZ FERNANDEZ JOAQUIN. Nombramientos. Apo.Man.Soli: TORRES SENES JUAN LUIS;AMORESMARTIN JESUS FERNANDO;ESCRIVA DE ROMANI CARICOL ALBERTO;AMORES ZURITA ENRIQUE;DEAN GARCIA ADAMEZJUAN CARLOS;GALINDO CORVILLO JOSE LUIS;GALVAN GOMEZ FRANCISCO;ESPILA JIMENEZ JUAN JOSE. Datosregistrales. T 4980 , F 100, S 8, H SE 20724, I/A 216 ( 6.03.09).
18 de Marzo de 2009Revocaciones. Apo.Man.Soli: CASTRO ROMERO RAMON ALBERTO;BATRES PEREZ FAVIO JOSUE. Apo.Sol.: ATILIO HEREDIANESTOR;CASTEJON RODRIGUEZ FRANCISCO DE PAULA. Nombramientos. Apo.Sol.: BATRES PEREZ FAVIO JOSUE;CASTROROMERO MANUEL ALBERTO. Apo.Man.Soli: ATILIO HEREDIA NESTOR;CASTEJON RODRIGUEZ FRANCISCO DE PAULA;DE LACRUZ OBREGON NESTOR. Apo.Manc.: GONZALEZ REINE RAFAEL;MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales.T 4980 , F 93, S 8, H SE 20724, I/A 209 (27.02.09).
Revocaciones. Apo.Sol.: ATILIO HEREDIA NESTOR;ALFONSO BIELSA JORGE;CASTEJON RODRIGUEZ FRANCISCO DEPAULAApo.Manc.: ALFONSO BIELSA JORGE;ATILIO HEREDIA NESTOR;CASTEJON RODRIGUEZ FRANCISCO DE PAULA;PIZAGRANADOS ALBERTO;MUÑOZ MARTIN MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MAYORAL ESPAÑA JOSEMANUEL;ATILIO HEREDIA NESTOR;CASTEJON RODRIGUEZ FRANCISCO DE PAULA. Apo.Manc.: GONZALEZ REINERAFAEL;MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 4980 , F 94, S 8, H SE 20724, I/A 210 ( 2.03.09).
03 de Marzo de 2009Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ REINE RAFAEL;MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL;JIMENEZ CASTAÑOMANUEL. Otros conceptos: Límite de 30.000E por unidad de acto o importe equivalente en la moneda local que corresponda para lafacultad C.5..- Hasta un importe de 3.000 E por unidad de acto o importe equivalente en la moneda local que corresponda, para lasfacultades F.3. y F.7..-En cuanto a las facultades enumeradas y relacionadas en el apartado F, podrán ser asimismo ejercitadas deforma mancomunada por dos cualesquiera de los tres apoderados nombrados, hasta un límite de 50.000 E por unidad de acto oimporte equivalente en la moneda local que corresponda.- Datos registrales. T 4980 , F 92, S 8, H SE 20724, I/A 208 (17.02.09).
18 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: MASERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: JOSE PEDRO SALIDO DE BENITO;VALERIOPALACIO JOSE JAVIER. Datos registrales. T 4980 , F 90, S 8, H SE 20724, I/A 207 ( 5.02.09).
09 de Febrero de 2009Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ GARCIA JOAQUIN. Apoderado: GONZALEZ SOLANO JOSE-JAVIER. Datos registrales. T4980 , F 90, S 8, H SE 20724, I/A 206 (27.01.09).
27 de Enero de 2009Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ZULUAGA ZILBERMANN ARMANDO. Nombramientos. Presidente: GONZALEZ DOMINGUEZALFONSO. SecreNoConsj: ZULUAGA ZILBERMANN ARMANDO. Datos registrales. T 4980 , F 90, S 8, H SE 20724, I/A 205(15.01.09).
07 de Enero de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: TERRY MERELLO RAFAEL;BENJUMEA LLORENTE MARIA DEL CARMEN;VALVERDE DELGADOMANUEL;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Presidente: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Nombramientos. Consejero:AYA ABAURRE ANA MARIA;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;TERRY MERELLO RAFAEL;VALVERDE DELGADOMANUEL;BENJUMEA LLORENTE MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 4980 , F 84, S 8, H SE 20724, I/A 201 (18.12.08).
Revocaciones. Apo.Sol.: CELIS BAUTISTA FERNANDO;MACIAS CAMACHO JOSE;CLARES DEL MORAL PEDRO;NUÑEZ
Nombramientos. Apoderado: HORACIO SARALEGUI ERNESTO. Datos registrales. T 4980 , F 84, S 8, H SE 20724, I/A 203(22.12.08).
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ REINE RAFAEL. Apo.Sol.: MONTELL GARCIA JOSE LUIS;GOMEZ GARCIAGONZALO;ESTERUELAS AGUIRRE MARIA JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ REINE RAFAEL;GALVAN GOMEZFRANCISCO;GOMEZ GARCIA GONZALO;MONTELLS GARCIA JOSE LUIS. Apo.Manc.: DE BENITO SALIDO PEDRO;VALERIOPALACIO JOSE JAVIER. Apo.Sol.: ESTERUELAS AGUIRRE MARIA JOSE. Apo.Manc.: DE BENITO SALIDO PEDRO;VALERIOPALACIO JOSE JAVIER. Datos registrales. T 4980 , F 88, S 8, H SE 20724, I/A 204 (22.12.08).