Actos BORME de Institut De Productivitat Industrial Sl
26 de Septiembre de 2012Nombramientos. APODERADO: AHICART GUILLEN MARIA NURIA. Datos registrales. T 21715 , F 89, S 8, H B 26004, I/A 13(17.09.12).
22 de Junio de 2012Revocaciones. ADMINISTR.: AHICART GUILLEN MARIA NURIA. Nombramientos. ADM.UNICO: AHICART GUILLEN LLUIS.Datos registrales. T 21715 , F 89, S 8, H B 26004, I/A 12 (13.06.12).
05 de Octubre de 2010Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: COSTA BLANCH RAMON. Datos registrales. T 21715 , F 88, S 8, H B 26004, I/A 10 (22.09.10).
Nombramientos. APODERADO: COSTA BLANCH RAMON. Datos registrales. T 21715 , F 88, S 8, H B 26004, I/A 11 (22.09.10).
16 de Julio de 2010Cambio de domicilio social. CL DE MOJA Num.12 P.1 PTA.2 (VILAFRANCA DEL PENEDES). Datos registrales. T 21715 , F 88, S8, H B 26004, I/A 9 ( 6.07.10).
13 de Agosto de 2009Revocaciones. ADMINISTR.: RAIC CONURI SL. REPR.143 RRM: AHICART GUILLEN MARIA NURIA. Nombramientos.ADM.SOLIDAR.: AHICART GUILLEN MARIA NURIA. Otros conceptos: DECLARACION DE LA PERDIDA DE LA CONDICION DEUNIPERSONAL. Datos registrales. T 21715 , F 87, S 8, H B 26004, I/A 8 ( 4.08.09).