Actos BORME de Instituto Multidisciplinar De Oncologia Sa
14 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apoderado: GOMEZ SANCHEZ PABLO. Nombramientos. Apoderado: SANTOS MESA ADRIAN. Datosregistrales. T 44548 , F 111, S 8, H M 113890, I/A 100 ( 5.12.23).
20 de Junio de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 44548 , F 110, S 8, H M 113890,I/A 98 (13.06.23).
12 de Mayo de 2023Revocaciones. Apoderado: COLLINS DAN JACOB. Datos registrales. T 44548 , F 110, S 8, H M 113890, I/A 97 ( 5.05.23).
24 de Febrero de 2023Nombramientos. Apoderado: NORDMANN RODRIGUEZ MARIA. Datos registrales. T 37496 , F 223, S 8, H M 113890, I/A 92(17.02.23).
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ SANCHEZ PABLO. Datos registrales. T 37496 , F 224, S 8, H M 113890, I/A 93 (17.02.23).
Nombramientos. Apoderado: CRACCO ALEXANDRA. Datos registrales. T 37496 , F 224, S 8, H M 113890, I/A 94 (17.02.23).
Nombramientos. Apoderado: CORDON PERALTA CRISTINA. Datos registrales. T 37496 , F 225, S 8, H M 113890, I/A 95(17.02.23).
Nombramientos. Apoderado: ENRICH RUIZ DE VELASCO JAIME. Datos registrales. T 37496 , F 225, S 8, H M 113890, I/A 96(17.02.23).
16 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: MONTA脩ES LOZANO JAVIER;ACOSTA ALVAREZ TOMAS JOSE;SEBASTIAN QUETGLAS RAFAEL.Apoderado: CRACCO ALEXANDRA;LOPEZ MIGUELEZ MARTA. Datos registrales. T 37496 , F 223, S 8, H M 113890, I/A 91 (9.12.22).
12 de Julio de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 37496 , F 223, S 8, H M 113890,I/A 90 ( 5.07.22).
13 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: MORAIS D'ALMEIDA SACCHETTI DE PASSOS JONAS. Datos registrales. T 37496 , F 223, S 8, H M113890, I/A 89 ( 2.12.21).
09 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apoderado: LOPEZ MIGUELEZ MARTA. Datos registrales. T 37496 , F 222, S 8, H M 113890, I/A 88 (30.11.21).
07 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Representan: ROLFO ALDO. Nombramientos. Representan: CAPELL BRENDAN. Datos registrales. T 37496, F 222, S 8, H M 113890, I/A 87 (29.11.21).
14 de Julio de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 37496 , F 222, S 8, H M 113890,I/A 86 ( 7.07.21).
26 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CRACCO ALEXANDRA. Datos registrales. T 37496 , F 221, S 8, H M 113890, I/A 85 (19.05.21).
27 de Agosto de 2020Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: INSTITUTO ONCOLOGICO CARTUJA SA. Datos registrales. T 37496 , F 218, S 8,H M 113890, I/A 84 (20.08.20).
19 de Agosto de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: SANZ MARTIN GEMMA. Datos registrales. T 37496 , F 218, S 8, H M 113890, I/A 83 (12.08.20).
24 de Julio de 2020Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 242.808,04 Euros. Desembolsado: 242.808,04 Euros. Resultante Suscrito: 14.329.881,43 Euros.Resultante Desembolsado: 14.329.881,43 Euros. Datos registrales. T 37496 , F 217, S 8, H M 113890, I/A 82 (17.07.20).
20 de Julio de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 37496 , F 217, S 8, H M 113890,I/A 81 (13.07.20).
14 de Julio de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ BRETONES MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 37496 , F 217, S 8, H M 113890, I/A 80 (7.07.20).
01 de Julio de 2020Nombramientos. Apoderado: CAPELL BRENDAN. Datos registrales. T 37496 , F 215, S 8, H M 113890, I/A 79 (24.06.20).
10 de Junio de 2020Ceses/Dimisiones. Representan: BRICE脩O LAGOS CONRADO. Nombramientos. Representan: ROLFO ALDO. Datosregistrales. T 37496 , F 215, S 8, H M 113890, I/A 78 ( 3.06.20).
25 de Mayo de 2020Nombramientos. Apoderado: REINA BRIASCO ALFONSO MIGUEL. Datos registrales. T 37496 , F 214, S 8, H M 113890, I/A 77(18.05.20).
11 de Febrero de 2020Otros conceptos: INSERTADO CON FECHA 29 DE ENERO DE 2020 EN LA PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD'www.genesiscare.com/es" , EL PROYECTO COMUN DE FUSION POR ABSORCION DE LAS SOCIEDADES "INSTITUTOMULTIDISCIPLINAR DE ONCOLOGIA, SA ", COMO SOCIEDAD ABSORBENTE, Y "INSTITUTO ONCOLOGICO CARTUJA, SA"COMO ABSORBIDA. Datos registrales. T 7003 , F 76, S 8, H M 113890, I/A 4-M ( 4.02.20).
30 de Enero de 2020Revocaciones. Apoderado: ALONSO ALONSO JOSE LUIS. Datos registrales. T 37496 , F 214, S 8, H M 113890, I/A 76 (23.01.20).
22 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: MURIEL SANZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 37496 , F 212, S 8, H M 113890, I/A 74 (15.11.19).
Nombramientos. Apoderado: PEREZ BRETONES MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 37496 , F 212, S 8, H M 113890, I/A 75(15.11.19).
18 de Noviembre de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: MORAIS D'ALMEIDA SACCHETTI DE PASSOS JONAS. Nombramientos. Representan:BRICE脩O LAGOS CONRADO. Datos registrales. T 37496 , F 212, S 8, H M 113890, I/A 73 (11.11.19).
21 de Agosto de 2019Revocaciones. Apoderado: REINA BRIASCO ALFONSO MIGUEL. Apo.Sol.: ALLEN MICHAEL JOHN. Apoderado: PICKETT AARONMACKENZIE;BERRA DE UNAMUNO RAMON. Datos registrales. T 37496 , F 212, S 8, H M 113890, I/A 72 (13.08.19).
09 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: BERRA DE UNAMUNO RAMON. Nombramientos. Representan: MORAIS D'ALMEIDASACCHETTI DE PASSOS JONAS. Datos registrales. T 37496 , F 210, S 8, H M 113890, I/A 70 ( 5.08.19).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.063.787,70 Euros. Desembolsado: 1.063.787,70 Euros. Resultante Suscrito: 14.087.073,39 Euros.Resultante Desembolsado: 14.087.073,39 Euros. Datos registrales. T 37496 , F 211, S 8, H M 113890, I/A 71 ( 5.08.19).
14 de Junio de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MORAIS D'ALMEIDA SACCHETTI DE PASSOS JONAS;MURIEL SANZ JOSE MANUEL;SANZ MARTINGEMMA. Datos registrales. T 37496 , F 208, S 8, H M 113890, I/A 69 ( 7.06.19).
21 de Enero de 2019P谩gina web de la sociedad. Modificaci贸n de la p谩gina web corporativa.Nueva p谩gina web: www.genesiscare.com/es/. Datosregistrales. T 37496 , F 208, S 8, H M 113890, I/A 68 (11.01.19).
02 de Agosto de 2018Nombramientos. Apoderado: COLLINS DAN JACOB;PICKETT AARON MACKENZIE;BERRA DE UNAMUNO RAMON. Datosregistrales. T 37496 , F 205, S 8, H M 113890, I/A 67 (26.07.18).
22 de Junio de 2018Cambio de domicilio social. C/ EMILIO VARGAS 16 (MADRID). Datos registrales. T 37496 , F 204, S 8, H M 113890, I/A 65(15.06.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: JIMENEZ-HERRERA BURGALETA PABLO. Nombramientos. Apoderado: ALONSO ALONSO JOSELUIS. Datos registrales. T 37496 , F 205, S 8, H M 113890, I/A 66 (15.06.18).
04 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Representan: JIMENEZ-HERRERA BURGALETA PABLO. Nombramientos. Representan: BERRA DEUNAMUNO RAMON. Datos registrales. T 37496 , F 204, S 8, H M 113890, I/A 64 (24.04.18).
03 de Mayo de 2018Otros conceptos: REFUNDICION DE ESTATUTOS SOCIALES.- Datos registrales. T 25601 , F 212, S 8, H M 113890, I/A 63(24.04.18).
25 de Abril de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: MONTA脩ES LOZANO JAVIER;ACOSTA ALVAREZ TOMAS JOSE;SEBASTIAN QUETGLAS RAFAEL.Datos registrales. T 25601 , F 211, S 8, H M 113890, I/A 62 (17.04.18).
20 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: COLIINS DAN;PICKETT AARON;JIMENEZ-HERRERA BURGALETA PABLO. Presidente: COLIINSDAN. Secretario: JIMENEZ-HERRERA BURGALETA PABLO. Nombramientos. Adm. Unico: GENESIS CARE ESPA脩A HOLDINGSSL. Representan: JIMENEZ-HERRERA BURGALETA PABLO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 25601 , F 211, S 8, H M 113890, I/A 61 (13.04.18).
12 de Julio de 2017Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25601 , F 211, S 8, H M 113890,I/A 60 ( 4.07.17).
09 de Junio de 2017Nombramientos. Auditor: AMO MIRON SAN SEGUNDO Y ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 25601 , F 210, S 8, H M 113890,I/A 59 ( 1.06.17).
21 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: SANTIAGO PEREZ ANTONIO. Datos registrales. T 25601 , F 208, S 8, H M 113890, I/A 56(13.02.17).
Revocaciones. Apoderado: MATEOS PEREZ MARIA DOLORES;CASTELLANO ORTEGA VICENTE;JIMENEZ-HERRERABURGALETA PABLO;ISACH GABALDON MARIA ANTONIA;JIMENEZ HERRERA BURGALETA PABLO;SAMBLAS GARCIAJOSE;SAMBLAS GARCIA JOSE;ISACH GABALDON MARIA ANTONIA;JIMENEZ-HERRERA BURGALETA PABLO. Datosregistrales. T 25601 , F 208, S 8, H M 113890, I/A 57 (13.02.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: ALLEN MICHAEL JOHN;JIMENEZ-HERRERA BURGALETA PABLO. Datos registrales. T 25601 , F208, S 8, H M 113890, I/A 58 (13.02.17).
22 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: SAMBLAS GARCIA JOSE. Presidente: SAMBLAS GARCIA JOSE. Consejero: JIMENEZ-HERRERABURGALETA PABLO;HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARIA INSTITUT;NAZCA DIRECTORSHIPS I SL;NAZCADIRECTORSHIPS III SL. SecreNoConsj: FRASQUET GARCIA ALBERTO. VsecrNoConsj: FERNANDEZ RICO NU脩EZ MARCOS.Representan: LOPEZ MARTINEZ JOSE MANUEL;MARIATEGUI VALDES ALVARO;PORTELA PALLARES IGNACIO.Nombramientos. Consejero: COLIINS DAN;PICKETT AARON;JIMENEZ-HERRERA BURGALETA PABLO;SANTIAGO PEREZANTONIOPresidente: COLIINS DAN. Secretario: JIMENEZ-HERRERA BURGALETA PABLO. Datos registrales. T 25601 , F 207, S8, H M 113890, I/A 54 (10.11.16).
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6. Modificado el art铆culo 22潞 de los estatutos sociales. Datosregistrales. T 25601 , F 207, S 8, H M 113890, I/A 55 (10.11.16).
02 de Agosto de 2016Otros conceptos: Insercion en la web www.grupoimo.com del proyecto de fusi贸n de las sociedades "Instituto Multidisciplinar deOncologia SA" como Absorbente e "Instituto Oncol贸gico Cartuja SA" como absorbida. Datos registrales. T 25601 , F 206, S 8, H M113890, I/A 53 M ( 5.07.16).