Buscador CIF Logo

Actos BORME Instituto Municipal De Vivienda De Fuenlabrada Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Instituto Municipal De Vivienda De Fuenlabrada Sa

Actos BORME Instituto Municipal De Vivienda De Fuenlabrada Sa - A84608462

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Instituto Municipal De Vivienda De Fuenlabrada Sa con CIF A84608462

🔙 Perfil de Instituto Municipal De Vivienda De Fuenlabrada Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Instituto Municipal De Vivienda De Fuenlabrada Sa

31 de Mayo de 2023
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: SEGOVIA IZQUIERDO SALVADOR. Nombramientos. VsecrNoConsj: ANTUNEZ ANTUNEZMARIA-ALMUDENA. Datos registrales. T 22290 , F 192, S 8, H M 397955, I/A 29 (24.05.23).

Nombramientos. Auditor: SEIQUER AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 22290 , F 192, S 8, H M 397955, I/A30 (24.05.23).

30 de Mayo de 2023
Reelecciones. Secretario: PARRA CASTEJON ROCIO. VsecrNoConsj: SEGOVIA IZQUIERDO SALVADOR. Datos registrales. T22290 , F 191, S 8, H M 397955, I/A 28 (23.05.23).

16 de Agosto de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ PALACIN JOSE-MARIA. Nombramientos. Consejero: CUBAS BARRAGAN CARMEN.Datos registrales. T 22290 , F 191, S 8, H M 397955, I/A 27 ( 9.08.21).

20 de Abril de 2021
Otros conceptos: SE SUBSANA LA INSCRIPCION 22, EN CUANTO A DNI DE DON JOSE MIGUEL AGUILAR FERNANDEZ,SIENDO EL CORRECTO "49016220T".- Datos registrales. T 22290 , F 191, S 8, H M 397955, I/A 26 (13.04.21).

20 de Julio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ VAQUERO SERGIO;MONTILLA MERINO JUAN;VALERO ROMERO OSCAR;ORTEGALOPEZ ISIDORO. Vicepresid.: ORTEGA LOPEZ ISIDORO. Nombramientos. Consejero: LOPEZ RODRIGUEZ RAQUEL;GONZALEZMOLDES ANTONIO;DE LAS ALAS PUMARIÑO ANDRES;NUÑEZ GONZALEZ NOELIA. Reelecciones. Consejero: AYALA ORTEGAFRANCISCO-JAVIER;PEREZ SANTIAGO ANA MARIA;FLORES JIMENEZ ROBERTO;MOLINA CASASOLA BEGOÑA;MARTINEZPALACIN JOSE-MARIA. Datos registrales. T 22290 , F 189, S 8, H M 397955, I/A 23 (13.07.20).

Nombramientos. Apoderado: AGUILAR FERNANDEZ JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 22290 , F 190, S 8, H M 397955, I/A 24(13.07.20).

Ceses/Dimisiones. Presidente: AYALA ORTEGA FRANCISCO-JAVIER. Nombramientos. Presidente: AYALA ORTEGAFRANCISCO-JAVIER. Vicepresid.: PEREZ SANTIAGO ANA MARIA. Apo.Sol.: AYALA ORTEGA FRANCISCO-JAVIER. Apo.Manc.:PEREZ SANTIAGO ANA MARIA. Datos registrales. T 22290 , F 190, S 8, H M 397955, I/A 25 (13.07.20).

11 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. D. Gerente: CARRION SANCHEZ JOSE IGNACIO. Revocaciones. Apoderado: CARRION SANCHEZ JOSEIGNACIO. Nombramientos. D. Gerente: AGUILAR FERNANDEZ JOSE MIGUEL. Apo.Man.Soli: AGUILAR FERNANDEZ JOSEMIGUEL. Datos registrales. T 22290 , F 188, S 8, H M 397955, I/A 22 ( 4.02.20).

21 de Octubre de 2019
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION de los artículos 1, 2, 16, 18, 19, 20 y 22 de los estatutos sociales.. Ampliacion delobjeto social. Constituye su objeto social, tanto la competencia municipal en materia de vivienda, conforme a las directrices generalesdadas por el Ayuntamiento, como la realización de las operaciones necesarias para el completo desarrollo de cualquier actuaciónurbanística en el Término Municipal de Fuenlabrada. Datos registrales. T 22290 , F 187, S 8, H M 397955, I/A 21 (14.10.19).

10 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: AYALA ORTEGA FRANCISCO-JAVIER. Consejero: ROBLES DELGADO MANUEL. Presidente:ROBLES DELGADO MANUEL. Nombramientos. Presidente: AYALA ORTEGA FRANCISCO-JAVIER. Apoderado: AYALA ORTEGAFRANCISCO-JAVIER;ORTEGA LOPEZ ISIDORO;CARRION SANCHEZ JOSE IGNACIO.Consejero: ORTEGA LOPEZ ISIDORO.Vicepresid.: ORTEGA LOPEZ ISIDORO. Datos registrales. T 22290 , F 186, S 8, H M 397955, I/A 20 ( 3.10.19).

21 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ MARIA TERESA;GONZALEZ SAN JOSE CARLOS. Nombramientos.Consejero: MARTINEZ PALACIN JOSE-MARIA;VALERO ROMERO OSCAR. Datos registrales. T 22290 , F 186, S 8, H M 397955,I/A 19 (13.07.17).

07 de Septiembre de 2016
Reelecciones. Secretario: PARRA CASTEJON ROCIO. Datos registrales. T 22290 , F 185, S 8, H M 397955, I/A 18 (31.08.16).

19 de Mayo de 2016
Reelecciones. VsecrNoConsj: SEGOVIA IZQUIERDO SALVADOR. Datos registrales. T 22290 , F 185, S 8, H M 397955, I/A 16 (6.05.16).

Nombramientos. Apoderado: CARRION SANCHEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 22290 , F 185, S 8, H M 397955, I/A 17 (6.05.16).

30 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROBLES DELGADO MANUEL;AYALA ORTEGA FRANCISCO-JAVIER;ORTEGA LOPEZISIDORO;VALERO ROMERO OSCAR;GONZALEZ SAN JOSE CARLOS;PEREZ BOIX ALBERTO;OBREGON LAMBEAISABEL;GARCIA MARTIN TEOFILO. Presidente: ROBLES DELGADO MANUEL. Vicepresid.: AYALA ORTEGA FRANCISCO-JAVIER.Nombramientos. Consejero: ROBLES DELGADO MANUEL. Presidente: ROBLES DELGADO MANUEL. Consejero: AYALAORTEGA FRANCISCO-JAVIER;PEREZ SANTIAGO ANA MARIA;LOPEZ VAQUERO SERGIO;FLORES JIMENEZROBERTO;FERNANDEZ GONZALEZ MARIA TERESA;GONZALEZ SAN JOSE CARLOS;MOLINA CASASOLA BEGOÑA;MONTILLAMERINO JUAN. Vicepresid.: AYALA ORTEGA FRANCISCO-JAVIER. Datos registrales. T 22290 , F 184, S 8, H M 397955, I/A 15(18.12.15).

30 de Enero de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROBLES DELGADO MANUEL;CRESPO SANTOS JULIO;AYALA ORTEGA FRANCISCO-JAVIER;BORRAS HERNANDEZ JOSE;MOZO ALEGRE SUSANA;FERNANDEZ GONZALEZ MARIA TERESA;GARCIA MARTINTEOFILO;GRANADOS AGUILAR VALENTIN. Presidente: ROBLES DELGADO MANUEL. Consejero: MORAN GARCIA JOSE.Vicepresid.: AYALA ORTEGA FRANCISCO-JAVIER. Nombramientos. Consejero: ROBLES DELGADO MANUEL;AYALA ORTEGAFRANCISCO-JAVIER;ORTEGA LOPEZ ISIDORO;VALERO ROMERO OSCAR;GONZALEZ SAN JOSE CARLOS;PEREZ BOIXALBERTO;OBREGON LAMBEA ISABEL;CORDERO NUÑEZ RAUL;GARCIA MARTIN TEOFILO. Presidente: ROBLES DELGADOMANUEL. Vicepresid.: AYALA ORTEGA FRANCISCO-JAVIER. Datos registrales. T 22290 , F 184, S 8, H M 397955, I/A 14(18.01.12).

12 de Agosto de 2011
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: CRESPO SANTOS JULIO. Revocaciones. Apo.Sol.: BURGOS GARCIA FERNANDO.Apo.Man.Soli: BURGOS GARCIA FERNANDO. Nombramientos. Vicepresid.: AYALA ORTEGA FRANCISCO-JAVIER. Apoderado:ROBLES DELGADO MANUEL;AYALA ORTEGA FRANCISCO-JAVIER;CARRION SANCHEZ JOSE IGNACIOD. Gerente: CARRIONSANCHEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 22290 , F 183, S 8, H M 397955, I/A 13 (27.07.11).

18 de Febrero de 2011
Revocaciones. Apo.Sol.: ROBLES DELGADO MANUEL. Apo.Manc.: CRESPO SANTOS JULIO. Apo.Man.Soli: GARCIA SANCHEZJOSE LUIS. Nombramientos. Apo.Sol.: BURGOS GARCIA FERNANDO. Apo.Manc.: CRESPO SANTOS JULIO. Apo.Man.Soli:BURGOS GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 22290 , F 182, S 8, H M 397955, I/A 12 ( 7.02.11).

15 de Febrero de 2011
Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 1 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-. Datos registrales. T 22290 , F182, S 8, H M 397955, I/A 11 ( 2.02.11).

26 de Enero de 2010
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: SANZ JIMENEZ CESAR. Nombramientos. SecreNoConsj: PARRA CASTEJON ROCIO.Reelecciones. VsecrNoConsj: SEGOVIA IZQUIERDO SALVADOR. Datos registrales. T 22290 , F 181, S 8, H M 397955, I/A 9(14.01.10).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA JIMENEZ MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: MORAN GARCIA JOSE. Datosregistrales. T 22290 , F 182, S 8, H M 397955, I/A 10 (14.01.10).

06 de Noviembre de 2009
Nombramientos. Auditor: LAVINIA AUDITORIA Y CONSULTORIA DE GESTION SL. Datos registrales. T 22290 , F 181, S 8, H M397955, I/A 8 (26.10.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información